GICL 2013 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | GICL 2013 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00995253 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GICL 2013 LIMITED ?
Adresse du siège social | 6th Floor One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GICL 2013 LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour GICL 2013 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Helen Alison Pickford en tant que directeur le 30 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stuart Logue en tant qu'administrateur le 16 nov. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2014 | 26 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Claire Catherine Marsh en tant que secrétaire le 13 janv. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Stewart Hunter en tant que secrétaire le 31 déc. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Divers Section 519 ca 2006 | 2 pages | MISC | ||||||||||
Divers Section 519 | 2 pages | MISC | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2013 | 47 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 21 mai 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Roy Sampson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Watson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Helen Alison Pickford en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Smale en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Urmston en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GICL 2013 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARSH, Claire Catherine | Secrétaire | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th Floor | 194060000001 | |||||||
BOISSEAU, Francois-Xavier Bernard | Administrateur | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th Floor | United Kingdom | British | Underwriting And Claims Direct | 81117550003 | ||||
LOGUE, Stuart Bruce | Administrateur | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th Floor | United Kingdom | British | Company Director | 202734850001 | ||||
HUNTER, Andrew Stewart | Secrétaire | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th Floor | 164379380001 | |||||||
MANNING, James Pius | Secrétaire | Downsleigh 20 Lucastes Road RH16 1JL Haywards Heath West Sussex | British | Company Secretary | 34157750001 | |||||
RAGAN, David Cameron | Secrétaire | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th Floor | 147410400001 | |||||||
TULLOCH, Elizabeth Anne | Secrétaire | 139 Downs Road CT19 5PT Folkestone Kent | British | 58391800003 | ||||||
WHITFIELD JONES, Rosemary | Secrétaire | Groupama House 24-26 Minories EC3N 1DE London | British | 7733220001 | ||||||
WILSON, David Morrison | Secrétaire | Woodridge Hillberry Green IM2 6DE Douglas Isle Of Man | British | Insurance Executive | 76889720001 | |||||
SISEC LIMITED | Secrétaire désigné | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||
ABLETT, Timothy Andrew | Administrateur | Benover House Rectory Lane CT21 4QA Saltwood Kent | England | British | Chartered Accountant | 65924000002 | ||||
ALLARD, Jean Francois | Administrateur | 1 Place Du Pantheon 75005 Paris France | French | General Manager | 44689740001 | |||||
ARNOLD, Lawrence Kenneth | Administrateur | 42 Raglan Road RH2 0DP Reigate Surrey | British | Director | 450150001 | |||||
BAUCHEREL, Jean Luc | Administrateur | La Butte Du Moulin Thehillac 56730 France | French | Director | 75648420001 | |||||
BEAUCHESNE, Michel Andre Bertrand Marie | Administrateur | 3 Rue De Beaune FOREIGN Paris 75007 France | French | Director | 74926970001 | |||||
BERNARDIE, Guy Jean Emile | Administrateur | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th Floor | France | French | Farmer | 163958810001 | ||||
BISHOP, Terence Harvey | Administrateur | Timbers Hempstead Road TN22 1DZ Uckfield East Sussex | British | Director | 7827330001 | |||||
BOUCHARD, Gilles Olliver | Administrateur | 138 Rue Du Bosquet FOREIGN Saint Clement De Riviere France 34980 | French | Managing Director | 88197710001 | |||||
BOUCHE, Regis Paul Marie | Administrateur | 4 Rue Jules Ferry 84850 Camaret FOREIGN France | French | Non-Exec Chairman Of The Ccama | 41797610001 | |||||
BOUQUIN, Jean Paul | Administrateur | 7 Rue Lauriston Paris 75116 France | French | Director | 80664160002 | |||||
CALLANDER, David Lachlan | Administrateur | Floor One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 173696590001 | ||||
CLARKE, Adam James | Administrateur | Floor One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th United Kingdom | England | British | Company Director | 132707490002 | ||||
CLENCH, John Anthony | Administrateur | 84 Seabrook Road CT21 5QA Hythe Kent | British | Insurance Executive | 34157740001 | |||||
CLYTI, Andre | Administrateur | 5 Rue Pierre De Coubertin Nogent Sur Seine 10400 France | French | Retired Farmer | 61728780001 | |||||
CORNUT CHAUVINC, Amaury Pierre Marie | Administrateur | Domaine Des Champs Saint Peray 07130 France | French | Agricultural Farmer | 104547670001 | |||||
DARBOUX, Jack Noel Andre | Administrateur | Le Brucher Chemin De Moutpezat Beaucaire 30300 France | French | Director | 95442270001 | |||||
DECOOL, Jean Pierre | Administrateur | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th Floor | France | French | Farmer | 97606370001 | ||||
DELAS, Bernard | Administrateur | 1 Rue Danton 75006 Paris France | French | Managing Director | 44686760001 | |||||
DINGLI, Paul Adrian Francis | Administrateur | Pheasants Wood Felcourt RH19 2LA East Grinstead Sussex | British | Non Executive Director | 35756100001 | |||||
DOBBS, William Victor | Administrateur | 28b Broadwater Down TN2 5NR Tunbridge Wells Kent | British | Insurance Co Executive | 6762970002 | |||||
DOLLE, Claude Rene | Administrateur | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th Floor | France | French | Director General | 96174460001 | ||||
DREW, David William | Administrateur | Mahe Glenmore Road East TN6 1RE Crowborough East Sussex | England | British | General Manager Sales & Region | 43382720001 | ||||
DU BOULLAY, Emmanuel | Administrateur | 12 Cite Vaneau 75007 Paris France | French | Insurer | 68391030001 | |||||
FABRE, Jean Marc | Administrateur | One America Square 17 Crosswall EC3N 2LB London 6th Floor | France | French | Agricultural Farmer | 74781530001 | ||||
GIORDANI, Giorgio | Administrateur | 26-28 Rue Marius Aufan 92300-Levallois Perret FOREIGN France | French | General Manager | 42834130001 |
GICL 2013 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Account charge | Créé le 02 août 2011 Livré le 16 août 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all monies from time to time standing to the credit of the account see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Account charge | Créé le 02 août 2011 Livré le 16 août 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first floating charge all monies from time to time standing to the credit of each account see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Memorandum of deposit and charge | Créé le 01 nov. 1993 Livré le 18 nov. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a supplemental deed of even date | |
Brèves mentions The bearer and registered UK government debt securities set out in sched ule 2 to the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0