HW PLASTICS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHW PLASTICS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00995976
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HW PLASTICS LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. (25990) / Industries manufacturières

    Où se situe HW PLASTICS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HW PLASTICS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HEYWOOD WILLIAMS PLASTICS LIMITED02 janv. 199602 janv. 1996
    PLANET GROUP LIMITED24 mai 198224 mai 1982
    PERCY LANE GROUP P L C03 déc. 197003 déc. 1970

    Quels sont les derniers comptes de HW PLASTICS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HW PLASTICS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HW PLASTICS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    11 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 avr. 2015

    11 pages4.68

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Changement d'adresse du siège social de * 4 Manor Park Business Centre Mackenzie Way Cheltenham Gloucestershire GL51 9TX* le 09 mai 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 avr. 2014

    État du capital au 23 avr. 2014

    • Capital: GBP 524,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Cessation de la nomination de David Challinor en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Brian Kennedy en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Epwin Secretaries Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Changement d'adresse du siège social de * Manor Park Business Centre Mackenzie Way Cheltenham Gloucestershire GL51 9TX United Kingdom* le 03 avr. 2012

    1 pagesAD01

    Période comptable précédente prolongée du 31 oct. 2011 au 31 déc. 2011

    1 pagesAA01

    legacy

    3 pagesMG02

    Changement d'adresse du siège social de * Bow Chambers 8 Tib Lane Manchester M2 4JB United Kingdom* le 26 janv. 2012

    1 pagesAD01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 20 janv. 2012

    • Capital: GBP 524,000
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 13/01/2012
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Qui sont les dirigeants de HW PLASTICS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EPWIN SECRETARIES LIMITED
    Manor Park Business Centre
    Mackenzie Way
    GL51 9TX Cheltenham
    4
    Gloucestershire
    England
    Secrétaire
    Manor Park Business Centre
    Mackenzie Way
    GL51 9TX Cheltenham
    4
    Gloucestershire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07983466
    168031440001
    KIRK, Adrian Christopher
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Administrateur
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritishFinance Director93313700001
    BARRON, Ian
    28 Arkenley Lane
    Almondbury
    HD4 6SQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    28 Arkenley Lane
    Almondbury
    HD4 6SQ Huddersfield
    West Yorkshire
    British36470950002
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    47 Woodhill Road
    LS16 7BZ Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    47 Woodhill Road
    LS16 7BZ Leeds
    West Yorkshire
    British52670320001
    KENNEDY, Sam
    2 Brampton Road
    SK7 3BS Bramhall
    Cheshire
    Secrétaire
    2 Brampton Road
    SK7 3BS Bramhall
    Cheshire
    BritishDirector118920880001
    MARTIN, Christopher Jonathan
    4 Highfield Road
    SK10 5LR Bollington
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Highfield Road
    SK10 5LR Bollington
    Cheshire
    BritishSecretary125360730001
    MARTIN, Terence John
    525 Holcombe Road
    Greenmount
    BL8 4EL Bury
    Lancashire
    Secrétaire
    525 Holcombe Road
    Greenmount
    BL8 4EL Bury
    Lancashire
    British802200001
    WALLIS, Daren Johnathan
    Castleford Drive
    Prestbury
    SK10 4BG Macclesfield
    11
    Cheshire
    Secrétaire
    Castleford Drive
    Prestbury
    SK10 4BG Macclesfield
    11
    Cheshire
    BritishDirecto128094920001
    WEIR, Gordon
    28 Oldbury Close
    OL10 2NQ Hopwood
    Lancashire
    Secrétaire
    28 Oldbury Close
    OL10 2NQ Hopwood
    Lancashire
    BritishDirector117407120001
    WILD, Mark Steven
    6 Baysdale Drive
    Royton
    OL2 5TR Oldham
    Secrétaire
    6 Baysdale Drive
    Royton
    OL2 5TR Oldham
    British76447520002
    ABBOTT, Peter
    Whitehalgh House
    16 Midfield Langho
    BB6 8HF Blackburn
    Lancs
    Administrateur
    Whitehalgh House
    16 Midfield Langho
    BB6 8HF Blackburn
    Lancs
    United KingdomBritishDirector11384150001
    ALLBUTT, Peter
    2 Clayton Hall Cottage
    Clayton Road
    ST5 4AD Newcastle
    Staffordshire
    Administrateur
    2 Clayton Hall Cottage
    Clayton Road
    ST5 4AD Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector79741650001
    ALTHORPE, Martin John
    2 Southlands
    NN15 7QG Kettering
    Northamptonshire
    Administrateur
    2 Southlands
    NN15 7QG Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritishTechnical Director69006110001
    BARR, Robert George Anthony
    The Stables 2 Northcote Fold
    Linton
    LS22 4UZ Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Stables 2 Northcote Fold
    Linton
    LS22 4UZ Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomIrishChief Executive145342220001
    BROADHEAD, Michael Robinson
    Broomhill
    Northgate Honley
    HD7 2QL Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Broomhill
    Northgate Honley
    HD7 2QL Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishDeputy Managing Director618330001
    BROWN, James Anderson
    82 Thornley Lane
    Timperley
    WA15 7AN Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    82 Thornley Lane
    Timperley
    WA15 7AN Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector31081820001
    CAMPBELL, Laurence James
    The Holt
    WF12 0PA Briestfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Holt
    WF12 0PA Briestfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director165808700001
    CHALLINOR, David John
    Manor Park Business Centre
    Mackenzie Way
    GL51 9TX Cheltenham
    4
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Manor Park Business Centre
    Mackenzie Way
    GL51 9TX Cheltenham
    4
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTax Director138870170001
    DUNLEVY, Michael
    47 Fox Hollow
    TF9 4DE Loggerheads
    Shropshire
    Administrateur
    47 Fox Hollow
    TF9 4DE Loggerheads
    Shropshire
    BritishDirector79741760001
    GANDHI, Virendra Poonamchand
    2 Sunninghey Court
    Brook Lane
    SK9 7SZ Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    2 Sunninghey Court
    Brook Lane
    SK9 7SZ Alderley Edge
    Cheshire
    EnglandBritishDirector123344720001
    GUERIN, John Michael
    184 Prestbury Road
    SK10 3BS Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    184 Prestbury Road
    SK10 3BS Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director4978400002
    HENDERSON, Shirley Wade
    The Old Beams
    Bentley Road
    NR16 1LH Forncett St Peter
    Norwich Norfolk
    Administrateur
    The Old Beams
    Bentley Road
    NR16 1LH Forncett St Peter
    Norwich Norfolk
    BritishCommercial Director47169720001
    HINCHLIFFE, Ralph Eric
    Bank House
    New Mill
    HD7 7HU Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Bank House
    New Mill
    HD7 7HU Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishPublic Co Chairman8506150001
    JACKSON, Colin
    26 Millers Meadow
    Rainow
    SK10 5UE Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    26 Millers Meadow
    Rainow
    SK10 5UE Macclesfield
    Cheshire
    BritishDirector77613100002
    KENNEDY, Brian George
    Manor Park Business Centre
    Mackenzie Way
    GL51 9TX Cheltenham
    4
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Manor Park Business Centre
    Mackenzie Way
    GL51 9TX Cheltenham
    4
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishChairman4067600009
    KENNEDY, Sam
    2 Brampton Road
    SK7 3BS Bramhall
    Cheshire
    Administrateur
    2 Brampton Road
    SK7 3BS Bramhall
    Cheshire
    BritishDirector118920880001
    LEES, Stuart
    Springfield
    Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    Springfield
    Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    EnglandBritishDirector70032700001
    LEWIS, Roger Maxwell
    71 Ravenscroft
    Holmes Chapel
    CW4 7HJ Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    71 Ravenscroft
    Holmes Chapel
    CW4 7HJ Crewe
    Cheshire
    BritishFinancial Controller28294750001
    LUPTON, John Carson
    Rowanburn Hall
    DG14 0QR Rowanburn
    Dumfriesshire
    Administrateur
    Rowanburn Hall
    DG14 0QR Rowanburn
    Dumfriesshire
    United KingdomBritishProduction Director126295960001
    MARTIN, Christopher Jonathan
    4 Highfield Road
    SK10 5LR Bollington
    Cheshire
    Administrateur
    4 Highfield Road
    SK10 5LR Bollington
    Cheshire
    BritishSecretary125360730001
    MARTIN, Terence John
    525 Holcombe Road
    Greenmount
    BL8 4EL Bury
    Lancashire
    Administrateur
    525 Holcombe Road
    Greenmount
    BL8 4EL Bury
    Lancashire
    EnglandBritishChartered Accountant802200001
    MATTHEWSON, Howard James
    8 Walnut Close
    Dean Row
    SK9 2SA Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    8 Walnut Close
    Dean Row
    SK9 2SA Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director40661130001
    MCCLURG, Harry William
    Grove Farm
    Thornley Edge Road Bagnall
    ST9 9LA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Grove Farm
    Thornley Edge Road Bagnall
    ST9 9LA Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishLogistics Director101694300003
    NEILSON, Paul Drummond
    Bridge Barn
    Mapleton Road
    DE6 2AA Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Bridge Barn
    Mapleton Road
    DE6 2AA Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritishManaging Director66491400001
    OLDFIELD, Philip David
    The Bath House 23 Low Town
    HD8 0SB Huddersfield
    Administrateur
    The Bath House 23 Low Town
    HD8 0SB Huddersfield
    BritishFinance Director72702120002

    HW PLASTICS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 22 mai 2006
    Livré le 07 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 sept. 2005
    Livré le 22 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 07 avr. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and trust debenture
    Créé le 02 mars 2004
    Livré le 03 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the chargors or any of them to the trustee and/or the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Main factory hurdsfield industrial estate macclesfield t/n CH420509, bartley way telford way industrial estate kettering NN94753, 1 brunel close daventry t/n NN102129. (For details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC, in Its Capacity as Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 03 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of set off
    Créé le 14 avr. 1986
    Livré le 03 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    The credit balances on any accounts of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 1986Enregistrement d'une charge
    Single debenture
    Créé le 14 avr. 1986
    Livré le 19 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Inc all heritable property & assets in scotland (see M40). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 05 févr. 1985
    Livré le 15 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at plot 12 forming part of the lichfield road industrial estate tamworth staffordshire k/a apollo works.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 04 janv. 1985
    Livré le 10 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at plot 7 forming part of the lichfield road industrial estate k/a apollo works tamworth staffordshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 24 juil. 1981
    Livré le 31 juil. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land fronting on north side of lichfield road tamworth staffordshire containing an area of 9,500 square yards or thereabouts and the buildings known as planent works as comprised in a conveyance 29.2.72.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1981Enregistrement d'une charge

    HW PLASTICS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 avr. 2014Commencement of winding up
    17 févr. 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nigel Morrison
    Hartwell House, 55-61 Victoria Street
    BS1 6FT Bristol
    practitioner
    Hartwell House, 55-61 Victoria Street
    BS1 6FT Bristol
    Alistair Gareth Wardell
    Grant Thornton Uk Llp
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0