NALIM LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | NALIM LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00996170 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NALIM LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NALIM LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 01 janv. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour NALIM LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU United Kingdom à 1 More London Place London SE1 2AF le 22 déc. 2020 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon James Callander en tant qu'administrateur le 25 mars 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon James Callander en tant que secrétaire le 25 mars 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Balbir Kelly-Bisla en tant que directeur le 25 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Balbir Kelly-Bisla en tant que secrétaire le 25 mars 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2020 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 01 janv. 2019 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Michael James Ford en tant qu'administrateur le 24 mai 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Margaret Pape en tant que directeur le 24 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Greenside House 50 Station Road Wood Green London N22 7TP à 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU le 01 mars 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Balbir Kelly-Bisla en tant qu'administrateur le 19 déc. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Balbir Kelly-Bisla en tant que secrétaire le 19 déc. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Luke Amos Thomas en tant que directeur le 19 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Luke Amos Thomas en tant que secrétaire le 19 déc. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 26 déc. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Luke Amos Thomas en tant que secrétaire le 17 sept. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Stamper Fuller en tant que secrétaire le 17 sept. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NALIM LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLANDER, Simon James | Secrétaire | More London Place SE1 2AF London 1 | 268457950001 | |||||||
| CALLANDER, Simon James | Administrateur | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 268458460001 | |||||
| FORD, Michael James | Administrateur | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 244782600001 | |||||
| ANDERSON, Sarah | Secrétaire | Greenside House 50 Station Road, Wood Green N22 7TP London | British | 100326820003 | ||||||
| BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin | Secrétaire | Top Farm High Street PE19 6RX Toseland Cambs | British | 63851130001 | ||||||
| FULLER, Thomas Stamper | Secrétaire | 50 Station Road N22 7TP Wood Green Greenside House London United Kingdom | British | 99624870001 | ||||||
| HOGAN, Kevin Matthew Joseph Christopher | Secrétaire | Willow House 121 Upper Hoyland Road S74 9NL Hoyland South Yorkshire | British | 4502520001 | ||||||
| KELLY-BISLA, Balbir | Secrétaire | Bedford Avenue WC1B 3AU London 1 United Kingdom | 253658590001 | |||||||
| MACQUEEN, Andrea Louise | Secrétaire | 10 Eglington Road Chingford E4 7AN London | British | 98483080001 | ||||||
| MOTT, Matthew John Spencer | Secrétaire | 25 Princess Court 105 Hornsey Lane Highgate N6 5XD London | British | 19710010002 | ||||||
| READ, Dennis | Secrétaire | Greenside House 50 Station Road Wood Green N22 7TP London | British | 125938390001 | ||||||
| THOMAS, Luke Amos | Secrétaire | 50 Station Road N22 7TP Wood Green Greenside House London United Kingdom | 250776010001 | |||||||
| BROWN, John Michael | Administrateur | Milford Court Milford Road South Milford LS25 5AD Leeds | British | 889800001 | ||||||
| COOPER, Neil | Administrateur | 50 Station Road N22 7TP Wood Green Greenside House London United Kingdom | United Kingdom | British | 151902940001 | |||||
| COWBURN, Leonard Ponsonby | Administrateur | Tranby Lane Swanland HU14 3NB East Yorkshire Foxhollows | British | 140373600001 | ||||||
| DUNCAN, Fraser Scott | Administrateur | 25 Kippington Road TN13 2LJ Sevenoaks Kent | England | British | 57508670001 | |||||
| HART, Raymond John | Administrateur | Hazel Court The Drive SM2 7DH Belmont Surrey | British | 63042500001 | ||||||
| HAYGARTH, William Leslie | Administrateur | 9 Hillside Burghfield Common RG7 3BQ Reading Berkshire | British | 11592110002 | ||||||
| KELLY-BISLA, Balbir | Administrateur | Bedford Avenue WC1B 3AU London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 253475470001 | |||||
| LAMBERT, Robert | Administrateur | Red Roof Tithe Barn Lane, Bardsey LS17 9DX Wetherby | United Kingdom | British | 153968320001 | |||||
| LANE, Simon Paul | Administrateur | Greenside House 50 Station Road, Wood Green N22 7TP London | British | 117893540001 | ||||||
| MCGUIGAN, Liam John | Administrateur | 9 Park Drive Thorntonhall G74 5AS Glasgow | Scotland | British | 62685050001 | |||||
| OLIVE, Stephen Gerard | Administrateur | 4 High Park Road Kew TW9 4BH Richmond Surrey | British | 38206770002 | ||||||
| PAPE, Claire Margaret | Administrateur | Bedford Avenue WC1B 3AU London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 215706010001 | |||||
| SINGER, Thomas Daniel | Administrateur | 27 Observatory Road SW14 7QB East Sheen London | British | 63386730002 | ||||||
| SPEARING, Ian John | Administrateur | Greenside House 50 Station Road, Wood Green N22 7TP London | British | 34180750003 | ||||||
| STEELE, Anthony David | Administrateur | Greenside House 50 Station Road N22 7TP Wood Green | United Kingdom | British | 193930220001 | |||||
| THOMAS, Luke Amos | Administrateur | 50 Station Road N22 7TP Wood Green Greenside House London United Kingdom | United Kingdom | British | 181597010001 | |||||
| WASANI, Shailen | Administrateur | Greenside House 50 Station Road, Wood Green N22 7TP London | British | 102956140003 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour NALIM LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 14 janv. 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
NALIM LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Créé le 01 mars 1994 Livré le 10 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 01 mars 1994 Livré le 10 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 01 mars 1994 Livré le 10 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 01 mars 1994 Livré le 10 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 01 mars 1994 Livré le 10 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 01 mars 1994 Livré le 10 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
NALIM LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0