NALIM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNALIM LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00996170
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NALIM LIMITED ?

    • Activités de jeux de hasard et de paris (92000) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe NALIM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NALIM LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 janv. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour NALIM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU United Kingdom à 1 More London Place London SE1 2AF le 22 déc. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 déc. 2020

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination de Mr Simon James Callander en tant qu'administrateur le 25 mars 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Simon James Callander en tant que secrétaire le 25 mars 2020

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Balbir Kelly-Bisla en tant que directeur le 25 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Balbir Kelly-Bisla en tant que secrétaire le 25 mars 2020

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2020 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 janv. 2019

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Michael James Ford en tant qu'administrateur le 24 mai 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Claire Margaret Pape en tant que directeur le 24 mai 2019

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Greenside House 50 Station Road Wood Green London N22 7TP à 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU le 01 mars 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 14 janv. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Balbir Kelly-Bisla en tant qu'administrateur le 19 déc. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Balbir Kelly-Bisla en tant que secrétaire le 19 déc. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Luke Amos Thomas en tant que directeur le 19 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Luke Amos Thomas en tant que secrétaire le 19 déc. 2018

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 26 déc. 2017

    4 pagesAA

    Nomination de Luke Amos Thomas en tant que secrétaire le 17 sept. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Thomas Stamper Fuller en tant que secrétaire le 17 sept. 2018

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de NALIM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALLANDER, Simon James
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Secrétaire
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    268457950001
    CALLANDER, Simon James
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish268458460001
    FORD, Michael James
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish244782600001
    ANDERSON, Sarah
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Secrétaire
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    British100326820003
    BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    Secrétaire
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    British63851130001
    FULLER, Thomas Stamper
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    Secrétaire
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    British99624870001
    HOGAN, Kevin Matthew Joseph Christopher
    Willow House
    121 Upper Hoyland Road
    S74 9NL Hoyland
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Willow House
    121 Upper Hoyland Road
    S74 9NL Hoyland
    South Yorkshire
    British4502520001
    KELLY-BISLA, Balbir
    Bedford Avenue
    WC1B 3AU London
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bedford Avenue
    WC1B 3AU London
    1
    United Kingdom
    253658590001
    MACQUEEN, Andrea Louise
    10 Eglington Road
    Chingford
    E4 7AN London
    Secrétaire
    10 Eglington Road
    Chingford
    E4 7AN London
    British98483080001
    MOTT, Matthew John Spencer
    25 Princess Court
    105 Hornsey Lane Highgate
    N6 5XD London
    Secrétaire
    25 Princess Court
    105 Hornsey Lane Highgate
    N6 5XD London
    British19710010002
    READ, Dennis
    Greenside House
    50 Station Road Wood Green
    N22 7TP London
    Secrétaire
    Greenside House
    50 Station Road Wood Green
    N22 7TP London
    British125938390001
    THOMAS, Luke Amos
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    Secrétaire
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    250776010001
    BROWN, John Michael
    Milford Court Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    Administrateur
    Milford Court Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    British889800001
    COOPER, Neil
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish151902940001
    COWBURN, Leonard Ponsonby
    Tranby Lane
    Swanland
    HU14 3NB East Yorkshire
    Foxhollows
    Administrateur
    Tranby Lane
    Swanland
    HU14 3NB East Yorkshire
    Foxhollows
    British140373600001
    DUNCAN, Fraser Scott
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish57508670001
    HART, Raymond John
    Hazel Court
    The Drive
    SM2 7DH Belmont
    Surrey
    Administrateur
    Hazel Court
    The Drive
    SM2 7DH Belmont
    Surrey
    British63042500001
    HAYGARTH, William Leslie
    9 Hillside
    Burghfield Common
    RG7 3BQ Reading
    Berkshire
    Administrateur
    9 Hillside
    Burghfield Common
    RG7 3BQ Reading
    Berkshire
    British11592110002
    KELLY-BISLA, Balbir
    Bedford Avenue
    WC1B 3AU London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Bedford Avenue
    WC1B 3AU London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish253475470001
    LAMBERT, Robert
    Red Roof
    Tithe Barn Lane, Bardsey
    LS17 9DX Wetherby
    Administrateur
    Red Roof
    Tithe Barn Lane, Bardsey
    LS17 9DX Wetherby
    United KingdomBritish153968320001
    LANE, Simon Paul
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Administrateur
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    British117893540001
    MCGUIGAN, Liam John
    9 Park Drive
    Thorntonhall
    G74 5AS Glasgow
    Administrateur
    9 Park Drive
    Thorntonhall
    G74 5AS Glasgow
    ScotlandBritish62685050001
    OLIVE, Stephen Gerard
    4 High Park Road
    Kew
    TW9 4BH Richmond
    Surrey
    Administrateur
    4 High Park Road
    Kew
    TW9 4BH Richmond
    Surrey
    British38206770002
    PAPE, Claire Margaret
    Bedford Avenue
    WC1B 3AU London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Bedford Avenue
    WC1B 3AU London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish215706010001
    SINGER, Thomas Daniel
    27 Observatory Road
    SW14 7QB East Sheen
    London
    Administrateur
    27 Observatory Road
    SW14 7QB East Sheen
    London
    British63386730002
    SPEARING, Ian John
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Administrateur
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    British34180750003
    STEELE, Anthony David
    Greenside House
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Administrateur
    Greenside House
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    United KingdomBritish193930220001
    THOMAS, Luke Amos
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish181597010001
    WASANI, Shailen
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Administrateur
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    British102956140003

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour NALIM LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    14 janv. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    NALIM LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The William Hill Group Limited
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • William Hill Organization Limited
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • William Hill Organization Limited
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank Plcas Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries(As Defined)
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 mars 1994
    Livré le 10 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The William Hill Group Limited
    Transactions
    • 10 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NALIM LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 mars 2022Dissolved on
    16 déc. 2020Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    practitioner
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0