DURKAN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDURKAN LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00997195
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DURKAN LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe DURKAN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DURKAN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DURKAN BROS LIMITED15 déc. 197015 déc. 1970

    Quels sont les derniers comptes de DURKAN LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 nov. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 août 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DURKAN LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour DURKAN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Ian Mcardle en tant qu'administrateur le 01 déc. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Roger Kimber en tant que directeur le 30 nov. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Roger Kimber en tant que secrétaire le 30 nov. 2024

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2023

    34 pagesAA

    Cessation de la nomination de Timothy Michael Carpenter en tant que directeur le 01 janv. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2022

    33 pagesAA

    Satisfaction de la charge 009971950064 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Jason Russell Mark Smith en tant que directeur le 05 avr. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2021

    30 pagesAA

    Nomination de Mr Russell Murphy en tant qu'administrateur le 01 avr. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Mark Geoffrey Gordon en tant qu'administrateur le 01 avr. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Gary Barton en tant qu'administrateur le 01 avr. 2022

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jason Russell Mark Smith le 01 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dean Martin en tant que directeur le 01 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Michael Carpenter le 01 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Daniel Gerard Durkan le 01 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Philip Briggs le 01 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Daniel Gerard Durkan le 20 août 2021

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2020

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jason Russell Mark Smith le 14 juin 2021

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Timothy Michael Carpenter en tant qu'administrateur le 10 mai 2021

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de DURKAN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARTON, Gary
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector294666760001
    BRIGGS, James Philip
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishDirector46355350005
    DURKAN, Daniel Gerard
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    EnglandIrishChairman6330180025
    GORDON, Mark Geoffrey
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector232810410001
    MCARDLE, Ian
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Finance Director274362930001
    MURPHY, Ronan Patrick
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    United KingdomIrishChartered Accountant151628410001
    MURPHY, Russell
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector294667720001
    CRESSWELL, Ian Philip
    Hazelwood Drive
    AL4 0UZ St. Albans
    128
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hazelwood Drive
    AL4 0UZ St. Albans
    128
    Hertfordshire
    United Kingdom
    BritishHealth & Safety Director129678860001
    FRAHER, David Alan
    Kingsley House
    35a Kings Road Arkley
    EN5 4EG Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Kingsley House
    35a Kings Road Arkley
    EN5 4EG Barnet
    Hertfordshire
    Irish6330190002
    KIMBER, Paul Roger
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    266086500001
    MURPHY, Ronan Patrick
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    200947460001
    BARTON, Robert James
    6 Spencer Avenue
    Cheshunt
    EN7 6RR Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Spencer Avenue
    Cheshunt
    EN7 6RR Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishJoint Construction Director27904090001
    BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul
    20 Harold Road
    SE19 3PL London
    Administrateur
    20 Harold Road
    SE19 3PL London
    EnglandBritishDirector46232460002
    BROOKS, David Nicholas
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant153492270002
    CARPENTER, Timothy Michael
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector283318950001
    CLARK, Robert Adams
    Woodside
    Meadway
    HP4 2PL Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Woodside
    Meadway
    HP4 2PL Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director27904070002
    CRESSWELL, Ian Philip
    Hazelwood Drive
    AL4 0UZ St. Albans
    128
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hazelwood Drive
    AL4 0UZ St. Albans
    128
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishHealth & Safety Director129678860001
    DURKAN, Patrick Francis
    65 De Bohun Court
    De Bohun Avenue Southgate
    N14 4PU London
    Administrateur
    65 De Bohun Court
    De Bohun Avenue Southgate
    N14 4PU London
    IrishBuilder63578930001
    DURKAN, William
    Carrowkeel Stud
    Ballyedmonduff
    IRISH Stepaside Sandyford
    Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Carrowkeel Stud
    Ballyedmonduff
    IRISH Stepaside Sandyford
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrishBuilder10077030003
    FRAHER, David Alan
    Kingsley House
    35a Kings Road Arkley
    EN5 4EG Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    Kingsley House
    35a Kings Road Arkley
    EN5 4EG Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomIrishChartered Accountant6330190002
    GILLIS, Patricia
    Rennesley Stables
    Anchor Lane Wadesmill
    SG12 0TE Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    Rennesley Stables
    Anchor Lane Wadesmill
    SG12 0TE Ware
    Hertfordshire
    BritishPartnership Director93722280001
    HARAJDA, Julian
    17 Lammas Road
    SL1 6LG Slough
    Berkshire
    Administrateur
    17 Lammas Road
    SL1 6LG Slough
    Berkshire
    BritishManaging Director84331630001
    HENNESSY, Timothy
    16 Woodville Road
    W5 2SF London
    Administrateur
    16 Woodville Road
    W5 2SF London
    IrishAccountant34777960001
    JANKOWSKI, Dominic George
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishConstruction Director190729190001
    KIMBER, Paul Roger
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant266086180001
    LOUGHLIN, John Francis
    24 Blythwood Gardens
    CM24 8HQ Stansted
    Essex
    Administrateur
    24 Blythwood Gardens
    CM24 8HQ Stansted
    Essex
    EnglandIrishJoint Construction Director23694020001
    LUNN, Martin
    12 Wheatfield Way
    SS16 6SN Basildon
    Essex
    Administrateur
    12 Wheatfield Way
    SS16 6SN Basildon
    Essex
    EnglandBritishDevelopment Director118770930001
    MARTIN, Dean
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    EnglandBritishConstruction Director213201310001
    MCATAMNEY, Martin
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    EnglandIrishPreconstruction, Technical & Design Director229214050001
    MCLOUGHLIN, Noel
    17 The Pleasance
    AL5 3NA Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 The Pleasance
    AL5 3NA Harpenden
    Hertfordshire
    IrishConstruction Director46355320001
    MURRAY, David
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    EnglandBritishBid Director177225030001
    NATHAN, Daren
    38 Wayside Avenue
    WD23 4SQ Bushey
    Hertfordshire
    Administrateur
    38 Wayside Avenue
    WD23 4SQ Bushey
    Hertfordshire
    EnglandBritishDevelopment Director118770850001
    NELSON, Michael Gary
    Durkan House
    214-224 High Street
    EN8 7DR Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    Durkan House
    214-224 High Street
    EN8 7DR Waltham Cross
    Hertfordshire
    EnglandBritishConstruction Director178271420001
    PUDELEK, Michael Thomas
    99 Winn Road
    SE12 9EZ London
    Administrateur
    99 Winn Road
    SE12 9EZ London
    United KingdomBritishBuilder21334310001
    ROBINS, Gary
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Elstree Gate
    Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishConstruction Director147782250001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DURKAN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Durkan Estates Limited
    Elstree Gate, Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    England
    06 avr. 2016
    Elstree Gate, Elstree Way
    WD6 1JD Borehamwood
    4
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUk Companies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House Uk
    Numéro d'enregistrement02132837
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    DURKAN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 mai 2019
    Livré le 15 mai 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The leasehold estate in part of the ground floor and the first, second, third and fourth floors of the building known as phase 1, waterside north, exchange street, aylesbury shown edged red on the plan annexed to this charge and forming part of the land registered at the land registry under title numbers BM229536, BM347345 and BN322112 demised or to be demised by the lease.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aylesbury Vale District Council
    Transactions
    • 15 mai 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 mai 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 15 nov. 2016
    Livré le 15 nov. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land at putney green development, london SW15 as more particularly described in a lease dated the same date as this deed and made between (1) the mayor and burgesses of the london borough of wandsworth (as landlord) and (2) durkan limited (as tenant).
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 25 avr. 2016
    Livré le 28 avr. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee
    Créé le 19 avr. 2002
    Livré le 04 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums of money due or to become due from durkan new homes limited to the chargee
    Brèves mentions
    A lien on all securities or other property of durkan holdings limited and durkan limited to set off and apply any credit balance in any accounts of the guarantors with the bank.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 04 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 févr. 1997
    Livré le 01 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & the Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 01 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 05 janv. 1993
    Livré le 13 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 26 août 1992
    Livré le 05 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 05 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 21 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The properties specified on form M395, ref M320 (see form for full details).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland
    Transactions
    • 21 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 1987
    Livré le 18 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the parent or any associated company or any guarantor (as defined) to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H property k/a units 7-10 (inclusive) townsend industrial estate waxlow road l/b of brent t/n ngl 386161 and all buildings and other structures (for further details please see doc M99/19 aug/ln).
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 18 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 18 juin 1987
    Livré le 26 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land & buildings lying to the north road, hertford floating charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks, P.L.C.
    Transactions
    • 26 juin 1987Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 nov. 1986
    Livré le 17 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the derkean holidings limited. To the chargee on any account whatsoever nor exceeding sterling pounds 1,500,000
    Brèves mentions
    Land to the east of great north road barnet t/no. Hd 177941 together with the buildings and fixtures thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Investment Bank of Ireland Limited
    Transactions
    • 17 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 17 oct. 1986
    Livré le 05 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Phase iii development or f/hold land lying to the north west of harefield road, uxbridge. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transactions
    • 05 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 juin 1986
    Livré le 26 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the comany or any associated company or any guarantor (as defined) ot the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/Hold 46, princes gate, london SW7 l/b of the city of westminster title no ngl 249691 all and any proceeds of sale. Fixed equitable charge over the benefit of each and all or the personal covenants by the lesses under the terms of the leases. Fixed charge over the copyright fixed equitable charge over the benefit of all guarantees, warranties and representations. Building materials (see doc M81 for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • United Ominions Trust Limited
    Transactions
    • 26 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 12 mai 1986
    Livré le 22 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Princes mansions havefield road uxbridge T.n mx 222521 all all stocks shares & other securities.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 22 mai 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 avr. 1986
    Livré le 21 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company or any associated company or any guarantor to the chargee in respect of "the debt" as defined in the chargee.
    Brèves mentions
    F/Hold land known as 153 and 155 east barnet road, east barnet london borough of barnet title no ngl 88297 all buildings and other structures, (see doc m 76).
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 21 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 14 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 03 avr. 1986
    Livré le 08 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Phase 1 land and buildings on the west side of harefield road uxbridge and phase 2 land at the rear of 11-65 harefield road, uxbridge. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 31 janv. 1986
    Livré le 05 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a master hire purchase agreement dated 11.12.85 and contract no 3 dated 31.1.86 or any variation or extension thereof and/or this charge
    Brèves mentions
    All rights, titles, benefites and interest of the company whatsoever, both present and future under the following lease agreement for the lease of motor vehicles date 31/1/86 parties the company(1) and city rentals limited (CR80).
    Personnes ayant droit
    • Banco Hispano Americano Limited.
    Transactions
    • 05 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 20 janv. 1986
    Livré le 27 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a master hire purchase agreement dated 15-1-86.
    Brèves mentions
    All rights, titles, benefits and interests or the company whatsoever, both present & future under the following lease agreement for the lease of motor vehicaled supplied by the company. Lease agreement dated 15/1/86 between the company (1) and city rentals limited ccr/78.(2).
    Personnes ayant droit
    • Banco Hispano Americano Limited.
    Transactions
    • 27 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 11 déc. 1985
    Livré le 20 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the trems of a hire purchase agreement and contract dated 11TH december, 1985.
    Brèves mentions
    Right title and interests of the company under h p agreement dated 11-12-85 for lease of motor vehicles. (See doc m 73).
    Personnes ayant droit
    • Banco Hispano Americano Limited
    Transactions
    • 20 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 1985
    Livré le 22 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any associated company or guarantor (as defined n the legal charge) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the f/hold land lying to the south west of meney lane, west drayton, l/b of hillington. T/no-ngl 353379 & possessany title no- ngl 404718 fixed equitable charge all & any proceeds of sale. Fixed charge over the copyright fixed equitable charge over the benefit of all guarangees warrantees & represntational & building materials (see doc M72 for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited.
    Transactions
    • 22 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 07 mai 1985
    Livré le 25 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the south or ver cottge 105 park street st. Albans herts all stocks, shares & securities (see doc M71 for details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks Limited
    Transactions
    • 25 mai 1985Enregistrement d'une charge
    Indenture of assignment and specific charge.
    Créé le 10 déc. 1984
    Livré le 14 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1) all sums due or to become due under a leare dated 10-12-84 in respect of the following equipment:- one automatic velnating block making machine tyne BC5SD per invocice no-CO1874 fifteen raching and packing systems per invoice no 9705 one automatic batching plant per invocie no- 9706 2) the sum os sterling pounds 307,971.90 and all susm due or to become due by the department of economic development to the company in respect of a standard capital grant for assets fixed out under part iv of the industrial development (NI) under 1982 in respect of the equipment (see doc M70 for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Investment Bank of Ireland Limited.
    Transactions
    • 14 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 09 nov. 1984
    Livré le 10 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land at rear of 11/65 harefield road, hillingdon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks Limited.
    Transactions
    • 10 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 03 sept. 1984
    Livré le 05 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold canberra & upper & lower hillford, aerodrane road, barnet. Title no. Ngl 398867. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks Limited.
    Transactions
    • 05 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 24 juil. 1984
    Livré le 10 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land at rear of 9 warren drive, greenford. Title no. Ngl 473980. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks Limited.
    Transactions
    • 10 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0