MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED

MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMARLON INSURANCE COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00998720
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Surrey
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SKANDIA MARINE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED01 janv. 199201 janv. 1992
    VESTA (U.K.) INSURANCE COMPANY LIMITED01 janv. 197101 janv. 1971

    Quels sont les derniers comptes de MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Dissolution by c/order effective 27/07/2017 manual gazette issued
    1 pagesMISC

    Ordonnance du tribunal

    Diss by c/order eff 27/07/2017 m
    28 pagesOC

    Gazette finale dissoute par décret

    pagesGAZ2

    Déclaration de confirmation établie le 14 mars 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 3 Guildford Business Park Guildford England and Wales GU2 8XG United Kingdom à 3 Guildford Business Park Guildford Surrey GU2 8XG le 03 août 2016

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Avaya House Cathedral Hill Guildford Surrey GU2 7YL à 3 Guildford Business Park Guildford England and Wales GU2 8XG le 02 août 2016

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    35 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mars 2016

    État du capital au 16 mars 2016

    • Capital: USD 23,172,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Steven Roger Western le 30 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Redénomination des actions. État du capital 08 sept. 2015

    • Capital: USD 23,172,000
    4 pagesSH14

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    22 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 avr. 2015

    État du capital au 01 avr. 2015

    • Capital: GBP 15,448,000
    SH01

    Nomination de Mr Gary Leonard Griffiths en tant qu'administrateur le 19 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Patrick Cogavin en tant qu'administrateur le 09 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    23 pagesAA

    Cessation de la nomination de Theo Wilkes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 009987200003

    22 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 mars 2014

    État du capital au 17 mars 2014

    • Capital: GBP 15,448,000
    SH01

    Divers

    Court order confiming cross border merger with a/s det kjobenhavnske reassurance compagni on 31/12/13
    3 pagesMISC

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    21 pagesAA

    Divers

    CB01 draft terms of merger
    46 pagesMISC

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Nomination de Theo James Rickus Wilkes en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    20 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEXTALL, Siobhan Mary
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Irish65283470005
    COGAVIN, Patrick Eamon
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish191149500001
    GRIFFITHS, Gary Leonard
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish184390930001
    THOMAS, Clive Paul
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish170854570001
    TURNER, Alan John
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish103211340004
    WESTERN, Steven Roger
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish98436900002
    COPPELL, Helen
    27 Chalky Bank Road
    Rainham
    ME8 7NP Gillingham
    Kent
    Secrétaire
    27 Chalky Bank Road
    Rainham
    ME8 7NP Gillingham
    Kent
    British126248740001
    GRANT, Philip James
    Clay Chimneys House Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Clay Chimneys House Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Hertfordshire
    British34492660002
    TUKE, Eamonn Vincent
    Eden View
    Penshurst Road, Penshurst
    TN11 8HY Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    Eden View
    Penshurst Road, Penshurst
    TN11 8HY Tonbridge
    Kent
    British29466740001
    CORNHILL SECRETARIES LIMITED
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    Secrétaire désigné
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    900023430001
    ALDOUS, Stephen David
    8 The Cedars
    GU1 1YU Guildford
    Surrey
    Administrateur
    8 The Cedars
    GU1 1YU Guildford
    Surrey
    British103211370001
    ANONSEN, Hans Terje
    Ostre Stiaberget 62
    Godvik N-5074
    Norway
    Administrateur
    Ostre Stiaberget 62
    Godvik N-5074
    Norway
    Norwegian34152530001
    BAMBER, Anthony
    Adstone
    Bildeston Road Combs
    IP14 2JZ Stowmarket
    Suffolk
    Administrateur
    Adstone
    Bildeston Road Combs
    IP14 2JZ Stowmarket
    Suffolk
    EnglandBritish70181210003
    BERGENSTJERNA, Johan Philip
    Strandvagen 55
    Stockholm Se-11523
    Sweden
    Administrateur
    Strandvagen 55
    Stockholm Se-11523
    Sweden
    Swedish67925020002
    BOWER, William John
    70 Prince George Avenue
    Oakwood
    N14 4SP London
    Administrateur
    70 Prince George Avenue
    Oakwood
    N14 4SP London
    United KingdomBritish28017860001
    BRANDERS, Christina Maria
    11 Isokaari 11 B 27
    FOREIGN Helsinki
    Fi-00200
    Finland
    Administrateur
    11 Isokaari 11 B 27
    FOREIGN Helsinki
    Fi-00200
    Finland
    Finnish102090620002
    BRUVIK, Trygve
    Rotvollen 25
    N-5041 Nordas
    Norway
    Administrateur
    Rotvollen 25
    N-5041 Nordas
    Norway
    Norwegian42547740001
    GRANT, Philip James
    Clay Chimneys House Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Clay Chimneys House Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish34492660002
    HALL, Nigel Rodger
    56 Lower Green Road
    KT10 8HD Esher
    Surrey
    Administrateur
    56 Lower Green Road
    KT10 8HD Esher
    Surrey
    United KingdomBritish65284120001
    HESSELMANN, Christian
    Norde Otervegen 7
    Bergen
    N 5045
    Norway
    Administrateur
    Norde Otervegen 7
    Bergen
    N 5045
    Norway
    Norwegian74376070001
    LINDKVIST, Lars Hakan
    18 Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    Surrey
    Administrateur
    18 Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    Surrey
    British36179090001
    MAKI, Kari Sakari
    Ilpoistente 33 B8
    FOREIGN Turku
    20740
    Finland
    Administrateur
    Ilpoistente 33 B8
    FOREIGN Turku
    20740
    Finland
    Finnish83922180001
    NICHOLS, Thomas James
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish129335930001
    NOKES, Gareth Howard John
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandEnglish141023860001
    ODFJELL, Johan Fredrik
    Shipanesveien 318
    Hjellestad 506
    Norway
    Administrateur
    Shipanesveien 318
    Hjellestad 506
    Norway
    Norwegian58974200001
    POYHONEN, Jorma Tapani
    Laurinpojankuja 4b8
    00840 Helsinki
    Finland
    Administrateur
    Laurinpojankuja 4b8
    00840 Helsinki
    Finland
    Finnish67367640001
    RATHKE, Tom
    Roggesvei 66
    N-5062 Bones
    FOREIGN Bergen Norway
    Administrateur
    Roggesvei 66
    N-5062 Bones
    FOREIGN Bergen Norway
    Norwegian37470670001
    ROCKE, David Michael
    11 Meadow Lane
    DV08 Devonshire
    Bermuda
    Administrateur
    11 Meadow Lane
    DV08 Devonshire
    Bermuda
    British123740180002
    STAAF, Per Ove
    6 Courtwood Drive
    TN13 2LR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    6 Courtwood Drive
    TN13 2LR Sevenoaks
    Kent
    Swedish17857340001
    TEPSTAD, Trond Einar
    Kraakeneslia 47
    5152 Boenes
    Norway
    Administrateur
    Kraakeneslia 47
    5152 Boenes
    Norway
    Norwegian65215820001
    VON HERTZEN, Hans Magnus Ake
    Magnus Hagelstamintie 3 D 14
    Kaunianen
    02700
    Finland
    Administrateur
    Magnus Hagelstamintie 3 D 14
    Kaunianen
    02700
    Finland
    Finnish98181940001
    WILKES, Theo James Rickus
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish172126980001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    06 avr. 2016
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06239044
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MARLON INSURANCE COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 mai 2014
    Livré le 24 mai 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Citibank Europe PLC
    Transactions
    • 24 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A reinsurance deposit agreement
    Créé le 15 nov. 1995
    Livré le 24 nov. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the reinsurance deposit agreement or under any agreement or on any other account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies at the date of the reinsurance deposit agreement standing to the credit of:- (a) each reinsurance deposit or other account the account details of which appear in clause 3(a)(i) of the deed or otherwise as may from time to time agreed in writing between the bank and the chargor;(b) any account opened by the bank pursuant to clauses 3(c) or 11(b) of the reinsurance deposit agreement;or any other account referred to in clause 13 of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank,N.A.
    Transactions
    • 24 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    A security agreement
    Créé le 15 nov. 1995
    Livré le 24 nov. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security agreement,under any agreement or on any other account whatsoever
    Brèves mentions
    All the chargor's rights,title and interest in and to:(i) all securities which are held by,to the order,for the account or under the control or direction of the bank;(ii) all securities which are held by any clearance system on behalf of,for the account of or to the order of the bank;(iii) all rights,benefits and proceeds arising from or in respect of any of the securities referred to in (I) and (ii) above;(iv) all sums of money standing to the credit of any account opened or maintained by the bank for the chargor;and (v) all sums standing to the credit of any account opened or maintained by any clearance system for the chargor.
    Personnes ayant droit
    • Citibank,N.A.
    Transactions
    • 24 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0