INVESTABLE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | INVESTABLE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00999661 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INVESTABLE LIMITED ?
Adresse du siège social | Drayton Hall Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex England England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INVESTABLE LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2011 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2012 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INVESTABLE LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mai 2017 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 juin 2017 |
En retard | Oui |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour INVESTABLE LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour INVESTABLE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Victoria Anne George en tant que directeur le 31 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Restauration par ordonnance du tribunal | 3 pages | AC92 | ||||||||||
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Kpmg Restructuring 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB* le 15 mars 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 4 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 9 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1FW United Kingdom* le 04 oct. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Christopher Francis Judd en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy Gorman en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Jeremy Philip Gorman en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lucy Turner en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Rachel Nancye Carr le 01 déc. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Cape House 3 Red Hall Avenue Paragon Business Village Wakefield West Yorkshire WF1 2UL* le 01 déc. 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 16 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Lucy Finch Turner le 23 déc. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Rachel Nancye Carr le 18 déc. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Victoria Anne George le 18 déc. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008 | 1 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INVESTABLE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDD, Christopher Francis | Secrétaire | Millenia Tower One Temasek Avenue Singapore Apartment 09-03 039192 Singapore | 169544760001 | |||||||
AMEY, Rachel Nancye | Administrateur | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 133976650005 | ||||
CONIBEAR, David Phillip | Secrétaire | 7 The Cedars Tilehurst RG31 6JW Reading Berkshire | British | 52581380002 | ||||||
CRAIGIE, Claire Louise | Secrétaire | 4 Hill Top LS29 9RS Ilkley West Yorkshire | British | Company Secretary | 82905830002 | |||||
GORMAN, Jeremy Philip | Secrétaire | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | 160675350001 | |||||||
PITT-PAYNE, Michael George | Secrétaire | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | British | Secretary | 829660002 | |||||
RHODES, Jeremy | Secrétaire | Grevel Lane GL55 6HS Chipping Campden Kelmscott Gloucestershire | British | 129206660001 | ||||||
SMITH, Stephen Harry | Secrétaire | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | Company Secretary | 64449570001 | |||||
TURNER, Lucy Finch | Secrétaire | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | British | 133976740001 | ||||||
WHITWORTH, Benjamin Warwick | Secrétaire | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | British | Solicitor | 99402260002 | |||||
BINGHAM, Richard Keith | Administrateur | Church Road Brasted TN16 1HZ Westerham Beechcroft Kent | British | Accountant | 131046090001 | |||||
CARTWRIGHT, Paul Ian | Administrateur | 195 Highbury Quadrant N5 2TE London | British | Chartered Accountant | 40873830002 | |||||
CONIBEAR, David Phillip | Administrateur | 7 The Cedars Tilehurst RG31 6JW Reading Berkshire | England | British | Chartered Accountant | 52581380002 | ||||
CRAIGIE, Claire Louise | Administrateur | 15 Marlborough Square LS29 8PU Ilkley West Yorkshire | British | Company Secretary | 82905830001 | |||||
DUXBURY, Brian | Administrateur | Carr Lea 15 Platting Road Lydgate Saddleworth OL4 4DL Oldham Lancashire | British | Company Director | 32253580001 | |||||
GEORGE, Victoria Anne | Administrateur | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Tax Adviser | 134024500001 | ||||
GILLESPIE, Andrew James | Administrateur | 5 White Moss Close Ackworth WF7 7QT Pontefract West Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 89560440001 | ||||
GREEN, Alan | Administrateur | 2 Barmpton Mews DL1 3SZ Darlington County Durham | England | English | Company Director | 20442600005 | ||||
JACKSON, Francis Keith John | Administrateur | The Artists House Station Road Goring On Thames RG8 9HA Reading Berkshire | England | British | Company Director | 15469790001 | ||||
NEEDHAM, Michael John | Administrateur | Egerton Lincoln Road Chalfont Heights SL9 9TG Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | Company Director | 46524850001 | |||||
PITT-PAYNE, Michael George | Administrateur | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 829660002 | ||||
SMITH, Stephen Harry | Administrateur | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | Company Secretary | 64449570001 | |||||
TAYLOR, Keith Denton | Administrateur | 14 Meridian Way Cochrane Park NE7 7RU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | Company Director | 49054110001 | ||||
WHITWORTH, Benjamin Warwick | Administrateur | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | England | British | Solicitor | 99402260002 | ||||
WIDDOWSON, Ian Richard | Administrateur | 49 Eghams Wood Road HP9 1JX Beaconsfield Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 16941000001 | |||||
CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Administrateur | Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Cape House, 3 West Yorkshire United Kingdom | 131421100001 |
INVESTABLE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating security document | Créé le 20 juil. 2001 Livré le 26 juil. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined) | |
Brèves mentions Freehold properties, (I) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 févr. 1991 Livré le 21 févr. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti £350,000 | |
Brèves mentions Floating charge upon all undertaking and all property and assets present and future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 30 avr. 1984 Livré le 10 mai 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H soth side of littlebank street,oldham greater manchester. T/n LA349086. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 30 avr. 1984 Livré le 10 mai 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H- northside of littlebank street, oldham greater manchester tn- OL5572. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 23 mars 1984 Livré le 29 mars 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H land and premises at the junction at carton right street, and wardle street tn ol 6548. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 23 mars 1984 Livré le 29 mars 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H land and buildings k/a land and buildings to the south east side of moorhey street, oldham, greater manchester tn la 33706. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 23 mars 1984 Livré le 29 mars 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land and premises at 3A moorhey street oltham, greater manchester and 1 and 3 court number one, moorhey street,l oldham greater manchester tn OL6885. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 23 mars 1984 Livré le 29 mars 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land at 5 and 7 moorhey street, oldham greater manchester and 2, number one court, oldham greater manchester tn ol 6601. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 23 mars 1984 Livré le 29 mars 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H land at the back of 3A moorhey street, oldham greater manchester T.n la 23442. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 06 mars 1984 Livré le 12 mars 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H & l/h land & premises k/a moorhey street, oldham, greater manchester T.nos- ol 6885 la 23442 ol 6601 ol 6548 la 33706. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 02 nov. 1982 Livré le 05 nov. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 28 mai 1974 Livré le 05 juin 1974 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Floating charg on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
INVESTABLE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0