HAVENSTREET LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHAVENSTREET LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01001557
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HAVENSTREET LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HAVENSTREET LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HAVENSTREET LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRANS EURO WORLDWIDE MOVERS (UK) LIMITED29 juin 199929 juin 1999
    BRENT PARK MOVERS AND STORAGE LIMITED30 sept. 199230 sept. 1992
    TRANS EURO WORLDWIDE MOVERS LIMITED09 sept. 198509 sept. 1985
    TRANS-EURO ROAD SERVICES LIMITED03 févr. 197103 févr. 1971

    Quels sont les derniers comptes de HAVENSTREET LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour HAVENSTREET LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mai 2021

    3 pagesAA

    État du capital au 24 juin 2021

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2020

    3 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c and capital redemption reserve 11/05/2021
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 sept. 2021 au 31 mai 2021

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2019

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name13 juil. 2018

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2016

    3 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 janv. 2016

    État du capital au 08 janv. 2016

    • Capital: GBP 62,500
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 janv. 2015

    État du capital au 28 janv. 2015

    • Capital: GBP 62,500
    SH01

    Qui sont les dirigeants de HAVENSTREET LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROMER, Timothy Paul
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Secrétaire
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    New Zealander42939040001
    METHA, Yogesh
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Administrateur
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    United KingdomBritish88858590001
    ROMER, Timothy Paul
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Administrateur
    Drury Way
    Brent Park
    NW10 0JN London
    United KingdomNew Zealander42939040001
    MCGREAL, Lawrence Edward
    1 Forest Court
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Surrey
    Secrétaire
    1 Forest Court
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Surrey
    British165048490001
    EVANS, Paul John
    Heath Lodge Heath Side
    Hampstead
    NW3 1LB London
    Administrateur
    Heath Lodge Heath Side
    Hampstead
    NW3 1LB London
    United KingdomBritish56591870006
    GRACE, Frank Clayton
    5 Chesterfield Hill
    W1X 7RP London
    Administrateur
    5 Chesterfield Hill
    W1X 7RP London
    British17960860002
    HAMBRIDGE, Neil Edgar
    26 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    Administrateur
    26 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    British39208740001
    MCGREAL, Lawrence Edward
    1 Forest Court
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Surrey
    Administrateur
    1 Forest Court
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Surrey
    EnglandBritish165048490001
    PECK, Stewart Kevin
    25 Cedar Close
    SL0 0QX Iver Heath
    Buckinghamshire
    Administrateur
    25 Cedar Close
    SL0 0QX Iver Heath
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish93977420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HAVENSTREET LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Trans Euro Limited
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Drury Way
    England
    06 avr. 2016
    Brent Park
    NW10 0JN London
    Drury Way
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement02676889
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HAVENSTREET LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 27 mai 1998
    Livré le 02 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Créé le 10 sept. 1990
    Livré le 27 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole (first) that plot or area of ground lying generally on the north west of woodside road, bridge of don, aberdeen in the parish of old machar & county of aberdeen extending to one acre & two hundred & sixty six decimal or thousandth parts of an acre (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC.
    Transactions
    • 27 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 août 1989
    Livré le 01 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land k/a:- the staton & staveley site lying to the north west of north circular road, neasden london borough of brent.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 25 juil. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 août 1989
    Livré le 09 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 30 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 août 1989
    Livré le 09 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the north west of the north circular road, neasden l/b of brent title no. Ngl 472350.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 16 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 août 1989
    Livré le 09 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the north west of the north circular road, neasden l/b of brent title no mx 306400.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 30 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 mars 1987
    Livré le 02 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjoining railway, neasden brent, title no:- mx 305400.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transactions
    • 02 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    Fixed charge
    Créé le 14 févr. 1986
    Livré le 25 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all moneys now or hereafter deposited by the company as a continuing security until all liabilities of the company to the bank have been full repaid to the bank and/or otherwise wholly satisfied and discharged.
    Personnes ayant droit
    • County Bank Limited.
    Transactions
    • 25 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    Second legal charge
    Créé le 17 août 1984
    Livré le 24 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north west side of the north circular road brent london. Title no. Ngl 472350. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank Leumi (U.K) PLC
    Transactions
    • 24 août 1984Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 17 août 1984
    Livré le 24 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situate on the north west side of the north circular road neasden title no ngl 472350 and f/h land known as site 28 fourth way wembley trading estate wembley london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • County Bank Limited
    Transactions
    • 24 août 1984Enregistrement d'une charge
    Second legal mortgage
    Créé le 17 août 1984
    Livré le 24 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land forming part of wembley stadium trading estate wembley title no ngl 486497. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank Leumi (U.K) PLC
    Transactions
    • 24 août 1984Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 26 juil. 1982
    Livré le 06 août 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Bank Leumi (U.K) PLC
    Transactions
    • 06 août 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0