AUK REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAUK REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01004276
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AUK REALISATIONS LIMITED ?

    • fabrication d'aéronefs et de vaisseaux spatiaux et de machines connexes (30300) / Industries manufacturières

    Où se situe AUK REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    11th Floor Landmark St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AUK REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AIM ALTITUDE UK LIMITED08 sept. 201708 sept. 2017
    AIM AVIATION (JECCO) LIMITED15 déc. 198915 déc. 1989
    JECCO AVIATION LIMITED24 févr. 198224 févr. 1982
    C.GROUP LIMITED(THE)09 mars 197109 mars 1971

    Quels sont les derniers comptes de AUK REALISATIONS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2021
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2022
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AUK REALISATIONS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au12 déc. 2022
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation26 déc. 2022
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au12 déc. 2021
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour AUK REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 juin 2024

    33 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    pagesAM22

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    36 pagesAM22

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    63 pagesAM10

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Change name to auk realisations LIMITED 27/07/2022
    RES13

    Certificat de changement de nom

    Company name changed aim altitude uk LIMITED\certificate issued on 30/08/22
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name30 août 2022

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Résultat de la réunion des créanciers

    6 pagesAM07

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    86 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de 1 Viscount Road, Aviation Business Park Bournemouth International Airport, Hurn Christchurch BH23 6BU England à 11th Floor Landmark St Peters Square 1 Oxford Street Manchester M1 4PB le 27 juin 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    4 pagesAM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    32 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Neil Taggart en tant qu'administrateur le 17 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Wayne Ball en tant que directeur le 09 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    32 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Qinghong Liu en tant qu'administrateur le 01 mai 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Jing Guo en tant qu'administrateur le 01 mai 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Li Fan en tant qu'administrateur le 01 mai 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Mark Bower en tant que directeur le 30 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Colin Philip Thornton en tant que directeur le 31 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    29 pagesAA

    Notification de Aim Altitude Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 avr. 2019

    2 pagesPSC02

    Qui sont les dirigeants de AUK REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FAN, Li
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Administrateur
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    United KingdomChineseCompany Director269686080001
    GUO, Jing
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Administrateur
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    ChinaChineseCompany Director268310700001
    LIU, Qinghong
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Administrateur
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    EnglandChineseCompany Director269686440001
    STODDART, Mark
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Administrateur
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    EnglandBritishFinance Director220064290001
    TAGGART, Neil
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Administrateur
    St Peters Square
    1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    11th Floor Landmark
    Northern IrelandBritishCompany Director279892730001
    EDWARDS, Mark
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    Secrétaire
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    153178340001
    FENN, Nicholas Patrick
    37 School Road
    West Wellow
    SO51 6AR Romsey
    Hampshire
    Secrétaire
    37 School Road
    West Wellow
    SO51 6AR Romsey
    Hampshire
    British10281800001
    GREEN, Robert Anthony
    Yew Tree Cottage South Lane
    Nomansland
    SP5 2BZ Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Yew Tree Cottage South Lane
    Nomansland
    SP5 2BZ Salisbury
    Wiltshire
    BritishFinance Director10281810001
    GREEN, Robert Anthony
    Yew Tree Cottage South Lane
    Nomansland
    SP5 2BZ Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Yew Tree Cottage South Lane
    Nomansland
    SP5 2BZ Salisbury
    Wiltshire
    British10281810001
    WINSHIP, Simon Mark
    126 River Way
    BH23 2QU Christchurch
    Secrétaire
    126 River Way
    BH23 2QU Christchurch
    British63193290003
    BALL, Wayne
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Administrateur
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    EnglandBritishOperations Director185821680001
    BOWER, Richard Mark
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Administrateur
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    EnglandBritishDirector185795210001
    EDWARDS, Mark John
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Administrateur
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    United KingdomBritishDirector56562210001
    FORBES, Peter Patrick Spencer
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritishCompany Director16260380002
    HEATH, Robert John
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritishEngineer74802290002
    LEITCH, Andrew Jack
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Administrateur
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    United KingdomBritishFinance Director154333950001
    LEVY, Max
    12 Landers Reach
    Lychett Matravers
    BH16 6NB Poole
    Dorset
    Administrateur
    12 Landers Reach
    Lychett Matravers
    BH16 6NB Poole
    Dorset
    EnglandBritishOperations Director110629560001
    LOCK, David
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    Jecco House
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritishFinancial Controller185795330001
    MACDONALD-HALL, Caspar
    School Farm
    Lockerley
    SO51 0JH Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    School Farm
    Lockerley
    SO51 0JH Romsey
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director10281830001
    MANN, Michael Alan
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Administrateur
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    United KingdomBritishFinancial Controller188031590001
    MCDONALD, Shaun Owen
    152 Stony Lane
    Burton
    BH23 7LD Christchurch
    Dorset
    Administrateur
    152 Stony Lane
    Burton
    BH23 7LD Christchurch
    Dorset
    BritishCompany Director30598230001
    READE, Bryan
    27 Moneyfly Road
    BH31 6BL Verwood
    Dorset
    Administrateur
    27 Moneyfly Road
    BH31 6BL Verwood
    Dorset
    BritishCompany Director30598250001
    ROBERTS, Anthony
    8 Robert Louis Stevenson Avenue
    Westbourne
    Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    8 Robert Louis Stevenson Avenue
    Westbourne
    Bournemouth
    Dorset
    BritishCompany Director41765280001
    SMITH, Jeffrey Colin
    Merdon Manor
    Hursley
    SO21 2JJ Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Merdon Manor
    Hursley
    SO21 2JJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director10281820001
    TAPPENDEN, Michael John
    49 Oakhurst Road
    West Moors
    BH22 0DP Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    49 Oakhurst Road
    West Moors
    BH22 0DP Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritishDirector64363900001
    THORNTON, Colin Philip
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Administrateur
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    EnglandBritishAircraft Interiors89175510001
    WARD, David
    27 Bartons Road
    SP6 1JD Fordingbridge
    Hampshire
    Administrateur
    27 Bartons Road
    SP6 1JD Fordingbridge
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director30598240002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AUK REALISATIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Aim Altitude Limited
    Aviation Business Park
    Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1 Viscount Road
    England
    19 avr. 2019
    Aviation Business Park
    Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1 Viscount Road
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House (England & Wales)
    Numéro d'enregistrement9804626
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Aim Altitude Limited
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    30 nov. 2016
    Viscount Road, Aviation Business Park
    Bournemouth International Airport, Hurn
    BH23 6BU Christchurch
    1
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk Companies House
    Numéro d'enregistrement9804626
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Jecco House
    England
    06 avr. 2016
    Boscombe Grove Road
    BH1 4PD Bournemouth
    Jecco House
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk Companies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement7275471
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    AUK REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 nov. 2016
    Livré le 25 nov. 2016
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 05 mai 2016
    Livré le 10 mai 2016
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 mai 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 oct. 2013
    Livré le 09 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    19 and 21 boscombe road, bournemouth t/no DT139474; land and buildings on the south side of boscombe grove road, bournemouth t/no DT94622; 188, 190, 194 spring road, bournemouth t/no DT134760.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 09 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 oct. 2013
    Livré le 08 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 19 déc. 2012
    Livré le 21 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 2010
    Livré le 30 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    19 and 21 boscombe grove road, bournemouth t/no DT139474. Land and buildings on the south side of boscombe grove road, bournemouth t/no DT94622 and 188, 190, 192 and 194 spring road, bournemouth t/no DT134760 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transactions
    • 30 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 juin 2010
    Livré le 30 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transactions
    • 30 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 19 mars 2008
    Livré le 03 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    188 190 192 and 194 spring road bournemouth t/n DT134760 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 19 mars 2008
    Livré le 03 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings on the north side of boscombe grove road bournemouth t/n DT94622 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 19 mars 2008
    Livré le 03 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    19 & 21 boscombe grove road bournemouth t/n DT139474 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 05 oct. 2004
    Livré le 15 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    £3,187.50 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit account in the sum of £3,187.50 as per the terms of the rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Bournemouth International Airport Limited
    Transactions
    • 15 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 11 avr. 1983
    Livré le 18 avr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over the company's f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof including fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts, go odwill and uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 10 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    AUK REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 juin 2022Administration started
    19 juin 2023Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Helen Dale
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    practitioner
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Jonathan Roden
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    practitioner
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Andrew Charters
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    2
    DateType
    19 juin 2023Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Helen Dale
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    practitioner
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Jonathan Roden
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    practitioner
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Andrew Charters
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0