HEATH INSURANCE BROKING LIMITED

HEATH INSURANCE BROKING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHEATH INSURANCE BROKING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01005219
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HEATH INSURANCE BROKING LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe HEATH INSURANCE BROKING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Walbrook Building
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HEATH INSURANCE BROKING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    C E HEATH (INSURANCE BROKING) LIMITED25 avr. 198825 avr. 1988
    C.E. HEATH & CO. (INSURANCE BROKING) LIMITED18 mars 197118 mars 1971

    Quels sont les derniers comptes de HEATH INSURANCE BROKING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour HEATH INSURANCE BROKING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Alistair Charles Peel en tant que secrétaire le 09 août 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de William Lindsay Mcgowan en tant que secrétaire le 09 août 2018

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 févr. 2016

    État du capital au 02 févr. 2016

    • Capital: GBP 55
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    11 pagesAA

    Nomination de Mr Matthew Pike en tant qu'administrateur le 09 févr. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Christopher Ross en tant que directeur le 09 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 févr. 2015

    État du capital au 05 févr. 2015

    • Capital: GBP 55
    SH01

    Cessation de la nomination de Mark Stephen Mugge en tant que directeur le 26 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 févr. 2014

    État du capital au 03 févr. 2014

    • Capital: GBP 55
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    11 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 9 Alie Street London E1 8DE* le 19 août 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr William Lindsay Mcgowan en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Hl Corporate Services Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Christopher Ross le 11 oct. 2012

    3 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HEATH INSURANCE BROKING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEEL, Alistair Charles
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Secrétaire
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    249410010001
    PIKE, Matthew William
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Administrateur
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    EnglandBritishCompany Director187274510001
    MCGOWAN, William Lindsay
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Secrétaire
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    180337270001
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    British33862660001
    SHARP, Pandora
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    Secrétaire
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    British64972020003
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    HL CORPORATE SERVICES LIMITED
    Houndsditch
    EC3A 7AH London
    133
    United Kingdom
    Secrétaire
    Houndsditch
    EC3A 7AH London
    133
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1054707
    43700080007
    BARTON, Michael Keith
    Alie Street
    E1 8DE London
    9
    Administrateur
    Alie Street
    E1 8DE London
    9
    EnglandUnited StatesDirector109126210001
    BLOOMER, William David
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    Administrateur
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    United KingdomBritishCompany Solicitor72374560002
    BROADHURST, Timothy Edward
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishInsurance Broker8657480001
    BRUCE, Michael Andrew
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishGroup Managing Director61928170002
    BURTON, Michael John
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    Administrateur
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    BritishDirector63922600001
    COLOSSO, Adrian
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    Administrateur
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    EnglandBritishGroup Chief Executive4555310002
    DEXTER, Neil Edward
    1 Courtlands
    Prince Imperial Road
    BR7 5LX Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    1 Courtlands
    Prince Imperial Road
    BR7 5LX Chislehurst
    Kent
    EnglandBritishCompany Director42053970001
    ELDRET, Kenneth George
    Broadmead
    3 Franklands Gardens
    RH15 0UJ Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    Broadmead
    3 Franklands Gardens
    RH15 0UJ Burgess Hill
    West Sussex
    BritishInsurance Broker34990880001
    FIELDING, Richard Walter
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    Administrateur
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    United KingdomBritishCompany Director77656210001
    HARRISON, Robert Melville
    Flint Cottage 53 Ridgway Road
    GU9 8NR Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Flint Cottage 53 Ridgway Road
    GU9 8NR Farnham
    Surrey
    BritishCompany Director8722560001
    HORNER, Frank Henry Leslie
    Pettits House Mountnessing Lane
    Doddinghurst
    CM15 0SP Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Pettits House Mountnessing Lane
    Doddinghurst
    CM15 0SP Brentwood
    Essex
    BritishCompany Director28353000001
    HUGHES, Michael Harold
    881 Ocean Drive
    Appartment 16 F
    USA Key Biscayne
    Florida
    Administrateur
    881 Ocean Drive
    Appartment 16 F
    USA Key Biscayne
    Florida
    BritishLloyds Broker65226980002
    HUGHES, Paul John
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    Administrateur
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritishCompany Director5389800001
    KAUFMAN, John Banwell
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    Administrateur
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    EnglandBritishInsurance Broker147388510001
    KIER, Michael Hector
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    DanishLloyds Broker8719670001
    LETBY, Roger David
    19 Alverton Close
    Great Notley
    CM7 8XU Braintree
    Essex
    Administrateur
    19 Alverton Close
    Great Notley
    CM7 8XU Braintree
    Essex
    BritishInsurance Broker28585270003
    MACKAY, Ian Hamish Noel
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    Administrateur
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    BritishChartered Accountant104334150001
    MACKENZIE GREEN, John Garvie
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    Administrateur
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    BritishLloyds Broker34988570004
    MACKENZIE GREEN, John Garvie
    Cheesedown Farm
    Steventon
    RG25 3AY Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Cheesedown Farm
    Steventon
    RG25 3AY Basingstoke
    Hampshire
    BritishCompany Director34988570001
    MCCARTHY, Paul Frank
    Tor House Station Road
    Woldingham
    CR3 7DA Caterham
    Surrey
    Administrateur
    Tor House Station Road
    Woldingham
    CR3 7DA Caterham
    Surrey
    BritishCompany Director65173730001
    MONEY, Anthony John
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritishCompany Director8785440001
    MUGGE, Mark Stephen
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Administrateur
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    EnglandAmericanDirector162920630001
    NEWBERY, Trevor Philip
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    Administrateur
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    BritishInsurance Broker66912140001
    NEWBERY, Trevor Philip
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    Administrateur
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    BritishCompany Director66912140001
    NICHOLS, David William
    Fairacre Ravensdale Road
    South Ascot
    SL5 9HJ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Fairacre Ravensdale Road
    South Ascot
    SL5 9HJ Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director6384890001
    PRESLAND, Peter Eric
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    Administrateur
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    EnglandBritishCompany Director7649630002
    PROCTOR, Jonathan Paul
    6 Herondale Avenue
    Wandsworth Common
    SW18 3JL London
    Administrateur
    6 Herondale Avenue
    Wandsworth Common
    SW18 3JL London
    BritishInsurance Broker8638320001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HEATH INSURANCE BROKING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Friary Intermediate Limited
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    06 avr. 2016
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement4404202
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HEATH INSURANCE BROKING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 29 févr. 2000
    Livré le 09 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 1 september 1989 ("the principal deed") as modified by a deed of variation dated 1 november 1993 (the "first deed of variation"),
    Créé le 23 sept. 1999
    Livré le 01 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a charge
    Brèves mentions
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's
    Transactions
    • 01 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third guarantee and debenture
    Créé le 31 déc. 1997
    Livré le 14 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 14 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second guarantee and debenture
    Créé le 03 déc. 1997
    Livré le 22 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 22 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of variation
    Créé le 01 nov. 1993
    Livré le 10 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security and trust deed dated 01/09/89
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of an insurance broking account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 10 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit agreement
    Créé le 07 nov. 1991
    Livré le 12 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deposit agreement
    Brèves mentions
    The balances for the time being standing to the credit of any accounts with the bank see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 12 nov. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 01 sept. 1989
    Livré le 14 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    See schedule attached to form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's as Trustee
    Transactions
    • 14 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 13 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit charge
    Créé le 08 nov. 1988
    Livré le 23 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title & interest of the company in & all sums from time to time standing to the credit of each l/c deposit account in the name of the company opened with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 01 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge document
    Créé le 16 avr. 1986
    Livré le 25 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    A) all sums of money which may now or hereafter be held by or for the account of the bank in the name or the company at the main office of the bank in london together with all interest accruing from time to time thereon. B) all shares stocks, bonds debentures certificates of deposit or other securities (see doc M21 for details).
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank N.A.
    Transactions
    • 25 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 11 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 21 févr. 1983
    Livré le 23 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account and monies and investments standing to the credit in other iba accounts of the company. (See doc M.20).
    Personnes ayant droit
    • The Corporation of Lloyd's
    Transactions
    • 23 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 09 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0