W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED

W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéW. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01006944
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED ?

    • Élevage de volailles (01470) / Agriculture, sylviculture et pêche

    Où se situe W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Wooden Barn
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2020
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2021
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au24 nov. 2020
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation05 janv. 2021
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au24 nov. 2019
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 déc. 2024

    18 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O K & W Recovery Limited Milton Park Innovation Centre 99 Park Drive Milton Abingdon OX14 4RY à The Wooden Barn Little Baldon Oxford OX44 9PU le 12 juin 2024

    3 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 déc. 2023

    19 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 déc. 2022

    19 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 déc. 2021

    19 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Critchleys Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP à C/O K & W Recovery Limited Milton Park Innovation Centre 99 Park Drive Milton Abingdon OX14 4RY le 15 juin 2021

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Begbies Traynor 1st Floor Gateway House Grove Business Park Enderby Leicester LE19 1SY à C/O Critchleys Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP le 14 déc. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    36 pagesAM22

    Satisfaction de la charge 010069440023 en totalité

    1 pagesMR04

    Résultat de la réunion des créanciers

    77 pagesAM07

    Changement d'adresse du siège social de Leigh Road Swift Valley Industrial Estate Rugby Warwickshire CV21 1DS à C/O Begbies Traynor 1st Floor Gateway House Grove Business Park Enderby Leicester LE19 1SY le 03 août 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    12 pagesAM02

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    75 pagesAM03

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Inscription de la charge 010069440023, créée le 04 juin 2020

    25 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 18 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Jamie William Pittman en tant que directeur le 14 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2019

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 nov. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Inscription de la charge 010069440022, créée le 08 nov. 2019

    32 pagesMR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Celia Parker le 26 juin 2019

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARKER, Celia
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    The Wooden Barn
    Secrétaire
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    The Wooden Barn
    British93947030001
    POTTER, Justin Matthew
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    The Wooden Barn
    Administrateur
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    The Wooden Barn
    United KingdomBritish66387220004
    POTTER, Olivia Jane
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    The Wooden Barn
    Administrateur
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    The Wooden Barn
    United KingdomBritish70392370004
    BAILEY, Trevor Arthur
    69 Whitestone Road
    CV11 4SY Nuneaton
    Warwickshire
    Secrétaire
    69 Whitestone Road
    CV11 4SY Nuneaton
    Warwickshire
    British2292140001
    MANSELL, Godfrey
    Yew Tree Cottage
    Torton Lane Torton
    DY10 4HX Kidderminster
    Worcestershire
    Secrétaire
    Yew Tree Cottage
    Torton Lane Torton
    DY10 4HX Kidderminster
    Worcestershire
    British43241470001
    NEILSON, John Michael
    Old Berry Hall Farm Ravenshaw Lane
    B91 2TB Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    Old Berry Hall Farm Ravenshaw Lane
    B91 2TB Solihull
    West Midlands
    British25254460001
    BAILEY, Trevor Arthur
    69 Whitestone Road
    CV11 4SY Nuneaton
    Warwickshire
    Administrateur
    69 Whitestone Road
    CV11 4SY Nuneaton
    Warwickshire
    British2292140001
    MANSELL, Godfrey
    Yew Tree Cottage
    Torton Lane Torton
    DY10 4HX Kidderminster
    Worcestershire
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Torton Lane Torton
    DY10 4HX Kidderminster
    Worcestershire
    British43241470001
    MCANDREW, Paul
    1 Coleshil Road
    Shustoke
    B46 2AQ Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    1 Coleshil Road
    Shustoke
    B46 2AQ Birmingham
    West Midlands
    British120679360001
    PITTMAN, Jamie William
    Swift Valley Industrial Estate
    CV21 1DS Rugby
    Leigh Road
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Swift Valley Industrial Estate
    CV21 1DS Rugby
    Leigh Road
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish157961540001
    POTTER, Ronald William
    Fillongley Lodge Cottage
    Fillongley
    CV7 8EA Coventry
    Administrateur
    Fillongley Lodge Cottage
    Fillongley
    CV7 8EA Coventry
    British2292150001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    W Potter & Sons (Holdings) Limited
    Swift Valley Industrial Estate
    CV21 1DS Rugby
    Leigh Road
    Warwickshire
    England
    01 nov. 2018
    Swift Valley Industrial Estate
    CV21 1DS Rugby
    Leigh Road
    Warwickshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement00931475
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Mr Justin Matthew Potter
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    The Wooden Barn
    06 avr. 2016
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    The Wooden Barn
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mrs Olivia Jane Stacey
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    The Wooden Barn
    06 avr. 2016
    Little Baldon
    OX44 9PU Oxford
    The Wooden Barn
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2020
    Livré le 05 juin 2020
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services Limited
    Transactions
    • 05 juin 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 27 oct. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 08 nov. 2019
    Livré le 13 nov. 2019
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 01 juin 2015
    Livré le 02 juin 2015
    En cours
    Brève description
    Freehold property at bodway poultry farm grove retford nottingham title no NT298485 and NT311097.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 sept. 2013
    Livré le 04 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Legal mortgage
    Créé le 29 sept. 2005
    Livré le 01 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from kepp limited and the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H - green end farm green end fillongley coventry. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 07 nov. 2000
    Livré le 14 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjoining willey fields willey and wibtoft rugby warwickshire WK240167.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 07 nov. 2000
    Livré le 14 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Willey fields farm, willey and wibtoft rugby warwickshire t/no: WK240166.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 26 juin 2000
    Livré le 13 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land o the south west side of watling street willey rugby warwickshire t/no;-WK239467.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 23 oct. 1995
    Livré le 31 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property- land on north side of oldwich lane chadwick end solihull west midlands and the proceeds of sale thereof; t/no wm 548655. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 04 août 1994
    Livré le 09 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a "fillongley lodge" fillongley warwickshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 août 1994
    Livré le 09 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 déc. 1992
    Livré le 11 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Please see doc M343C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 1992
    Livré le 16 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £55000
    Brèves mentions
    Rosemary cottage farm oldwich lane chadwick end silihull W. midlands.
    Personnes ayant droit
    • R. W. Potter & T.A.Bailey Trustees of the W. Potter & Sons ( Poultry)Limited Number 1 Executive Retirement Benefitscheme
    Transactions
    • 16 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 sept. 1989
    Livré le 29 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from C.ee.S. Potters limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H property situate on the west and east sides of station road, arley and formerly forming part of arley lane farm, staation road, arley, warwickshire, title no wk 277769.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 29 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 juin 1986
    Livré le 13 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H: property situate on west side and east side of station road, orley farming part of arley lane farm station road, arley together with all fixtures. (Please see doc M31).
    Personnes ayant droit
    • Farming and Agricultural Finance Limited
    Transactions
    • 13 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 10 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 oct. 1984
    Livré le 26 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the south west side of watling street, willey parish, warwickshire &leicestershire title no wk 239467.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 1983
    Livré le 18 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H willey fields farm, willey willey and wibtoft parish warwickshire title no:-wk 240166.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 1983
    Livré le 18 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land adjoining willey fields farm, willey, willey and wibtoft parish, warwickshire title no:- wk 240167.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 06 avr. 1983
    Livré le 14 avr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H close of land situate adjoining fellongley lodge" fillongley, warickwhire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 06 avr. 1983
    Livré le 14 avr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land adjoining the gatehouse, fillonley lodge, fillongley, warwickshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 06 avr. 1983
    Livré le 14 avr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 'fillangley lodge' fillangley, warwickshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 04 oct. 1977
    Livré le 11 oct. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold lands adjoining willey fields farm willeyand wibtoft parish with off fixtures whatsoever title no. Wk 2J0167.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 1977Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 14 juin 1977
    Livré le 20 juin 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold lands hereditaments and premises being willey fields farm willey and wibtoft parish together with all fixtures.(see doc M22).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 1977Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    W. POTTER & SONS (POULTRY) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 juin 2020Administration started
    03 déc. 2020Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Martin Richard Buttriss
    1st Floor Gateway House Grove Business Park
    Enderby
    LE19 1SY Leicester
    practitioner
    1st Floor Gateway House Grove Business Park
    Enderby
    LE19 1SY Leicester
    Carolynn Jean Best
    1st Floor Gateway House Grove Business Park
    Enderby
    LE19 1SY Leicester
    Leicestershire
    practitioner
    1st Floor Gateway House Grove Business Park
    Enderby
    LE19 1SY Leicester
    Leicestershire
    2
    DateType
    03 déc. 2020Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lawrence John King
    Beaver House, 23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire
    practitioner
    Beaver House, 23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0