SHOWBOAT HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSHOWBOAT HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01011088
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SHOWBOAT HOLDINGS LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe SHOWBOAT HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SHOWBOAT HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SHOWBOAT HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 févr. 2012

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 17 févr. 2012

    • Capital: GBP 0.50
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Statuts

    10 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Rank Nemo (Twenty-Six) Limited le 05 sept. 2011

    1 pagesCH04

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Frances Bingham le 01 mars 2010

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de SHOWBOAT HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THE RANK ORGANISATION LIMITED
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    116576210002
    BINGHAM, Frances
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishSolicitor128838610001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    British 42996540002
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Secrétaire
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    British26244410001
    DUFFILL, Clare Marianne
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    Secrétaire
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    BritishCompany Secretariat Assistant71005690005
    PATEL, Aurelia Azalea
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    Secrétaire
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    BritishCompany Secretariat Assistant108784710001
    WATKINS, Simon Andrew
    6 Errington Close
    Chadwell St Mary
    RM16 4TA Grays
    Essex
    Secrétaire
    6 Errington Close
    Chadwell St Mary
    RM16 4TA Grays
    Essex
    British34048840001
    COLES, Pamela Mary
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary70326980002
    CORMICK, Charles Bruce Arthur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    Administrateur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    United KingdomBritishCompany Secretary17946190001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    British 42996540002
    DUFFILL, Clare Marianne
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    Administrateur
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    BritishCompany Secretariat Assistant71005690005
    OWERS, Brian Charles
    19 Wilmot Way
    GU15 1JA Camberley
    Surrey
    Administrateur
    19 Wilmot Way
    GU15 1JA Camberley
    Surrey
    EnglandBritishDirector34009090001
    PATEL, Aurelia Azalea
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    Administrateur
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    BritishCompany Secretariat Assistant108784710001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant34191470001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Administrateur
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    BritishChartered Secretary34048840002

    SHOWBOAT HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 21 oct. 1986
    Livré le 23 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    118, high street scunthorpe, humberside.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 09 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 21 oct. 1986
    Livré le 23 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    157, high street, scunthorpe, humberside.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 09 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Omnibus letter of set off
    Créé le 21 oct. 1986
    Livré le 10 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1986Enregistrement d'une charge
    • 09 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 28 juin 1984
    Livré le 29 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Properties as described in doc M42.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1984Enregistrement d'une charge
    • 09 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Letter of set off
    Créé le 30 janv. 1984
    Livré le 02 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    All sums standing to the credit of any account of the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 02 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 31 oct. 1983
    Livré le 01 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5, 7 and 9, the burges, coventry and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 23 mars 1983
    Livré le 25 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land in silver street whitwich, leicestershire. &/Or the proceed of sale thereof part of title no lt 77890. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 mars 1983Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 23 mars 1983
    Livré le 25 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold nos 10 & 12 high street, coalville, leicesteshire &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 mars 1983Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 14 mars 1983
    Livré le 16 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17A and 17B market place. Loughborough, charnwood leicestershire title no. LT133004 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 1983Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 08 nov. 1982
    Livré le 09 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 brook square, rugeley, cannock chase, staffs &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 21 sept. 1981
    Livré le 29 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    63 high street, poole, dorset title no:- dt 38558.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 08 sept. 1981
    Livré le 21 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    213 & 215 high street, scunthorpe, humberside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 08 juin 1981
    Livré le 23 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    121, high street, bedford. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 juin 1981Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 08 juin 1981
    Livré le 23 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1, northgate, halifax.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 juin 1981Enregistrement d'une charge

    SHOWBOAT HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2013Dissolved on
    24 févr. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Gerard Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0