PFI STREET LIGHTING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PFI STREET LIGHTING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01011586 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PFI STREET LIGHTING LIMITED ?
Adresse du siège social | Tempsford Hall Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire Great Britain |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PFI STREET LIGHTING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour PFI STREET LIGHTING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 15 mai 2017
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 1 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Bethan Melges le 08 déc. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anoop Kang en tant que directeur le 22 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Lee Foreman en tant qu'administrateur le 22 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy Francis Wray en tant que directeur le 12 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Anoop Kang en tant qu'administrateur le 12 oct. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Bethan Melges en tant qu'administrateur le 12 oct. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Giles Stewart Pearson en tant que directeur le 26 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 1 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Export House Cawsey Way Woking Surrey GU21 6QX à Tempsford Hall Tempsford Hall Sandy Bedfordshire SG19 2BD le 16 oct. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Adrian Rayner en tant que directeur le 08 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013 | 1 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicky Cobden en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul England en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PFI STREET LIGHTING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOREMAN, Thomas Lee | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | Director | 221070030001 | ||||
MELGES, Bethan Anne Elizabeth | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | Company Secretary | 199583330002 | ||||
COBDEN, Nicky | Secrétaire | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | 169439630001 | |||||||
ENGMANN, Catherine | Secrétaire | 11 Tudor Way SL4 5LT Windsor Berkshire | British | 92722710004 | ||||||
HAMES, Victoria Elizabeth | Secrétaire | Flat 5 70 Elmbourne Road SW17 8JJ London | British | 102613150001 | ||||||
LEE, Kelly | Secrétaire | Friars Stile Place TW10 6NL Richmond 6 Surrey United Kingdom | British | Deputy Company Secretary | 138708240001 | |||||
MASSIE, Amanda Jane Emilia | Secrétaire | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | British | 36957420004 | ||||||
PREECE, Richard Alec | Secrétaire | 3 Moorings Close Parkgate CH64 6TL South Wirral | British | 7353920001 | ||||||
SHAW, Christine Ann | Secrétaire | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | 161060620001 | |||||||
SJOGREN, Carl | Secrétaire | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | 153648990001 | |||||||
BOND, Eric | Administrateur | Henfold 120 Henfold Road Astley M29 7EX Manchester Lancashire | British | Chartered Engineer | 11646690001 | |||||
DAVIES, John Charles | Administrateur | Cambridge House 78 Melbourn Road SG8 7DG Royston Hertfordshire | British | Director | 78509070001 | |||||
ENGLAND, Paul David | Administrateur | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | England | British | Director | 153205540001 | ||||
HANDLEY, John | Administrateur | Brook Cottage Brinsea Batch, Congresbury BS49 5JP Bristol | British | Chartered Engineer | 97439420001 | |||||
HARRIS, Rodney Hewer | Administrateur | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 104017460001 | ||||
HOWITT, Ian Howard | Administrateur | The Spinney Mill Lane Rainhill L35 6NG Prescot Merseyside | England | British | C Accountant | 43712120001 | ||||
KANG, Anoop | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | Director | 198683900001 | ||||
KEMP, William Ronald | Administrateur | 70 Chartwell Avenue Wingerworth S42 6SP Chesterfield Derbyshire | England | British | Consulting Civil Eng. | 43585680001 | ||||
KILNER, Robert Graham | Administrateur | 11 The Limes Culcheth WA3 4HE Warrington Cheshire | British | Chartered Engineer | 11487410002 | |||||
MASSIE, Amanda Jane Emilia | Administrateur | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | United Kingdom | British | Company Secretary | 36957420004 | ||||
NOTT, Nigel Alfred | Administrateur | 19 Shoscombe BA2 8LS Bath | England | British | Chartered Engineer | 11646680001 | ||||
PEARSON, Giles Stewart | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 180473890001 | ||||
PREECE, Richard Alec | Administrateur | 20 Mereworth Caldy CH48 1QT Wirral | British | Chartered Engineer | 7353920002 | |||||
RAYNER, Paul Adrian | Administrateur | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 45628680002 | ||||
STRANDERS, Robert | Administrateur | 26 Highfields CM6 1ED Great Dunmow Essex | British | Director | 77625600001 | |||||
TILSTON, David Frank | Administrateur | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 157476100001 | ||||
WALLER, Derek | Administrateur | 7 Borrell Close EN10 7RD Broxbourne Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 11525040003 | ||||
WRAY, Jeremy Francis | Administrateur | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | Chartered Engineer | 76133960001 | ||||
YOUNG, Kevin Andrew | Administrateur | 35 Dean Close GU22 8NX Pyrford Surrey | England | British | Chartered Accountant | 102706960001 |
PFI STREET LIGHTING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Further guarantee and debenture | Créé le 14 août 1981 Livré le 25 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 12 août 1980 Livré le 18 août 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from parkman holdings limited to the charge | |
Brèves mentions See doc M32. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Further guarantee & debenture | Créé le 09 mai 1979 Livré le 21 mai 1979 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts, uncalled capital. Together with all buildings & fixtures & fixed plant & machinery. (See doc 31). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0