FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE)
Vue d'ensemble
| Nom de la société | FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01018579 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) ?
| Adresse du siège social | Swinton Meadows Industrial Estate Meadow Way Swinton S64 8AB Rotherham South Yorkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 27 sept. 2013
| 4 pages | SH01 | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
État du capital au 08 oct. 2013
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Nomination de Mr David William Boyes en tant qu'administrateur le 01 août 2013 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Baker en tant que directeur le 30 avr. 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 26 déc. 2011 au 31 déc. 2011 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Pitmans the Anchorage 34 Bridge St Reading Berks RG1 2LU United Kingdom | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||||||
Nomination de Pitsec Limited en tant que secrétaire | 2 pages | AP04 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Halliwells Secretaries Limited en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2010 | 15 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITSEC LIMITED | Secrétaire | Castle St RG1 7SR Reading 47 Berks United Kingdom |
| 38734010001 | ||||||||||
| BOYES, David William | Administrateur | Meadow Way Swinton S64 8AB Rotherham Swinton Meadows Industrial Estate South Yorkshire | England | British | 180413110001 | |||||||||
| IRWIN, Clifford Edward | Administrateur | South Haining Brockenhurst Road SL5 9HB Ascot Berkshire | England | British | 80267740001 | |||||||||
| LAN, Richard | Administrateur | 80 Westminster Road 17928 Chatham New Jersey | Usa | American | 86052300001 | |||||||||
| BELLEINI, Brian John | Secrétaire | 3 Bramley Way Whittington WS14 9SB Lichfield Staffordshire | British | 6230250003 | ||||||||||
| GARAVAN, Charles | Secrétaire | Curragrean IRISH Galway Ireland | Irish | 52207090001 | ||||||||||
| POCQ ST JEAN, Felicity Caroline | Secrétaire | Woodford House 44 Fairmile Lane KT11 Cobham Surrey | British | 12673540001 | ||||||||||
| HBJGW MANCHESTER SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 3 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester | 113594300007 | |||||||||||
| BAKER, Peter | Administrateur | 12 Tallow Road TW8 8EU Brentford Middlesex | United Kingdom | British | 112123100001 | |||||||||
| BELLEINI, Brian John | Administrateur | 3 Bramley Way Whittington WS14 9SB Lichfield Staffordshire | British | 6230250003 | ||||||||||
| BRIDSON, John | Administrateur | 18a Bridge Park Ivypark PL21 0AT Plymouth Devon | British | 47307550005 | ||||||||||
| CLARK, Matthew | Administrateur | 4 Adcroft Piece Stapleford CB2 5FD Cambridge | British | 62828780002 | ||||||||||
| CLARKE, Paul Lee | Administrateur | The Willows Went Edge Road Kirk Smeaton WF8 3JS Pontefract West Yorkshire | England | British | 114683580001 | |||||||||
| COWLING, Colin Richard, Director | Administrateur | 18 The Glade Escrick YO19 6JH York | United Kingdom | British | 96639130001 | |||||||||
| GARAVAN, Charles | Administrateur | Curragrean IRISH Galway Ireland | Ireland | Irish | 52207090001 | |||||||||
| HORSMAN, Nigel Anthony | Administrateur | 24 Fosbrook Drive Castle Donington DE74 2UW Derby Derbyshire | British | 38626840001 | ||||||||||
| JONES, David Eurfyl | Administrateur | Greenacres 7 Keepers Lane Codsall WV8 2DP Wolverhampton West Midlands | British | 10978940002 | ||||||||||
| LISTER, John Richard Arkwright | Administrateur | Shipton Mill Long Newnton GL8 8RP Tetbury Gloucestershire | England | British | 18046460001 | |||||||||
| MAYCOCK, Peter Granville | Administrateur | 95 Thorpe Road PE3 6JQ Peterborough Cambridgeshire | United Kingdom | British | 53723130003 | |||||||||
| POCQ ST JEAN, Felicity Caroline | Administrateur | Woodford House 44 Fairmile Lane KT11 Cobham Surrey | British | 12673540001 | ||||||||||
| POCQ ST JEAN, Serge Jacques Jean | Administrateur | Woodford House 44 Fairmile Lane KT11 Cobham Surrey | French | 12673550001 | ||||||||||
| PRICE, Jonathan | Administrateur | 14 The Crescent B92 0BP Hampton In Arden West Midlands | British | 111512800001 | ||||||||||
| PRICE, Martin Raymond | Administrateur | Basse Croft Henley Road Claverdon CV35 8PS Warwick Warwickshire | British | 10978960001 |
FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 04 juil. 2006 Livré le 12 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the book and other debts revenues and claims the proceeds of insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment | Créé le 28 juil. 2004 Livré le 13 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti £381,649.72 due from william price and sons limited to the chargee | |
Brèves mentions All right title and interest to repayment from the inland revenue of corporation tax paid in respect of a prebs scheme. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 31 mars 2004 Livré le 15 avr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the book debts of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattel mortgage | Créé le 11 mars 2004 Livré le 18 mars 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The mortgaged chattels, the benefit of any guarantee, warranty or to the obligation in relation to the mortgaged chattels.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 11 mars 2004 Livré le 18 mars 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Equipment mortgage | Créé le 04 août 1998 Livré le 05 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions For details of equipment charged please refer to form M395.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Créé le 31 juil. 1998 Livré le 05 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Single debenture | Créé le 31 août 1984 Livré le 10 sept. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 30 janv. 1984 Livré le 31 janv. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H property known as shop no 3, part of unit 2 by the road, willesden title no ngl 179550 together with all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery present & future upon the above premises. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Single debenture | Créé le 30 nov. 1982 Livré le 08 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts goodwill & uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0