FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE)

FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE)
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01018579
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) ?

    • Fabrication de pain; fabrication de pâtisseries fraîches et de gâteaux (10710) / Industries manufacturières

    Où se situe FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) ?

    Adresse du siège social
    Swinton Meadows Industrial Estate Meadow Way
    Swinton
    S64 8AB Rotherham
    South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital après une attribution d'actions au 27 sept. 2013

    • Capital: GBP 20,117,840
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Allot shares 27/09/2013
    RES13

    État du capital au 08 oct. 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mr David William Boyes en tant qu'administrateur le 01 août 2013

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Peter Baker en tant que directeur le 30 avr. 2013

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 26 déc. 2011 au 31 déc. 2011

    1 pagesAA01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Pitmans the Anchorage 34 Bridge St Reading Berks RG1 2LU United Kingdom

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Nomination de Pitsec Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Halliwells Secretaries Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2010

    15 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PITSEC LIMITED
    Castle St
    RG1 7SR Reading
    47
    Berks
    United Kingdom
    Secrétaire
    Castle St
    RG1 7SR Reading
    47
    Berks
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2451677
    38734010001
    BOYES, David William
    Meadow Way
    Swinton
    S64 8AB Rotherham
    Swinton Meadows Industrial Estate
    South Yorkshire
    Administrateur
    Meadow Way
    Swinton
    S64 8AB Rotherham
    Swinton Meadows Industrial Estate
    South Yorkshire
    EnglandBritish180413110001
    IRWIN, Clifford Edward
    South Haining
    Brockenhurst Road
    SL5 9HB Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    South Haining
    Brockenhurst Road
    SL5 9HB Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish80267740001
    LAN, Richard
    80 Westminster Road
    17928 Chatham
    New Jersey
    Administrateur
    80 Westminster Road
    17928 Chatham
    New Jersey
    UsaAmerican86052300001
    BELLEINI, Brian John
    3 Bramley Way
    Whittington
    WS14 9SB Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    3 Bramley Way
    Whittington
    WS14 9SB Lichfield
    Staffordshire
    British6230250003
    GARAVAN, Charles
    Curragrean
    IRISH Galway
    Ireland
    Secrétaire
    Curragrean
    IRISH Galway
    Ireland
    Irish52207090001
    POCQ ST JEAN, Felicity Caroline
    Woodford House
    44 Fairmile Lane
    KT11 Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    Woodford House
    44 Fairmile Lane
    KT11 Cobham
    Surrey
    British12673540001
    HBJGW MANCHESTER SECRETARIES LIMITED
    3 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Secrétaire
    3 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    113594300007
    BAKER, Peter
    12 Tallow Road
    TW8 8EU Brentford
    Middlesex
    Administrateur
    12 Tallow Road
    TW8 8EU Brentford
    Middlesex
    United KingdomBritish112123100001
    BELLEINI, Brian John
    3 Bramley Way
    Whittington
    WS14 9SB Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    3 Bramley Way
    Whittington
    WS14 9SB Lichfield
    Staffordshire
    British6230250003
    BRIDSON, John
    18a Bridge Park
    Ivypark
    PL21 0AT Plymouth
    Devon
    Administrateur
    18a Bridge Park
    Ivypark
    PL21 0AT Plymouth
    Devon
    British47307550005
    CLARK, Matthew
    4 Adcroft Piece
    Stapleford
    CB2 5FD Cambridge
    Administrateur
    4 Adcroft Piece
    Stapleford
    CB2 5FD Cambridge
    British62828780002
    CLARKE, Paul Lee
    The Willows
    Went Edge Road Kirk Smeaton
    WF8 3JS Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Willows
    Went Edge Road Kirk Smeaton
    WF8 3JS Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish114683580001
    COWLING, Colin Richard, Director
    18 The Glade
    Escrick
    YO19 6JH York
    Administrateur
    18 The Glade
    Escrick
    YO19 6JH York
    United KingdomBritish96639130001
    GARAVAN, Charles
    Curragrean
    IRISH Galway
    Ireland
    Administrateur
    Curragrean
    IRISH Galway
    Ireland
    IrelandIrish52207090001
    HORSMAN, Nigel Anthony
    24 Fosbrook Drive
    Castle Donington
    DE74 2UW Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    24 Fosbrook Drive
    Castle Donington
    DE74 2UW Derby
    Derbyshire
    British38626840001
    JONES, David Eurfyl
    Greenacres 7 Keepers Lane
    Codsall
    WV8 2DP Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    Greenacres 7 Keepers Lane
    Codsall
    WV8 2DP Wolverhampton
    West Midlands
    British10978940002
    LISTER, John Richard Arkwright
    Shipton Mill
    Long Newnton
    GL8 8RP Tetbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    Shipton Mill
    Long Newnton
    GL8 8RP Tetbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish18046460001
    MAYCOCK, Peter Granville
    95 Thorpe Road
    PE3 6JQ Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    95 Thorpe Road
    PE3 6JQ Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish53723130003
    POCQ ST JEAN, Felicity Caroline
    Woodford House
    44 Fairmile Lane
    KT11 Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Woodford House
    44 Fairmile Lane
    KT11 Cobham
    Surrey
    British12673540001
    POCQ ST JEAN, Serge Jacques Jean
    Woodford House
    44 Fairmile Lane
    KT11 Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Woodford House
    44 Fairmile Lane
    KT11 Cobham
    Surrey
    French12673550001
    PRICE, Jonathan
    14 The Crescent
    B92 0BP Hampton In Arden
    West Midlands
    Administrateur
    14 The Crescent
    B92 0BP Hampton In Arden
    West Midlands
    British111512800001
    PRICE, Martin Raymond
    Basse Croft
    Henley Road Claverdon
    CV35 8PS Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    Basse Croft
    Henley Road Claverdon
    CV35 8PS Warwick
    Warwickshire
    British10978960001

    FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 juil. 2006
    Livré le 12 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the book and other debts revenues and claims the proceeds of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC Trading as Allied Irish Bank (GB)
    Transactions
    • 12 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment
    Créé le 28 juil. 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £381,649.72 due from william price and sons limited to the chargee
    Brèves mentions
    All right title and interest to repayment from the inland revenue of corporation tax paid in respect of a prebs scheme. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Steven Charles Sugar,David Christopher Willis and Nicholas Kilmaine De Courcy-Ireland
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 2004
    Livré le 15 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the book debts of the company.
    Personnes ayant droit
    • Aib Commercial Services Limited
    Transactions
    • 15 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 11 mars 2004
    Livré le 18 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The mortgaged chattels, the benefit of any guarantee, warranty or to the obligation in relation to the mortgaged chattels.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 18 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 mars 2004
    Livré le 18 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equipment mortgage
    Créé le 04 août 1998
    Livré le 05 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    For details of equipment charged please refer to form M395.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 05 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 31 juil. 1998
    Livré le 05 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 31 août 1984
    Livré le 10 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 10 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 30 janv. 1984
    Livré le 31 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property known as shop no 3, part of unit 2 by the road, willesden title no ngl 179550 together with all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery present & future upon the above premises.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 31 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 05 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 30 nov. 1982
    Livré le 08 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts goodwill & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0