BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED

BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01021920
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?

    • Édition de journaux (58130) / Information et communication

    Où se situe BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY City Of London
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UNIQUE NEWSPAPERS LIMITED19 juil. 199619 juil. 1996
    EMAP UNIQUE NEWSPAPERS LIMITED20 juin 199420 juin 1994
    TOWN CRIER LIMITED16 avr. 198516 avr. 1985
    ADPOWER PROMOTIONS LIMITED23 août 197123 août 1971

    Quels sont les derniers comptes de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    10 pagesLIQ14

    Cessation de la nomination de David John King en tant que directeur le 31 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Michael Mccall en tant que secrétaire le 31 déc. 2019

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG à 6 Snow Hill City of London London EC1A 2AY le 08 avr. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration des affaires

    10 pagesLIQ02

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 18 mars 2019

    LRESEX

    Comptes pour une société dormante établis au 30 déc. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Ashley Gilroy Mark Highfield en tant que directeur le 05 juin 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 août 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 août 2015

    État du capital au 07 août 2015

    • Capital: GBP 1,089.01
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 11-13 Mill Street Bedford Bedfordshire MK40 3EU à Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG le 06 août 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 03 janv. 2015

    9 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2013

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David John King le 01 juil. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ashley Gilroy Mark Highfield le 01 juil. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Peter Michael Mccall le 01 juil. 2014

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 août 2014

    État du capital au 08 août 2014

    • Capital: GBP 1,089.01
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 déc. 2012

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 août 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 05 août 2013

    SH01

    Qui sont les dirigeants de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ABBOTT, Jane Dorothy
    Sawatdi
    East Road
    PE8 4BX Oundle
    Northhampshire
    Secrétaire
    Sawatdi
    East Road
    PE8 4BX Oundle
    Northhampshire
    British102874790001
    HARRIS, Christopher Ian
    6 Baker Court
    Thrapston
    NN14 4XA Kettering
    Northamptonshire
    Secrétaire
    6 Baker Court
    Thrapston
    NN14 4XA Kettering
    Northamptonshire
    British53420880002
    LISLE, Vincent Thomas
    5 Otters Holt
    Durkar
    WF4 3QE Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    5 Otters Holt
    Durkar
    WF4 3QE Wakefield
    West Yorkshire
    British88104040001
    MCCALL, Peter Michael
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Secrétaire
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    158805550001
    PATRICK, David John
    21 East Street
    NN1 5JZ Northampton
    Secrétaire
    21 East Street
    NN1 5JZ Northampton
    British119390850002
    STEELE, Toby Andrew Murray
    62 Dynevor Close
    Bromham
    MK43 8UD Bedford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    62 Dynevor Close
    Bromham
    MK43 8UD Bedford
    Bedfordshire
    British91907510001
    VALDERAZ, Anne
    37 Manor Lane
    Alconbury
    PE17 5EH Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    37 Manor Lane
    Alconbury
    PE17 5EH Huntingdon
    Cambridgeshire
    British48965240001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    Sennen
    Grange Road
    MK43 7EU Felmersham
    North Bedfordshire
    Secrétaire
    Sennen
    Grange Road
    MK43 7EU Felmersham
    North Bedfordshire
    British16754910001
    YEOMANS, Graham Arthur
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    British602760001
    ALLEN, Frederick John
    6 Glebe Close
    Horringer
    IP29 5PR Bury St Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    6 Glebe Close
    Horringer
    IP29 5PR Bury St Edmunds
    Suffolk
    British30121880001
    BAILLIE, John Andrew Main
    Yew Cottage
    Main Road, Uffington
    PE9 4SN Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    Yew Cottage
    Main Road, Uffington
    PE9 4SN Stamford
    Lincolnshire
    British76483990001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Administrateur
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritish37521870002
    CAMMIADE, Danny
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Administrateur
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    EnglandBritish251394160001
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Administrateur
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    ScotlandBritish474360001
    CLARK, Stephen Robert
    114 Hillesden Avenue
    Elstow
    MK42 9AJ Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    114 Hillesden Avenue
    Elstow
    MK42 9AJ Bedford
    Bedfordshire
    British60851690002
    ELLIS, Michael John
    40 King Street
    Somersham
    PE17 3EJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    40 King Street
    Somersham
    PE17 3EJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish178022450001
    EVANS, Michael Joseph
    The Manor House 59 Church Street
    Nassington
    PE8 6QG Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    The Manor House 59 Church Street
    Nassington
    PE8 6QG Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish30037370001
    FEETHAM, Robert Anthony
    4 The Charters
    Uffington
    PE9 4UD Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    4 The Charters
    Uffington
    PE9 4UD Stamford
    Lincolnshire
    EnglandBritish64401770001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Administrateur
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritish136914890001
    HARRIS, Christopher Ian
    31 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Administrateur
    31 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    British53420880003
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish164400440001
    JOHNSTON, Frederick Patrick Mair
    1 Grange Terrace
    EH9 2LD Edinburgh
    Administrateur
    1 Grange Terrace
    EH9 2LD Edinburgh
    British328390001
    JOHNSTON, Michael Frederick
    19 Webster Gardens
    W5 5NA London
    Administrateur
    19 Webster Gardens
    W5 5NA London
    British64615750001
    KING, David John
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish179020430001
    LANKESTER, David Robin Archibald
    11 Bath Row
    PE9 2QU Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    11 Bath Row
    PE9 2QU Stamford
    Lincolnshire
    British49804010002
    LAWLER, Thomas Philip
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    British7475760001
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Administrateur
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritish159877110001
    NIZOL, David Frederick
    18 Hallam Close
    CM15 0NW Brentwood
    Essex
    Administrateur
    18 Hallam Close
    CM15 0NW Brentwood
    Essex
    British109032760001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish64281400001
    RATCLIFFE, Neil Anthony
    Red Oaks Mill Road
    Lower Shiplake
    RG9 3LN Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Red Oaks Mill Road
    Lower Shiplake
    RG9 3LN Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish122955650001
    RICHARDSON, Michael Robert
    4 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    4 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    England-UkBritish74383790001
    TOULMIN, George Michael
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    British9253330001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Johnston Press Plc
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Orchard Brae House
    Scotland
    06 avr. 2016
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Orchard Brae House
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementScotland
    Numéro d'enregistrementSc015382
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 juil. 1996
    Livré le 19 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement, the other finance documents, the rbs facilities, the bridging facility and the rbs guarantee and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without limitation, all obligations to indemnify the chargee (the "secured obligations")
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC(For Itself and as Trustee for and on Behalf Ofthe Agent, the Banks and Rbs)
    Transactions
    • 19 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 avr. 1983
    Livré le 07 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Please see doc M22). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Dennis Roy Pegran
    Transactions
    • 07 mai 1983Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 16 oct. 1981
    Livré le 29 oct. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts & other debts due, owing or incurred to the company present & future.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 oct. 1981Enregistrement d'une charge
    • 24 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 déc. 1980
    Livré le 18 déc. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H lands & premises being the old court house, priory road, st. Ives, cambridgeshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1980Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 09 févr. 1978
    Livré le 21 févr. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H lands and premises being:- 83 victoria rd, new chesterton, cambridgeshire, together with all fixtures. Title no:- GB 8203.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 1978Enregistrement d'une charge
    • 03 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 17 août 1977
    Livré le 24 août 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge (see doc M18 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1977Enregistrement d'une charge
    • 24 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 mars 2019Commencement of winding up
    17 avr. 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Edward Butt
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    practitioner
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Michael David Rollings
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    practitioner
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0