BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01021920 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 6 Snow Hill EC1A 2AY City Of London London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 10 pages | LIQ14 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David John King en tant que directeur le 31 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Michael Mccall en tant que secrétaire le 31 déc. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG à 6 Snow Hill City of London London EC1A 2AY le 08 avr. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration des affaires | 10 pages | LIQ02 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 déc. 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ashley Gilroy Mark Highfield en tant que directeur le 05 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 août 2016 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 11-13 Mill Street Bedford Bedfordshire MK40 3EU à Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG le 06 août 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 03 janv. 2015 | 9 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2013 | 8 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David John King le 01 juil. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ashley Gilroy Mark Highfield le 01 juil. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Peter Michael Mccall le 01 juil. 2014 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 déc. 2012 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTT, Jane Dorothy | Secrétaire | Sawatdi East Road PE8 4BX Oundle Northhampshire | British | 102874790001 | ||||||
| HARRIS, Christopher Ian | Secrétaire | 6 Baker Court Thrapston NN14 4XA Kettering Northamptonshire | British | 53420880002 | ||||||
| LISLE, Vincent Thomas | Secrétaire | 5 Otters Holt Durkar WF4 3QE Wakefield West Yorkshire | British | 88104040001 | ||||||
| MCCALL, Peter Michael | Secrétaire | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | 158805550001 | |||||||
| PATRICK, David John | Secrétaire | 21 East Street NN1 5JZ Northampton | British | 119390850002 | ||||||
| STEELE, Toby Andrew Murray | Secrétaire | 62 Dynevor Close Bromham MK43 8UD Bedford Bedfordshire | British | 91907510001 | ||||||
| VALDERAZ, Anne | Secrétaire | 37 Manor Lane Alconbury PE17 5EH Huntingdon Cambridgeshire | British | 48965240001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secrétaire | Sennen Grange Road MK43 7EU Felmersham North Bedfordshire | British | 16754910001 | ||||||
| YEOMANS, Graham Arthur | Secrétaire | 13 Beagle Ridge Drive Acomb YO2 3JH York North Yorkshire | British | 602760001 | ||||||
| ALLEN, Frederick John | Administrateur | 6 Glebe Close Horringer IP29 5PR Bury St Edmunds Suffolk | British | 30121880001 | ||||||
| BAILLIE, John Andrew Main | Administrateur | Yew Cottage Main Road, Uffington PE9 4SN Stamford Lincolnshire | British | 76483990001 | ||||||
| BOWDLER, Timothy John | Administrateur | 2-11 St Vincent Place EH3 5BQ Edinburgh | United Kingdom | British | 37521870002 | |||||
| CAMMIADE, Danny | Administrateur | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | England | British | 251394160001 | |||||
| CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio | Administrateur | 21 Braid Farm Road EH10 6LE Edinburgh | Scotland | British | 474360001 | |||||
| CLARK, Stephen Robert | Administrateur | 114 Hillesden Avenue Elstow MK42 9AJ Bedford Bedfordshire | British | 60851690002 | ||||||
| ELLIS, Michael John | Administrateur | 40 King Street Somersham PE17 3EJ Huntingdon Cambridgeshire | England | British | 178022450001 | |||||
| EVANS, Michael Joseph | Administrateur | The Manor House 59 Church Street Nassington PE8 6QG Peterborough Cambridgeshire | England | British | 30037370001 | |||||
| FEETHAM, Robert Anthony | Administrateur | 4 The Charters Uffington PE9 4UD Stamford Lincolnshire | England | British | 64401770001 | |||||
| FRY, John Anthony | Administrateur | Church Hill NR15 1TD Saxlingham Nethergate Old Rectory Norfolk Uk | England | British | 136914890001 | |||||
| HARRIS, Christopher Ian | Administrateur | 31 Kettering Road Isham NN14 1HQ Kettering Northamptonshire | British | 53420880003 | ||||||
| HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Administrateur | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | 164400440001 | |||||
| JOHNSTON, Frederick Patrick Mair | Administrateur | 1 Grange Terrace EH9 2LD Edinburgh | British | 328390001 | ||||||
| JOHNSTON, Michael Frederick | Administrateur | 19 Webster Gardens W5 5NA London | British | 64615750001 | ||||||
| KING, David John | Administrateur | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | 179020430001 | |||||
| LANKESTER, David Robin Archibald | Administrateur | 11 Bath Row PE9 2QU Stamford Lincolnshire | British | 49804010002 | ||||||
| LAWLER, Thomas Philip | Administrateur | Glenlair Cottage 15 Nab Lane BD18 4EH Shipley West Yorkshire | British | 7475760001 | ||||||
| MURRAY, Grant | Administrateur | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | 159877110001 | |||||
| NIZOL, David Frederick | Administrateur | 18 Hallam Close CM15 0NW Brentwood Essex | British | 109032760001 | ||||||
| PATERSON, Stuart Randall | Administrateur | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 64281400001 | |||||
| RATCLIFFE, Neil Anthony | Administrateur | Red Oaks Mill Road Lower Shiplake RG9 3LN Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 122955650001 | |||||
| RICHARDSON, Michael Robert | Administrateur | 4 Saint Marys Close Felmersham MK43 7JP Bedford Bedfordshire | England-Uk | British | 74383790001 | |||||
| TOULMIN, George Michael | Administrateur | The West Wing Thorp Arch Hall LS23 7AW Wetherby West Yorkshire | British | 9253330001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnston Press Plc | 06 avr. 2016 | 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Orchard Brae House Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 01 juil. 1996 Livré le 19 juil. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement, the other finance documents, the rbs facilities, the bridging facility and the rbs guarantee and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without limitation, all obligations to indemnify the chargee (the "secured obligations") | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 18 avr. 1983 Livré le 07 mai 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Please see doc M22). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 16 oct. 1981 Livré le 29 oct. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book debts & other debts due, owing or incurred to the company present & future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 12 déc. 1980 Livré le 18 déc. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H lands & premises being the old court house, priory road, st. Ives, cambridgeshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 09 févr. 1978 Livré le 21 févr. 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H lands and premises being:- 83 victoria rd, new chesterton, cambridgeshire, together with all fixtures. Title no:- GB 8203. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 17 août 1977 Livré le 24 août 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Floating charge (see doc M18 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0