THE SYMPHONY GROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE SYMPHONY GROUP PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 01022506
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE SYMPHONY GROUP PLC ?

    • Fabrication de meubles de cuisine (31020) / Industries manufacturières

    Où se situe THE SYMPHONY GROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    Pen Hill Estate
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE SYMPHONY GROUP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BDC CABINETS LIMITED27 août 197127 août 1971

    Quels sont les derniers comptes de THE SYMPHONY GROUP PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE SYMPHONY GROUP PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au26 juil. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation09 août 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au26 juil. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour THE SYMPHONY GROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Ian Ralph Marwood en tant qu'administrateur le 25 juil. 2024

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    26 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    25 pagesAA

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 010225060019, créée le 15 févr. 2023

    34 pagesMR01

    Inscription de la charge 010225060020, créée le 15 févr. 2023

    37 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    25 pagesAA

    Cessation de la nomination de Graham Smith en tant que directeur le 30 avr. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr John Alexander Dunsford en tant qu'administrateur le 01 juil. 2020

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    25 pagesAA

    Nomination de Mr Richard James Bunton en tant qu'administrateur le 05 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 26 juil. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Adrienne Lee Murdoch en tant que secrétaire le 25 mai 2017

    2 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    24 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de THE SYMPHONY GROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MURDOCH, Adrienne Lee
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    232410760001
    BUNTON, Richard James
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Administrateur
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    EnglandEnglishDirector238168960001
    DAVIS, Martyn Royston
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Administrateur
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector65809190002
    DUNSFORD, John Alexander
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Administrateur
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector170179020002
    GREGORY, Katherine May
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Administrateur
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    EnglandBritishSolicitor60564500005
    MARWOOD, Ian Ralph
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Administrateur
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    EnglandBritishNon-Executive Director176710990001
    HAY, Ellen Nataly
    24 Rutland Drive
    HG1 2NS Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    24 Rutland Drive
    HG1 2NS Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Secretary38173190001
    HODKIN, David Arthur
    27 Nettleham Road
    LN2 1RQ Lincoln
    Secrétaire
    27 Nettleham Road
    LN2 1RQ Lincoln
    BritishFinance Director40702370002
    HODKIN, David Arthur
    3 Nursery Grove
    LN2 1RS Lincoln
    Secrétaire
    3 Nursery Grove
    LN2 1RS Lincoln
    BritishChartered Management Accountan40702370001
    HUGGAN, Brigitte
    10 Kirklees Garth
    LS28 5TQ Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    10 Kirklees Garth
    LS28 5TQ Leeds
    West Yorkshire
    British91229970001
    MURDOCH, Adrienne Lee
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    180206310001
    SMITH, Graham
    Langdale 103 Back Lane South
    Wheldrake
    YO19 6DT York
    Yorkshire
    Secrétaire
    Langdale 103 Back Lane South
    Wheldrake
    YO19 6DT York
    Yorkshire
    BritishFinance Director58431810001
    STEWART, Claire Susan
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    211959310001
    SWALLOW, Jack Marsh
    275 New Mill Road
    Brockholes
    HD7 7AL Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    275 New Mill Road
    Brockholes
    HD7 7AL Huddersfield
    West Yorkshire
    British1970680001
    VERNON, Pauline
    Northfield Villa
    Field Lane Wistow
    YO8 3XD Selby
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Northfield Villa
    Field Lane Wistow
    YO8 3XD Selby
    North Yorkshire
    British30696930002
    WATSON, Diane
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    BritishCompany Secretary35170730003
    DONNELLY, Philip Joseph
    56 Crimple Meadows
    Pannal
    HG3 1EN Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    56 Crimple Meadows
    Pannal
    HG3 1EN Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector1970700001
    GREGORY, Douglas Stuart
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Administrateur
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector1970690004
    HASSELL, Harold Robert
    Whitecroft Browgate
    Baildon
    BD17 6NQ Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    Whitecroft Browgate
    Baildon
    BD17 6NQ Bradford
    West Yorkshire
    BritishGroup Sales & Marketing Direct44943970001
    HODKIN, David Arthur
    27 Nettleham Road
    LN2 1RQ Lincoln
    Administrateur
    27 Nettleham Road
    LN2 1RQ Lincoln
    United KingdomBritishFinancial Director40702370002
    KETTLEWELL, Paul
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Administrateur
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    United KingdomBritishSales Director60741940001
    KIRK, Philip Anthony
    8 Ullswater Rise
    LS22 6YP Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 Ullswater Rise
    LS22 6YP Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector35144620001
    RILEY, John David
    Rhinsdale The Ridge
    Linton
    LS22 4HJ Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Rhinsdale The Ridge
    Linton
    LS22 4HJ Wetherby
    West Yorkshire
    BritishGroup Commercial Director42377590001
    SINFIELD, Ian Albert
    28 South Drive
    HG2 8AU Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    28 South Drive
    HG2 8AU Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector77984760001
    SMITH, Graham
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    Administrateur
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director58431810004
    SMITH, Robert
    6 Higham Way
    HU15 1NA Brough
    North Humberside
    Administrateur
    6 Higham Way
    HU15 1NA Brough
    North Humberside
    BritishSpecial Projects Director30936890001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE SYMPHONY GROUP PLC ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Symphony Holdings Limited
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    England
    06 avr. 2016
    Park Spring Road
    S72 7EZ Barnsley
    Pen Hill Estate
    South Yorkshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House Uk
    Numéro d'enregistrement05533292
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    THE SYMPHONY GROUP PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 15 févr. 2023
    Livré le 21 févr. 2023
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank Corporate Markets PLC
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 févr. 2023
    Livré le 21 févr. 2023
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank Corporate Markets PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 15 déc. 2009
    Livré le 16 déc. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 15 déc. 2009
    Livré le 16 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 mars 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 avr. 1998
    Livré le 13 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 mai 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 août 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Single debenture
    Créé le 02 sept. 1994
    Livré le 14 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 10 mai 1993
    Livré le 25 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 1993Enregistrement d'une charge
    • 23 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 21 oct. 1991
    Livré le 06 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See doc M560C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 nov. 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 nov. 1990
    Livré le 14 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The parking area comprising part of land and buildings at sheffield road brinsworth rotherham south yorkshire t/n part of SYK269885.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 04 janv. 1990
    Livré le 17 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 janv. 1989
    Livré le 18 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 11 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 janv. 1989
    Livré le 18 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Gerrard place east gillibrands skelmesdale lancashire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 déc. 1988
    Livré le 11 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at sheffield road brinsworth south yorkshire t/n SYK249107.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 déc. 1988
    Livré le 11 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Office premises at sheffield road brinsworth south yorkshire t/n SYK249017.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 août 1988
    Livré le 24 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the north east side of peel road skelmesdale lancashire t/n's LA520371 and LA520372 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1988Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 14 mai 1984
    Livré le 18 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property situate to the north west side of gelderd road leeds west yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 1984Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 21 févr. 1980
    Livré le 29 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property progress works gelderd lane leeds 12 t/n WYK177615. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank Limited
    Transactions
    • 29 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 08 janv. 1980
    Livré le 11 janv. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to north west of gelderd lane wortley leeds 12 t/n ywe 65613. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank Limited
    Transactions
    • 11 janv. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0