THE SYMPHONY GROUP PLC
Vue d'ensemble
Nom de la société | THE SYMPHONY GROUP PLC |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société anonyme cotée en bourse |
Numéro de société | 01022506 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE SYMPHONY GROUP PLC ?
Adresse du siège social | Pen Hill Estate Park Spring Road S72 7EZ Barnsley South Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE SYMPHONY GROUP PLC ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE SYMPHONY GROUP PLC ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 26 juil. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 09 août 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 26 juil. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE SYMPHONY GROUP PLC ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Ian Ralph Marwood en tant qu'administrateur le 25 juil. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 26 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 août 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 25 pages | AA | ||
Satisfaction de la charge 17 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Inscription de la charge 010225060019, créée le 15 févr. 2023 | 34 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge 010225060020, créée le 15 févr. 2023 | 37 pages | MR01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 25 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 25 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Graham Smith en tant que directeur le 30 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr John Alexander Dunsford en tant qu'administrateur le 01 juil. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 24 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 août 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 24 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 août 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 25 pages | AA | ||
Nomination de Mr Richard James Bunton en tant qu'administrateur le 05 sept. 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 août 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 26 juil. 2017 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mrs Adrienne Lee Murdoch en tant que secrétaire le 25 mai 2017 | 2 pages | AP03 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 24 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de THE SYMPHONY GROUP PLC ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURDOCH, Adrienne Lee | Secrétaire | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | 232410760001 | |||||||
BUNTON, Richard James | Administrateur | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | England | English | Director | 238168960001 | ||||
DAVIS, Martyn Royston | Administrateur | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 65809190002 | ||||
DUNSFORD, John Alexander | Administrateur | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | England | British | Director | 170179020002 | ||||
GREGORY, Katherine May | Administrateur | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | England | British | Solicitor | 60564500005 | ||||
MARWOOD, Ian Ralph | Administrateur | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | England | British | Non-Executive Director | 176710990001 | ||||
HAY, Ellen Nataly | Secrétaire | 24 Rutland Drive HG1 2NS Harrogate North Yorkshire | British | Company Secretary | 38173190001 | |||||
HODKIN, David Arthur | Secrétaire | 27 Nettleham Road LN2 1RQ Lincoln | British | Finance Director | 40702370002 | |||||
HODKIN, David Arthur | Secrétaire | 3 Nursery Grove LN2 1RS Lincoln | British | Chartered Management Accountan | 40702370001 | |||||
HUGGAN, Brigitte | Secrétaire | 10 Kirklees Garth LS28 5TQ Leeds West Yorkshire | British | 91229970001 | ||||||
MURDOCH, Adrienne Lee | Secrétaire | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | 180206310001 | |||||||
SMITH, Graham | Secrétaire | Langdale 103 Back Lane South Wheldrake YO19 6DT York Yorkshire | British | Finance Director | 58431810001 | |||||
STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | 211959310001 | |||||||
SWALLOW, Jack Marsh | Secrétaire | 275 New Mill Road Brockholes HD7 7AL Huddersfield West Yorkshire | British | 1970680001 | ||||||
VERNON, Pauline | Secrétaire | Northfield Villa Field Lane Wistow YO8 3XD Selby North Yorkshire | British | 30696930002 | ||||||
WATSON, Diane | Secrétaire | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | British | Company Secretary | 35170730003 | |||||
DONNELLY, Philip Joseph | Administrateur | 56 Crimple Meadows Pannal HG3 1EN Harrogate North Yorkshire | British | Director | 1970700001 | |||||
GREGORY, Douglas Stuart | Administrateur | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 1970690004 | ||||
HASSELL, Harold Robert | Administrateur | Whitecroft Browgate Baildon BD17 6NQ Bradford West Yorkshire | British | Group Sales & Marketing Direct | 44943970001 | |||||
HODKIN, David Arthur | Administrateur | 27 Nettleham Road LN2 1RQ Lincoln | United Kingdom | British | Financial Director | 40702370002 | ||||
KETTLEWELL, Paul | Administrateur | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | United Kingdom | British | Sales Director | 60741940001 | ||||
KIRK, Philip Anthony | Administrateur | 8 Ullswater Rise LS22 6YP Wetherby West Yorkshire | British | Director | 35144620001 | |||||
RILEY, John David | Administrateur | Rhinsdale The Ridge Linton LS22 4HJ Wetherby West Yorkshire | British | Group Commercial Director | 42377590001 | |||||
SINFIELD, Ian Albert | Administrateur | 28 South Drive HG2 8AU Harrogate North Yorkshire | British | Director | 77984760001 | |||||
SMITH, Graham | Administrateur | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 58431810004 | ||||
SMITH, Robert | Administrateur | 6 Higham Way HU15 1NA Brough North Humberside | British | Special Projects Director | 30936890001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE SYMPHONY GROUP PLC ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symphony Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Park Spring Road S72 7EZ Barnsley Pen Hill Estate South Yorkshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
THE SYMPHONY GROUP PLC a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 15 févr. 2023 Livré le 21 févr. 2023 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 15 févr. 2023 Livré le 21 févr. 2023 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 15 déc. 2009 Livré le 16 déc. 2009 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Créé le 15 déc. 2009 Livré le 16 déc. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 22 avr. 1998 Livré le 13 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 02 sept. 1994 Livré le 14 sept. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 10 mai 1993 Livré le 25 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 21 oct. 1991 Livré le 06 nov. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (See doc M560C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 28 nov. 1990 Livré le 14 déc. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The parking area comprising part of land and buildings at sheffield road brinsworth rotherham south yorkshire t/n part of SYK269885. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 04 janv. 1990 Livré le 17 janv. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 11 janv. 1989 Livré le 18 janv. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 11 janv. 1989 Livré le 18 janv. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Gerrard place east gillibrands skelmesdale lancashire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 21 déc. 1988 Livré le 11 janv. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings at sheffield road brinsworth south yorkshire t/n SYK249107. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 21 déc. 1988 Livré le 11 janv. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Office premises at sheffield road brinsworth south yorkshire t/n SYK249017. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 17 août 1988 Livré le 24 août 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings on the north east side of peel road skelmesdale lancashire t/n's LA520371 and LA520372 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 14 mai 1984 Livré le 18 mai 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property situate to the north west side of gelderd road leeds west yorkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 21 févr. 1980 Livré le 29 févr. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property progress works gelderd lane leeds 12 t/n WYK177615. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 08 janv. 1980 Livré le 11 janv. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land to north west of gelderd lane wortley leeds 12 t/n ywe 65613. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0