RSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED

RSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01023631
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED ?

    • Transport aérien de passagers non régulier (51102) / Transports et stockage

    Où se situe RSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OCEAN SKY ENGINEERING LIMITED24 août 200924 août 2009
    NORTHERN EXECUTIVE AVIATION (MAINTENANCE) LIMITED10 sept. 197110 sept. 1971

    Quels sont les derniers comptes de RSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour RSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    15 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 nov. 2017

    12 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 nov. 2016

    8 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 nov. 2015

    10 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 18 nov. 2014

    LRESEX

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Changement d'adresse du siège social de Britannia House Frank Lester Way London Luton Airport Luton LU2 9NQ à C/O Bdo Llp 55 Baker Street London W1U 7EU le 26 nov. 2014

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Andrew David May en tant qu'administrateur le 27 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Helen Baldwin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edward Allison en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 janv. 2014

    État du capital au 15 janv. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    2 pagesGAZ1

    Nomination de Mrs Helen Baldwin en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    17 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Certificat de changement de nom

    Company name changed ocean sky engineering LIMITED\certificate issued on 27/09/12
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name27 sept. 2012

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name27 sept. 2012

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Changement d'adresse du siège social de * Portland House Bressenden Place London SW1E 5BH England* le 12 sept. 2012

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Ian Anderson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de RSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAY, Andrew David
    c/o Bdo Llp
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    England
    Administrateur
    c/o Bdo Llp
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    England
    EnglandBritish106913510001
    ANDERSON, Ian
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    Secrétaire
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    168685840001
    ANTROBUS, David Lowden
    Spring Cottage Wellbank Lane
    Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    Spring Cottage Wellbank Lane
    Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    British7393710001
    CURTIS, Gemma
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    Secrétaire
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    157655780001
    DAVEY, Martin Gregory
    4 Mount Grove
    Gatley
    SK8 4HR Cheadle
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Mount Grove
    Gatley
    SK8 4HR Cheadle
    Cheshire
    British48367350001
    OLASHORE, Kemi Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    Secrétaire
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    British136168760001
    HBJGW MANCHESTER SECRETARIES LIMITED
    3 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Secrétaire
    3 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    113594300007
    ALLISON, Edward Leonard
    Frank Lester Way
    London Luton Airport
    LU2 9NQ Luton
    Britannia House
    England
    Administrateur
    Frank Lester Way
    London Luton Airport
    LU2 9NQ Luton
    Britannia House
    England
    ScotlandBritish171855920001
    ANDERSON, Ian
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    Administrateur
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    United KingdomBritish168652280001
    ANTROBUS, David Lowden
    Spring Cottage Wellbank Lane
    Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Spring Cottage Wellbank Lane
    Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritish7393710001
    BALDWIN, Helen
    Frank Lester Way
    London Luton Airport
    LU2 9NQ Luton
    Britannia House
    England
    Administrateur
    Frank Lester Way
    London Luton Airport
    LU2 9NQ Luton
    Britannia House
    England
    EnglandBritish181424030001
    BESGROVE, Kerry Ivor
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    Administrateur
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    United KingdomBritish135146820001
    BRYAN, Antony
    11 Oakdene Place
    PH2 6PD Scone
    Perthshire
    Administrateur
    11 Oakdene Place
    PH2 6PD Scone
    Perthshire
    ScotlandBritish104734350001
    CURTIS, Gemma Louise
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    Administrateur
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    United KingdomBritish157653810001
    DE RAAT, Cornelius Rochus
    Chemin Due Couchant 6
    1180 Rolle
    FOREIGN
    Switzerland
    Administrateur
    Chemin Due Couchant 6
    1180 Rolle
    FOREIGN
    Switzerland
    Dutch7409160001
    FOLEY, Michael Patrick
    3 Waddington Fold
    OL16 4QB Rochdale
    Administrateur
    3 Waddington Fold
    OL16 4QB Rochdale
    British94635680001
    GRIMES, Stephen Philip
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    Administrateur
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    United KingdomBritish131401310001
    MALTBY, Philip
    Business Aviation Centre
    Hangar 7 Faireys Way
    M90 5NE Manchester Airport West
    Manchester
    Administrateur
    Business Aviation Centre
    Hangar 7 Faireys Way
    M90 5NE Manchester Airport West
    Manchester
    United KingdomBritish135146730001
    MUN-GAVIN, David Colin
    1 Airlie Gardens
    W8 7AJ London
    Administrateur
    1 Airlie Gardens
    W8 7AJ London
    British21890490001
    OLASHORE, Kemi Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    Administrateur
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    United KingdomBritish136168760001
    RAPER, Natalie Jane
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    Administrateur
    Bressenden Place
    SW1E 5BH London
    Portland House
    England
    EnglandBritish139050420001
    SIMPSON, James Young
    Rudha Mor
    IV52 8TH Plockton
    Ross Shire
    Administrateur
    Rudha Mor
    IV52 8TH Plockton
    Ross Shire
    British7393730001
    TEHRANCHIAN, Kurosh
    37 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Administrateur
    37 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    British117157030001

    RSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 août 2003
    Livré le 19 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 juin 1998
    Livré le 04 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transactions
    • 04 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Single debenture
    Créé le 03 déc. 1985
    Livré le 09 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures) for details see doc m 37. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 25 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Omnibus letter of set off
    Créé le 28 août 1984
    Livré le 10 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or northern executive aviation limited to the chargee
    Brèves mentions
    All sums standing to the present or future account of the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • 25 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    RSS AIRCRAFT ENGINEERING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 avr. 2019Dissolved on
    18 nov. 2014Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Shane Crooks
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0