G REALISATIONS 2022 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéG REALISATIONS 2022 LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01026430
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de G REALISATIONS 2022 LIMITED ?

    • Vente au détail de vêtements en magasin spécialisé (47710) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe G REALISATIONS 2022 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    G Realisations 2022 Limited C/O Fti Consulting 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de G REALISATIONS 2022 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GIEVES LIMITED30 juin 199930 juin 1999
    GIEVES & HAWKES LIMITED06 oct. 197106 oct. 1971

    Quels sont les derniers comptes de G REALISATIONS 2022 LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2021
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2022
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour G REALISATIONS 2022 LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au25 juin 2023
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation09 juil. 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au25 juin 2022
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour G REALISATIONS 2022 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    4 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    40 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    41 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    4 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    40 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    40 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    42 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    15 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    4 pagesAM06

    Changement d'adresse du siège social de Ground Floor 21-22 Grosvenor Street London W1K 4QJ United Kingdom à G Realisations 2022 Limited C/O Fti Consulting 200 Aldersgate Aldersgate Street London London EC1A 4HD le 19 déc. 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    68 pagesAM03

    Nomination d'un administrateur

    4 pagesAM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed gieves LIMITED\certificate issued on 02/12/22
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name02 déc. 2022

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas John Pike le 05 juil. 2022

    2 pagesCH01

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration de confirmation établie le 25 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 010264300010, créée le 16 juin 2022

    24 pagesMR01

    Modification des détails de Mr Qiu Yafu en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 mai 2022

    2 pagesPSC04

    Changement d'adresse du siège social de 22 King Street London SW1Y 6QY United Kingdom à Ground Floor 21-22 Grosvenor Street London W1K 4QJ le 18 mai 2022

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    33 pagesAA

    Statuts

    6 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    6 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Qui sont les dirigeants de G REALISATIONS 2022 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PIKE, Nicholas John
    Leicester House
    Thomas Wyatt Close
    NR2 2TN Norwich
    20
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Leicester House
    Thomas Wyatt Close
    NR2 2TN Norwich
    20
    Norfolk
    United Kingdom
    EnglandBritish290766640001
    BAXTER, James Nathan
    37 Turners Avenue
    GU51 1DU Fleet
    Hampshire
    Secrétaire
    37 Turners Avenue
    GU51 1DU Fleet
    Hampshire
    British75619440002
    BRASSINGTON, Philip John
    King Street
    SW1Y 6QY London
    22
    United Kingdom
    Secrétaire
    King Street
    SW1Y 6QY London
    22
    United Kingdom
    262582460001
    COLLINS, David Alford
    Savile Row
    W1S 3PE London
    7
    England
    Secrétaire
    Savile Row
    W1S 3PE London
    7
    England
    169541640001
    COLLINS, David Alford
    3 Malkin Drive
    HP9 1JN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    3 Malkin Drive
    HP9 1JN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British66969430001
    COLLINS, David Alford
    3 Malkin Drive
    HP9 1JN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    3 Malkin Drive
    HP9 1JN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British66969430001
    CURRIE, Ian Hamilton
    72 Hill Road
    Portchester
    PO16 8JY Fareham
    Hampshire
    Secrétaire
    72 Hill Road
    Portchester
    PO16 8JY Fareham
    Hampshire
    British46791700001
    DRESNER, William Johnathan
    Ember Lane
    KT10 8EH Esher
    143
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ember Lane
    KT10 8EH Esher
    143
    Surrey
    United Kingdom
    British135982370001
    JOHNSTON, Matthew Francis Iain, Mr.
    King Street
    SW1Y 6QY London
    22
    United Kingdom
    Secrétaire
    King Street
    SW1Y 6QY London
    22
    United Kingdom
    218129700001
    MERRIMAN, Andrew John
    1 Savile Row
    London
    W1S 3JR
    Secrétaire
    1 Savile Row
    London
    W1S 3JR
    153013050001
    SAUNDERS, Anthony James, Mr.
    Northumberland House 31 Jubilee Road
    PO7 7RD Waterlooville
    Hampshire
    Secrétaire
    Northumberland House 31 Jubilee Road
    PO7 7RD Waterlooville
    Hampshire
    British52310160001
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    22 Melton Street
    NW1 2BW London
    Secrétaire
    22 Melton Street
    NW1 2BW London
    38636470004
    BAXTER, James Nathan
    37 Turners Avenue
    GU51 1DU Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    37 Turners Avenue
    GU51 1DU Fleet
    Hampshire
    British75619440002
    BOOW, Julian
    33 Alexander Street
    W2 5NU London
    Administrateur
    33 Alexander Street
    W2 5NU London
    British102484290001
    CLACHER, Raymond Mark
    Savile Row
    W1S 3JN London
    14
    United Kingdom
    United Kingdom
    Administrateur
    Savile Row
    W1S 3JN London
    14
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandBritish188050940001
    CLACHER, Raymond Mark
    119 Chartridge Lane
    HP5 2RG Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    119 Chartridge Lane
    HP5 2RG Chesham
    Buckinghamshire
    British96302390002
    COHEN, Richard Samuel, Mr.
    Savile Row
    W1S 3PE London
    7
    England
    Administrateur
    Savile Row
    W1S 3PE London
    7
    England
    Hong KongAmerican187963310002
    COLLINS, David Alford
    Savile Row
    W1S 3PE London
    7
    England
    Administrateur
    Savile Row
    W1S 3PE London
    7
    England
    EnglandBritish,Australian170092960001
    COLLINS, David Alford
    3 Malkin Drive
    HP9 1JN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    3 Malkin Drive
    HP9 1JN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish66969430001
    COLLINS, David Alford
    3 Malkin Drive
    HP9 1JN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    3 Malkin Drive
    HP9 1JN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish66969430001
    CURRIE, Ian Hamilton
    72 Hill Road
    Portchester
    PO16 8JY Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    72 Hill Road
    Portchester
    PO16 8JY Fareham
    Hampshire
    EnglandBritish46791700001
    DAVIES, Nicole Rosemary
    12 Brandon Mansions
    Queens Club Gardens
    W14 9RE London
    Administrateur
    12 Brandon Mansions
    Queens Club Gardens
    W14 9RE London
    British43692270001
    DRESNER, William Johnathan
    Ember Lane
    KT10 8EH Esher
    143
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ember Lane
    KT10 8EH Esher
    143
    Surrey
    United Kingdom
    British135982370001
    DUNKLEY, Karl James
    7 Pembroke Place
    W8 6ET London
    Administrateur
    7 Pembroke Place
    W8 6ET London
    British34929820003
    DURNIN, John Patrick
    1 Savile Row
    London
    W1S 3JR
    Administrateur
    1 Savile Row
    London
    W1S 3JR
    United KingdomBritish153012320001
    FORRESTER, William
    Flat 2 23 Nottingham Street
    W1U 5ES London
    Administrateur
    Flat 2 23 Nottingham Street
    W1U 5ES London
    United KingdomBritish114444680001
    GIBBS, Simon David
    The Lost Cottage Church Road
    Penn
    HP10 8EG High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Lost Cottage Church Road
    Penn
    HP10 8EG High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish25615050002
    GIEVE, Robert James Watson
    The Old Vicarage
    Wonersh
    GU5 0PF Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Wonersh
    GU5 0PF Guildford
    Surrey
    British13395300001
    GORDON MARTIN, Howard Michael
    Dryburgh House 5 Dryburgh Road
    SW15 1BN London
    Administrateur
    Dryburgh House 5 Dryburgh Road
    SW15 1BN London
    British47696810001
    HAOUZI, Paul David
    56/F, Tower 1
    Island Resort
    28 Siu Sai Wan Road
    Flat F
    Hong Kong
    Administrateur
    56/F, Tower 1
    Island Resort
    28 Siu Sai Wan Road
    Flat F
    Hong Kong
    Hong KongFrench252872390001
    HENDERSON, Mark Anthony Vere
    King Street
    SW1Y 6QY London
    22
    United Kingdom
    Administrateur
    King Street
    SW1Y 6QY London
    22
    United Kingdom
    EnglandBritish70383260001
    HIGGINS, John Francis
    42 Kinnerton Street
    Belgravia
    SW1X 8ES London
    Administrateur
    42 Kinnerton Street
    Belgravia
    SW1X 8ES London
    British51013840002
    HOBBINS, Jeremy Paul Egerton
    Savile Row
    W1S 3JN London
    14
    United Kingdom
    United Kingdom
    Administrateur
    Savile Row
    W1S 3JN London
    14
    United Kingdom
    United Kingdom
    ChinaBritish52576800006
    IFAYEMI, Lennard Oluwafemi
    1 Starrock Road
    CR5 3EH Coulsdon
    Surrey
    Administrateur
    1 Starrock Road
    CR5 3EH Coulsdon
    Surrey
    British35372890001
    LEE KA KUI, Edmund
    1 Savile Row
    London
    W1S 3JR
    Administrateur
    1 Savile Row
    London
    W1S 3JR
    ChinaChinese187505320001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur G REALISATIONS 2022 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Qiu Yafu
    21-22 Grosvenor Street
    W1K 4QJ London
    Ground Floor
    United Kingdom
    18 avr. 2018
    21-22 Grosvenor Street
    W1K 4QJ London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: Chinese
    Pays de résidence: China
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Savile Row
    W1S 3JN London
    14
    United Kingdom
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Savile Row
    W1S 3JN London
    14
    United Kingdom
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01455128
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    G REALISATIONS 2022 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 juin 2022
    Livré le 23 juin 2022
    En cours
    Brève description
    The chargor charges to the lender by way of separate first fixed charges, all interests and estates in any freehold, leasehold or commonhold property now or subsequently owned by it and all its intellectual property.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Huk 110 Limited
    Transactions
    • 23 juin 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    Memorandum of security relating to a deposit
    Créé le 10 août 2011
    Livré le 12 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of East Asia
    Transactions
    • 12 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 25 sept. 2006
    Livré le 27 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from gieves & hawkes PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h interest in 1 savile row london, insurance, all contracts and rights, floating charge the undertaking and assets of the company present and future,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of East Asia
    Transactions
    • 27 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 13 oct. 1997
    Livré le 14 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    26A, 28 and 30 market street leicester t/no's;-LT40755 and LT272410. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of legal charge and mortgage
    Créé le 15 févr. 1996
    Livré le 06 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £2,400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    L/H land k/a 1 saville row city of westminster.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 06 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 15 juil. 1992
    Livré le 31 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £2,500,000 convertable secured loan stock 2000 of the gieves group PLC and all other monies to the chargee under the terms of the deed
    Brèves mentions
    See form 395 ref 94. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • US1 Holdings Limited
    Transactions
    • 31 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of set off
    Créé le 29 janv. 1985
    Livré le 08 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    All sums standing to the present or future account of the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 07 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Leter of set off
    Créé le 17 déc. 1982
    Livré le 22 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any/or the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    Any sums standing to the credit of any present /future account of the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    • 07 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 07 sept. 1981
    Livré le 16 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank LTD
    Transactions
    • 16 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    • 05 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 07 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 10 mars 1980
    Livré le 17 mars 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank LTD
    Transactions
    • 17 mars 1980Enregistrement d'une charge

    G REALISATIONS 2022 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 nov. 2022Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samuel Ballinger
    Fourth Floor 200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    practitioner
    Fourth Floor 200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Andrew Johnson
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    practitioner
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Christopher Jon Bennett
    200 Aldersgate Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    practitioner
    200 Aldersgate Aldersgate Street
    EC1A 4HD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0