BRITISH FITTINGS NORTH WESTERN LIMITED

BRITISH FITTINGS NORTH WESTERN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRITISH FITTINGS NORTH WESTERN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01030094
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRITISH FITTINGS NORTH WESTERN LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe BRITISH FITTINGS NORTH WESTERN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRITISH FITTINGS NORTH WESTERN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRITISH FLOWPLANT MANUFACTURING LIMITED06 mai 199206 mai 1992
    JETTING EQUIPMENT TECHNOLOGY MANUFACTURING LIMITED12 nov. 199112 nov. 1991
    BRITISH FLOWPLANT MANUFACTURING GROUP LIMITED17 sept. 199117 sept. 1991
    HARBEN SYSTEMS LIMITED05 nov. 197105 nov. 1971

    Quels sont les derniers comptes de BRITISH FITTINGS NORTH WESTERN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour BRITISH FITTINGS NORTH WESTERN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 23 sept. 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Canc share prem/undist reserves 15/09/2010
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Stephen Webster en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robert Andrew Ross Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen Paul Webster le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Alison Drew le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 juil. 2009

    5 pagesAA

    Comptes établis au 31 juil. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 juil. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 juil. 2006

    6 pagesAA

    Comptes établis au 31 juil. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de BRITISH FITTINGS NORTH WESTERN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DREW, Alison
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Secrétaire
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    British86845230002
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Administrateur
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritish150753930001
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    Administrateur
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    122185200001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Secrétaire
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    British37378570013
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    WOODWARD, William Edward
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    British11797040001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    British272310001
    BUCKETT, Cecil John
    Vectis House 10 Cherry Hill Drive
    Barnt Green
    B45 8JY Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    Vectis House 10 Cherry Hill Drive
    Barnt Green
    B45 8JY Birmingham
    West Midlands
    British690420001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Administrateur
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    British37378570013
    STANTON, Brian William
    The Moors
    Burlingham
    WR10 3AD Pershore
    Hereford & Worcester
    Administrateur
    The Moors
    Burlingham
    WR10 3AD Pershore
    Hereford & Worcester
    British14648180001
    WADSWORTH, Christopher Robert
    Cherry Trees
    Hinstock
    TF9 2ST Market Drayton
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Cherry Trees
    Hinstock
    TF9 2ST Market Drayton
    Shropshire
    England
    British27227340001
    WEBSTER, Stephen Paul
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Administrateur
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    United KingdomBritish40201730005
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    Administrateur
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritish82978250002
    WOODWARD, William Edward
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish11797040001

    BRITISH FITTINGS NORTH WESTERN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 24 avr. 1992
    Livré le 06 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the goodwill bookdebts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 22 août 1988
    Livré le 25 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 05 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 06 juin 1986
    Livré le 13 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 juin 1986Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 13 janv. 1981
    Livré le 20 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or harben pumps (london) limited
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. With all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 03 oct. 1980
    Livré le 14 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land & premises at watt road, churchfields salisbury wilts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1980Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 24 janv. 1980
    Livré le 05 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & buildings on the south of london rd, stone, dartford, kent. K 488775.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0