ENVIROCARE GB LTD.
Vue d'ensemble
Nom de la société | ENVIROCARE GB LTD. |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01031254 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ENVIROCARE GB LTD. ?
Adresse du siège social | 6 Stirling Park Laker Road ME1 3QR Rochester Kent England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ENVIROCARE GB LTD. ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour ENVIROCARE GB LTD. ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 oct. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP à 6 Stirling Park Laker Road Rochester Kent ME1 3QR le 15 juin 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2015 au 31 août 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Nomination de Mr Hugh Francis Edmonds en tant que secrétaire le 14 mai 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que secrétaire le 30 avr. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que directeur le 30 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY à 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP le 10 avr. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2013 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2012 | 19 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Prowse en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John William Charles Charlton le 01 oct. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Hodgson le 01 oct. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2011 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 14 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Qui sont les dirigeants de ENVIROCARE GB LTD. ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMONDS, Hugh Francis | Secrétaire | Stirling Park Laker Road ME1 3QR Rochester 6 Kent England | 197707250001 | |||||||
HODGSON, Richard George | Administrateur | Gunnersbury Crescent W3 9AA London 13 England | England | British | Finance Director | 155847280001 | ||||
CHARLTON, John William Charles | Secrétaire | Neata Farm Greet GL54 5BL Cheltenham Rowan Lodge Gloucestershire | British | 153009970001 | ||||||
HORTON TILLEY, Jeanette | Secrétaire | Pallett Drive CV11 6EG Nuneaton 31 Warks | British | 139414680001 | ||||||
PARKIN, Andrew, Dr | Secrétaire | 26 Heathfield Terrace Chiswick W4 4JE London | British | 30772800001 | ||||||
PRIESTLEY, Anne | Secrétaire | Laburnum Cottage 175 Kenilworth Road CV7 7ES Balsall Common | British | Company Secretary | 117428310001 | |||||
BRYDEN, Allan George Caldwell, The Executors Of | Administrateur | 1 Crossburn Avenue Milngavie G62 6DS Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | Director Pest Control | 65975140001 | ||||
CHARLTON, John William Charles | Administrateur | Neata Farm Greet GL54 5BL Cheltenham Rowan Lodge Gloucestershire | England | British | Director- Shared Services | 119598150002 | ||||
COE, Nicholas | Administrateur | 4 Abingdon View Gateford S81 7RT Worksop Nottinghamshire | Great Britain | British | Director | 118366940001 | ||||
JONES, Richard Humphrey | Administrateur | 14 Hederman Close Silverton EX5 4HW Exeter Devon | Great Britain | British | Director | 15790350001 | ||||
MCPHERSON, Ian | Administrateur | 124 Felbridge Avenue HA7 2BJ Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Director | 110587390001 | ||||
PARKIN, Andrew, Dr | Administrateur | 26 Heathfield Terrace Chiswick W4 4JE London | England | British | Executive | 30772800001 | ||||
PARKIN, Donald Harry | Administrateur | Three Gables Kirkby Lane LN10 Woodhall Spa Lincolnshire | British | 30772820001 | ||||||
PARKIN, Penelope Deighton | Administrateur | 26 Heathfield Terrace Chiswick W4 4JE London | England | British | Executive | 14235110001 | ||||
POLLARD, Christopher | Administrateur | Derril Pyworthy EX22 6YB Holsworthy The Ramblers Devon | England | British | Director | 127985500001 | ||||
PRIESTLEY, Peter James, William | Administrateur | 175 Kenilworth Road Balsall Common CV7 7ES Coventry Laburnum Cottage West Midlands | England | British | Director | 81411520001 | ||||
PROWSE, John | Administrateur | Ongar Road CM15 9HP Brentwood 317 Essex | England | British | Chief Executive Officer | 96786510001 | ||||
THOMSON, Ross Gavin | Administrateur | Blairdenan Avenue G69 0JT Moodiesburn 30 North Lanarkshire | Great Britain | British | Director | 161883100001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ENVIROCARE GB LTD. ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apc Technology Group Plc | 06 avr. 2016 | Stirling Park, Laker Road ME1 3QR Rochester 6 Kent England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
ENVIROCARE GB LTD. a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 19 août 2010 Livré le 24 août 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 28 sept. 2009 Livré le 06 oct. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 02 juil. 2009 Livré le 07 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 janv. 2002 Livré le 24 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 29 juin 1982 Livré le 14 juil. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 43 arlington gardens W4 london borough of hounslow. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 11 oct. 1973 Livré le 31 oct. 1973 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 26 heathfield terrace chiswick london W4. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0