BERISFORD BRISTAR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBERISFORD BRISTAR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01031367
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BERISFORD BRISTAR LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BERISFORD BRISTAR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BERISFORD BRISTAR LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRISTAR GROUP PLC19 oct. 198719 oct. 1987
    BRISTAR HOLDINGS LIMITED17 févr. 198417 févr. 1984
    LENABBEY ESTATES LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    DAVID LEWIS GROUP (ESTATES) LIMITED17 nov. 197117 nov. 1971

    Quels sont les derniers comptes de BERISFORD BRISTAR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour BERISFORD BRISTAR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 04 sept. 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 24/08/2012
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Nomination de Graham Philip Brisley Veal en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevin Blades en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Prima Secretary Limited le 18 juin 2010

    2 pagesCH04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Thomas Doerr en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Adrian David Gray en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de BERISFORD BRISTAR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Secrétaire
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Administrateur
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Administrateur
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Administrateur
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Administrateur
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Secrétaire
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Secrétaire
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Administrateur
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BUTLER, Peter Robert
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    British34707070001
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Administrateur
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Administrateur
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritish61620710001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    MULHALL, Denis Joseph
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    Administrateur
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    EnglandBritish,Irish32235150003
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Administrateur désigné
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    TIVEY, Andrew David
    2 Manor Farm Cottages
    Church Street
    KT4 7RY Worcester Park
    Administrateur
    2 Manor Farm Cottages
    Church Street
    KT4 7RY Worcester Park
    British9318760001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Administrateur
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    BERISFORD BRISTAR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Créé le 11 avr. 2002
    Livré le 25 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transactions
    • 25 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Créé le 20 févr. 2002
    Livré le 08 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transactions
    • 08 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Créé le 20 nov. 2001
    Livré le 30 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of amendment
    Créé le 30 sept. 1991
    Livré le 16 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from parent and/or each obligor (as defined therein). To the chargee. Under the terms of the guarantee and this deed of amendment
    Brèves mentions
    (For fuel details see form 390). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    • Barclays Bank"("He Replacement Agent")
    Transactions
    • 16 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 22 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 déc. 1990
    Livré le 04 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from each obligor to the chargee as "second security agent" and trustee for itself and for each bank under each of the indebtedness agreements andthe coffee refinancing agreement and of bensford international PLC under the subordinated guarantee
    Brèves mentions
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    Guarantee and debenture
    Créé le 18 déc. 1990
    Livré le 04 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for itself and for each bank under each of the indebtedness agreements
    Brèves mentions
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 03 juin 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 03 juin 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 19 déc. 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 22 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 sept. 1990
    Livré le 09 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each obligor (as defined therein) to the chargee (second security agent) as agent and transfer for itself and for each bank (as defined therein) under the terms of the indebtedness agreements the coffee refinacing agreement and the refinancing agreement dated 21.9.90, the subordinated guarantee and this chargee
    Brèves mentions
    All estates or interests in any f/h & l/h property. Also all group shores as specificied in the form 395.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 déc. 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 sept. 1990
    Livré le 09 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) under the terms of the indebtecness agreement, the refinancing agreement dated 21.9.90 and this charge.
    Brèves mentions
    All estates in any f/h & l/h property and all group shares listed in the form 395.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 21 sept. 1990
    Livré le 09 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each obligor (as defied therein) to the chargee as security agent for itself and for the "banks" (as defined therein) under the terms of each of the indebtendeness agreements the refincing agreements of even date and this charge.
    Brèves mentions
    All estates or interests in any f/h & l/h property. Also all group shores as specified in the form 395.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 04 juil. 1990
    Livré le 10 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each indebtedness agreement (as defined therein)
    Brèves mentions
    Al the bs shares held by the company and/or any nominees on its behalf and all related rights accruing to the bs shares see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1990Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0