IMPACT PACKAGING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIMPACT PACKAGING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01035892
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IMPACT PACKAGING LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe IMPACT PACKAGING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    100 Capability Green
    LU1 3LG Luton
    Bedfordshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de IMPACT PACKAGING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour IMPACT PACKAGING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    État du capital après une attribution d'actions au 03 janv. 2020

    • Capital: GBP 10,001
    8 pagesSH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 16 janv. 2020

    • Capital: GBP 2
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share premium account 03/01/2020
    RES13
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire B-R Secretariat Limited le 13 déc. 2016

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de Third Floor 4 Millbank London SW1P 3XR à 100 Capability Green Luton Bedfordshire LU1 3LG le 13 déc. 2016

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Christopher James Drummond en tant que directeur le 30 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard John Peachey en tant qu'administrateur le 30 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David William Gibson en tant que directeur le 30 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Philip James Hocken en tant qu'administrateur le 30 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juil. 2015

    État du capital au 16 juil. 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de IMPACT PACKAGING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    B-R SECRETARIAT LIMITED
    LU1 3LG Luton
    100 Capability Green
    Bedfordshire
    England
    Secrétaire
    LU1 3LG Luton
    100 Capability Green
    Bedfordshire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement957946
    33582140001
    HOCKEN, Philip James
    LU1 3LG Luton
    100 Capability Green
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    LU1 3LG Luton
    100 Capability Green
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish218278660001
    PEACHEY, Richard John
    LU1 3LG Luton
    100 Capability Green
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    LU1 3LG Luton
    100 Capability Green
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish126754290001
    CLOTHIER, Garry John
    Parkfield Rank
    Pucklechurch
    BS16 3NS Bristol
    The Old Schoolhouse
    Avon
    Secrétaire
    Parkfield Rank
    Pucklechurch
    BS16 3NS Bristol
    The Old Schoolhouse
    Avon
    British35984330002
    COURTMAN, John Charles
    Whitehouse Bassingfield Lane
    Bassingfield
    NG12 2LG Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Whitehouse Bassingfield Lane
    Bassingfield
    NG12 2LG Nottingham
    Nottinghamshire
    British54039780001
    MCLEOD, Iain Mitchell
    28 Abbey Avenue
    AL3 4AZ St Albans
    Secrétaire
    28 Abbey Avenue
    AL3 4AZ St Albans
    British11460270001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Oakwoods
    Sawpit Lane
    PE28 5QS Hamerton
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Oakwoods
    Sawpit Lane
    PE28 5QS Hamerton
    Cambridgeshire
    British79449700001
    BULL, Stuart Alan
    Wingletang Old Farm Road
    TW12 3RJ Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    Wingletang Old Farm Road
    TW12 3RJ Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritish3970950002
    COURTMAN, John Charles
    Whitehouse Bassingfield Lane
    Bassingfield
    NG12 2LG Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Whitehouse Bassingfield Lane
    Bassingfield
    NG12 2LG Nottingham
    Nottinghamshire
    British54039780001
    DRUMMOND, Christopher James
    Third Floor 4 Millbank
    London
    SW1P 3XR
    Administrateur
    Third Floor 4 Millbank
    London
    SW1P 3XR
    United KingdomBritish181784100001
    GIBSON, David William
    Third Floor 4 Millbank
    London
    SW1P 3XR
    Administrateur
    Third Floor 4 Millbank
    London
    SW1P 3XR
    EnglandBritish48081800006
    JONES, David Eric Ashton
    3 Manor Way
    SG6 3NJ Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Manor Way
    SG6 3NJ Letchworth
    Hertfordshire
    British11169250003
    MITCHELL, Anthony Charles George
    Trent House
    Cliff Drive
    NG12 1AX Radcliffe On Trent
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Trent House
    Cliff Drive
    NG12 1AX Radcliffe On Trent
    Nottinghamshire
    British39347560001
    MORAN, Wayham Hutcheson
    13 Adderstone Crescent
    NE2 2HH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    13 Adderstone Crescent
    NE2 2HH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish69362640001
    PARTLETT, Gareth Roy
    2 Richmond Court
    Repton
    DE65 6WS Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    2 Richmond Court
    Repton
    DE65 6WS Derby
    Derbyshire
    British29208780001
    UPCRAFT, Stephen Keith
    3 School Lane
    South Normanton
    DE55 3LA Alfreton
    Derbyshire
    Administrateur
    3 School Lane
    South Normanton
    DE55 3LA Alfreton
    Derbyshire
    British29208790001
    WATSON, David John
    4 Ferngrove Close
    Lower Road
    KT22 9EQ Fetcham
    Surrey
    Administrateur
    4 Ferngrove Close
    Lower Road
    KT22 9EQ Fetcham
    Surrey
    EnglandBritish73130590001
    BERKELEY NOMINEES LTD
    Third Floor
    4 Millbank
    SW1P 3XR London
    Administrateur
    Third Floor
    4 Millbank
    SW1P 3XR London
    51491190002
    REXAM PACKAGING LIMITED
    9th Floor West 114 Knightsbridge
    SW1X 7NN London
    Administrateur
    9th Floor West 114 Knightsbridge
    SW1X 7NN London
    49652140001
    REXAM UK HOLDINGS LIMITED
    Third Floor
    4 Millbank
    SW1P 3XR London
    Administrateur
    Third Floor
    4 Millbank
    SW1P 3XR London
    70215200001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IMPACT PACKAGING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    4 Millbank
    SW1P 3XR London
    Third Floor
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    4 Millbank
    SW1P 3XR London
    Third Floor
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00191285
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    IMPACT PACKAGING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 17 nov. 1986
    Livré le 24 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & premises at heanor gate road,smalley derbyshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 14 nov. 1986
    Livré le 24 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H delves road, heanor gate, heanor, derbyshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 16 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 mars 1982
    Livré le 22 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital, tog. With all fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery (see doc. M24).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 09 mars 1982
    Livré le 22 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and factory premises at delves road, heanor gate industrial estate, heanor derbyshire as comprised in 2 conveyances dated 24/4/73 and 25/03/75.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Single debenture
    Créé le 24 mars 1981
    Livré le 26 mars 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land l/h properties present and future with fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant and machinery goodwill and uncalled capital present and future undertaking and all other property and assets present and future including heritable property and assets in scotland, fixed and floating charge (please see doc M18).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1981Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 14 déc. 1979
    Livré le 04 janv. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal deed dated 18/5/73, the further charge dated 27/3/75 and this charge.
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage on property comprised in a principal deed dated 18/5/73. further charge of 27/3/75 with payment of all principal sums interest & other moneys paybale by the company as the borrower. The property being charged in the said principal deed, further charge & charge of 14/12/79 being all that the company's premises & f/h land in the parish of smalley in the county of derby & situate to the ne. Side of delves road, heanor gate industrial estate, heanor, derbyshire. (See doc M17).
    Personnes ayant droit
    • The Derbyshire County Council
    Transactions
    • 04 janv. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0