IMPACT PACKAGING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | IMPACT PACKAGING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01035892 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe IMPACT PACKAGING LIMITED ?
| Adresse du siège social | 100 Capability Green LU1 3LG Luton Bedfordshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de IMPACT PACKAGING LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour IMPACT PACKAGING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 03 janv. 2020
| 8 pages | SH01 | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 16 janv. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2019 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2018 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire B-R Secretariat Limited le 13 déc. 2016 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Third Floor 4 Millbank London SW1P 3XR à 100 Capability Green Luton Bedfordshire LU1 3LG le 13 déc. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher James Drummond en tant que directeur le 30 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Richard John Peachey en tant qu'administrateur le 30 sept. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de David William Gibson en tant que directeur le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Philip James Hocken en tant qu'administrateur le 30 sept. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de IMPACT PACKAGING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-R SECRETARIAT LIMITED | Secrétaire | LU1 3LG Luton 100 Capability Green Bedfordshire England |
| 33582140001 | ||||||||||
| HOCKEN, Philip James | Administrateur | LU1 3LG Luton 100 Capability Green Bedfordshire England | United Kingdom | British | 218278660001 | |||||||||
| PEACHEY, Richard John | Administrateur | LU1 3LG Luton 100 Capability Green Bedfordshire England | United Kingdom | British | 126754290001 | |||||||||
| CLOTHIER, Garry John | Secrétaire | Parkfield Rank Pucklechurch BS16 3NS Bristol The Old Schoolhouse Avon | British | 35984330002 | ||||||||||
| COURTMAN, John Charles | Secrétaire | Whitehouse Bassingfield Lane Bassingfield NG12 2LG Nottingham Nottinghamshire | British | 54039780001 | ||||||||||
| MCLEOD, Iain Mitchell | Secrétaire | 28 Abbey Avenue AL3 4AZ St Albans | British | 11460270001 | ||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Administrateur | Oakwoods Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Cambridgeshire | British | 79449700001 | ||||||||||
| BULL, Stuart Alan | Administrateur | Wingletang Old Farm Road TW12 3RJ Hampton Middlesex | United Kingdom | British | 3970950002 | |||||||||
| COURTMAN, John Charles | Administrateur | Whitehouse Bassingfield Lane Bassingfield NG12 2LG Nottingham Nottinghamshire | British | 54039780001 | ||||||||||
| DRUMMOND, Christopher James | Administrateur | Third Floor 4 Millbank London SW1P 3XR | United Kingdom | British | 181784100001 | |||||||||
| GIBSON, David William | Administrateur | Third Floor 4 Millbank London SW1P 3XR | England | British | 48081800006 | |||||||||
| JONES, David Eric Ashton | Administrateur | 3 Manor Way SG6 3NJ Letchworth Hertfordshire | British | 11169250003 | ||||||||||
| MITCHELL, Anthony Charles George | Administrateur | Trent House Cliff Drive NG12 1AX Radcliffe On Trent Nottinghamshire | British | 39347560001 | ||||||||||
| MORAN, Wayham Hutcheson | Administrateur | 13 Adderstone Crescent NE2 2HH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 69362640001 | |||||||||
| PARTLETT, Gareth Roy | Administrateur | 2 Richmond Court Repton DE65 6WS Derby Derbyshire | British | 29208780001 | ||||||||||
| UPCRAFT, Stephen Keith | Administrateur | 3 School Lane South Normanton DE55 3LA Alfreton Derbyshire | British | 29208790001 | ||||||||||
| WATSON, David John | Administrateur | 4 Ferngrove Close Lower Road KT22 9EQ Fetcham Surrey | England | British | 73130590001 | |||||||||
| BERKELEY NOMINEES LTD | Administrateur | Third Floor 4 Millbank SW1P 3XR London | 51491190002 | |||||||||||
| REXAM PACKAGING LIMITED | Administrateur | 9th Floor West 114 Knightsbridge SW1X 7NN London | 49652140001 | |||||||||||
| REXAM UK HOLDINGS LIMITED | Administrateur | Third Floor 4 Millbank SW1P 3XR London | 70215200001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IMPACT PACKAGING LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rexam Plc | 06 avr. 2016 | 4 Millbank SW1P 3XR London Third Floor United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
IMPACT PACKAGING LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 17 nov. 1986 Livré le 24 nov. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land & premises at heanor gate road,smalley derbyshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 nov. 1986 Livré le 24 nov. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H delves road, heanor gate, heanor, derbyshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 09 mars 1982 Livré le 22 mars 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital, tog. With all fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery (see doc. M24). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 09 mars 1982 Livré le 22 mars 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land and factory premises at delves road, heanor gate industrial estate, heanor derbyshire as comprised in 2 conveyances dated 24/4/73 and 25/03/75. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Single debenture | Créé le 24 mars 1981 Livré le 26 mars 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land l/h properties present and future with fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant and machinery goodwill and uncalled capital present and future undertaking and all other property and assets present and future including heritable property and assets in scotland, fixed and floating charge (please see doc M18). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 14 déc. 1979 Livré le 04 janv. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal deed dated 18/5/73, the further charge dated 27/3/75 and this charge. | |
Brèves mentions By way of legal mortgage on property comprised in a principal deed dated 18/5/73. further charge of 27/3/75 with payment of all principal sums interest & other moneys paybale by the company as the borrower. The property being charged in the said principal deed, further charge & charge of 14/12/79 being all that the company's premises & f/h land in the parish of smalley in the county of derby & situate to the ne. Side of delves road, heanor gate industrial estate, heanor, derbyshire. (See doc M17). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0