LIKEMIND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLIKEMIND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01042104
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LIKEMIND LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe LIKEMIND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Avon House Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8TS London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LIKEMIND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CRATON LODGE & KNIGHT COMPANY23 déc. 200423 déc. 2004
    CRATON LODGE & KNIGHT COMPANY LIMITED11 févr. 197211 févr. 1972

    Quels sont les derniers comptes de LIKEMIND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour LIKEMIND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 mai 2011

    État du capital au 04 mai 2011

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Cessation de la nomination de Christopher Wood en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Christopher Wood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Wood en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Adam Kilgour en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Brian Lindsay Bickmore en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Brendan York en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de Brian Lindsay Bickmore en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Hughes en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Matthew Bailey en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Nicholas Jefferson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Nicholas Philip Jefferson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Nicholas Philip Jefferson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Lake en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    30 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re agreement 04/11/2009
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    5 pages363a

    Qui sont les dirigeants de LIKEMIND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    YORK, Brendan
    155 George Street
    Sydney
    Level 9
    Nsw 2000
    Australia
    Secrétaire
    155 George Street
    Sydney
    Level 9
    Nsw 2000
    Australia
    British154651940001
    BICKMORE, Brian Lindsay
    George Street
    2000 Sydney
    Lelel 9 155
    Australia
    Administrateur
    George Street
    2000 Sydney
    Lelel 9 155
    Australia
    AustraliaAustralianChairman155178120001
    BICKMORE, Brian Lindsay
    155 George Street
    FOREIGN Sydney
    Level 9
    N.S.W.2000
    Australia
    Administrateur
    155 George Street
    FOREIGN Sydney
    Level 9
    N.S.W.2000
    Australia
    Australia, VicAustralianChairman154317180001
    JEFFERSON, Nicholas Philip
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8TS London
    Avon House
    Administrateur
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8TS London
    Avon House
    EnglandBritishDirector149201270001
    SIMSON, Michael David
    60 Stile Hall Gardens
    Chiswick
    W4 3BU London
    Secrétaire
    60 Stile Hall Gardens
    Chiswick
    W4 3BU London
    Irish5233630002
    WALFORD, Anthony Nigel
    20 Baronsfield Road
    TW1 2QU Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    20 Baronsfield Road
    TW1 2QU Twickenham
    Middlesex
    BritishCompany Director77239920001
    WALFORD, Anthony Nigel
    20 Baronsfield Road
    TW1 2QU Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    20 Baronsfield Road
    TW1 2QU Twickenham
    Middlesex
    BritishAccountant77239920001
    WOOD, Christopher Hereward Vaughan, Mr.
    3 Stowe Road
    W12 8BQ London
    Secrétaire
    3 Stowe Road
    W12 8BQ London
    BritishCompany Director5233690001
    WYLEY, Hannah Marie
    23 Thornbury Road
    TW7 4LQ Isleworth
    Middlesex
    Secrétaire
    23 Thornbury Road
    TW7 4LQ Isleworth
    Middlesex
    Irish47271690004
    BAILEY, Matthew William
    4 Marlborough Street
    Surrey Hills
    Victoria 3127
    Australia
    Administrateur
    4 Marlborough Street
    Surrey Hills
    Victoria 3127
    Australia
    AustraliaAustralianDirector125271290001
    BENNETT, Stephen Scott
    50 West Hill
    Sanderstead
    CR2 0SA South Croydon
    Surrey
    Administrateur
    50 West Hill
    Sanderstead
    CR2 0SA South Croydon
    Surrey
    BritishChartered Accountant8689150001
    HUGHES, Timothy James
    37 Telegraph Road
    Pymble
    New South Wales 2071
    Australia
    Administrateur
    37 Telegraph Road
    Pymble
    New South Wales 2071
    Australia
    AustraliaAustralianDirector125273770001
    INSKIP, Irene Mary
    Little Hinton
    Hinton Road
    RG10 0BT Hurst
    Berkshire
    Administrateur
    Little Hinton
    Hinton Road
    RG10 0BT Hurst
    Berkshire
    BritishMarketing Consultant37644220003
    JEFFERSON, Nicholas Philip
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8TS London
    Avon House
    Administrateur
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8TS London
    Avon House
    EnglandBritishDirector149201270001
    KILGOUR, Adam Mckenzie
    25 Park Avenue
    Mosman
    New South Wales
    Australia
    Administrateur
    25 Park Avenue
    Mosman
    New South Wales
    Australia
    AustraliaAustralianDirector125270320001
    LAKE, Simon Charles
    1 Manor Cottages
    The Street
    TN33 0QG Sedlescombe
    East Sussex
    Administrateur
    1 Manor Cottages
    The Street
    TN33 0QG Sedlescombe
    East Sussex
    EnglandBritishCompany Director109785980001
    LEVY, Michael
    17 Mervyn Road
    W13 9UW London
    Administrateur
    17 Mervyn Road
    W13 9UW London
    BritishMarketing Consultant5233650002
    LEVY, Michael
    6 The Crescent
    Cricklewood
    NW2 6HA London
    Administrateur
    6 The Crescent
    Cricklewood
    NW2 6HA London
    BritishCompany Director5233650001
    LODGE, Creenagh Margaret
    Flat 7 56 Holland Park
    W11 3RS London
    Administrateur
    Flat 7 56 Holland Park
    W11 3RS London
    EnglandBritishCompany Director52602850001
    NORMAN, Tod
    42 Westbury Road
    N12 7PD London
    Administrateur
    42 Westbury Road
    N12 7PD London
    AmericanDirector59199460001
    RUFFELL, Bridget Mary Anne
    Bell Yard
    6a Doctors Commons Road
    HP4 3DW Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Bell Yard
    6a Doctors Commons Road
    HP4 3DW Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director5233670004
    SHAW, Peter John Edward
    79 Wendell Road
    W12 9SB London
    Administrateur
    79 Wendell Road
    W12 9SB London
    United KingdomBritishCompany Director50294470003
    SIMSON, Michael David
    60 Stile Hall Gardens
    Chiswick
    W4 3BU London
    Administrateur
    60 Stile Hall Gardens
    Chiswick
    W4 3BU London
    EnglandIrishChartered Accountant5233630002
    SWALWELL, Susan
    7 Park Gate
    Mount Avenue
    W5 1PX London
    Administrateur
    7 Park Gate
    Mount Avenue
    W5 1PX London
    BritishCompany Director39988140001
    WALFORD, Anthony Nigel
    20 Baronsfield Road
    TW1 2QU Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    20 Baronsfield Road
    TW1 2QU Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant77239920001
    WOOD, Christopher Hereward Vaughan, Mr.
    3 Stowe Road
    W12 8BQ London
    Administrateur
    3 Stowe Road
    W12 8BQ London
    United KingdomBritishCompany Director5233690001
    ZAMBUNI, Richard
    42 Shelgate Road
    SW11 1BG London
    Administrateur
    42 Shelgate Road
    SW11 1BG London
    BritishCompany Director5233700001

    LIKEMIND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 nov. 2009
    Livré le 23 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Australia and New Zealand Banking Group Limited
    Transactions
    • 23 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 23 avr. 1997
    Livré le 01 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 01 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 23 avr. 1997
    Livré le 01 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities now due or to become due from the company and each obligor to the chargee pursuant to the terms of the financing documents (as defined) and this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 oct. 1991
    Livré le 01 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1991Enregistrement d'une charge
    • 06 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 mai 1989
    Livré le 02 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H- part of basement, third, fourth and fifth floors of 149 hammersmith road, hammersmith.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 janv. 1989
    Livré le 24 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets prsent and future including bookdebts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 22 déc. 1988
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on book debts
    Créé le 13 juil. 1988
    Livré le 28 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 06 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0