EDLAW NO. 7 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEDLAW NO. 7 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01043892
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EDLAW NO. 7 LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe EDLAW NO. 7 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bettws Road
    Llangeinor
    CF32 8PL Bridgend
    Mid Glamorgan
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EDLAW NO. 7 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    R F D LEASEHOLDS LIMITED25 févr. 197225 févr. 1972

    Quels sont les derniers comptes de EDLAW NO. 7 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour EDLAW NO. 7 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Cessation de la nomination de David Richard Howells en tant que directeur le 30 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Richard Howells en tant que secrétaire le 30 déc. 2011

    1 pagesTM02

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 févr. 2011

    État du capital au 11 févr. 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Richard Howells le 27 déc. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire David Richard Howells le 27 déc. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Deborah Janet Wilkinson le 27 déc. 2010

    2 pagesCH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2010 au 30 juin 2010

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Comptes établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    Comptes établis au 31 mars 2008

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 mars 2007

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 mars 2006

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de EDLAW NO. 7 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILKINSON, Deborah Janet
    Bettws Road
    Llangeinor
    CF32 8PL Bridgend
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    Bettws Road
    Llangeinor
    CF32 8PL Bridgend
    Mid Glamorgan
    United KingdomBritishFinance Director88411860004
    BOLTER, Roger Christopher
    Sheepleys
    Llandow
    CF71 7PA Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Secrétaire
    Sheepleys
    Llandow
    CF71 7PA Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    BritishAccountant78969400005
    HOAD, Geoffrey Douglas
    23 North Street
    CM6 1AZ Great Dunmow
    Essex
    Secrétaire
    23 North Street
    CM6 1AZ Great Dunmow
    Essex
    British48622020001
    HOWELLS, David Richard
    Bettws Road
    Llangeinor
    CF32 8PL Bridgend
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    Bettws Road
    Llangeinor
    CF32 8PL Bridgend
    Mid Glamorgan
    BritishAssnt Grp Financial Director110640670001
    WILKINSON, Deborah Janet
    Heol Y Cwrt
    North Cornelly
    CF33 4AX Bridgend
    43
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    Heol Y Cwrt
    North Cornelly
    CF33 4AX Bridgend
    43
    Mid Glamorgan
    BritishFinancial Controller88411860003
    WILMAN, David John
    Kylemore 4 The Cranagh
    Warren Road
    BT21 0ET Donaghadee
    Secrétaire
    Kylemore 4 The Cranagh
    Warren Road
    BT21 0ET Donaghadee
    British22174080002
    WILMAN, David John
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    British22174080001
    BOLTER, Roger Christopher
    Sheepleys
    Llandow
    CF71 7PA Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    Sheepleys
    Llandow
    CF71 7PA Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritishAccountant78969400005
    EARP, John
    43 Church Meadows
    BT25 1LZ Dromore
    County Down
    Administrateur
    43 Church Meadows
    BT25 1LZ Dromore
    County Down
    BritishChartered Accountant67307010002
    HOWELLS, David Richard
    Bettws Road
    Llangeinor
    CF32 8PL Bridgend
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    Bettws Road
    Llangeinor
    CF32 8PL Bridgend
    Mid Glamorgan
    WalesBritishAssnt Grp Financial Director110640670001
    MCCHESNEY, William Samuel
    3 Hampton Court
    BT38 9DT Carrickfergus
    County Antrim
    Administrateur
    3 Hampton Court
    BT38 9DT Carrickfergus
    County Antrim
    United KingdomBritishDirector69155740001
    NUWAR, David
    12 Penarth Portway
    CF64 1SQ Penarth
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    12 Penarth Portway
    CF64 1SQ Penarth
    Vale Of Glamorgan
    BritishDirector112290260001
    TAYLOR, Brian Reginald
    The Manor
    Marten
    SN8 3SJ Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    The Manor
    Marten
    SN8 3SJ Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director2197890003
    THOMAS, Philip
    57 Bryneglwys Gardens
    CF36 5PR Porthcawl
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    57 Bryneglwys Gardens
    CF36 5PR Porthcawl
    Mid Glamorgan
    BritishManaging Director95171100001
    WILMAN, David John
    Kylemore 4 The Cranagh
    Warren Road
    BT21 0ET Donaghadee
    Administrateur
    Kylemore 4 The Cranagh
    Warren Road
    BT21 0ET Donaghadee
    United KingdomBritishCompany Director22174080002

    EDLAW NO. 7 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security deed of accession
    Créé le 20 févr. 2002
    Livré le 01 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the obligors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Other Finance Parties (The "Security Agent ")
    Transactions
    • 01 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 janv. 2002
    Livré le 12 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) in any currency whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including land and premises at kingsway,dunmurry,belfast; la 393060; land and premises at 1,2 and 3 beaufort rd,birkenhead, ms 278694; land and premises at brunel rd,newton abbot,devon; dn 113225; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,London as Security Trustee for Itself and Theother Finance Parties
    Transactions
    • 12 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture of even date between troyess PLC (the parent) edlaw PLC (the company) the companies listed in the schedule 1 of the debenture (the charging companies) and the chargee
    Créé le 27 avr. 2001
    Livré le 08 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the subordinated finance documents (as defined) on any account
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security deed of accession to a debenture dated 17 november 1999 as amended by a deed of amendment dated 26 january 2000 and a deed of accession and amendment dated 15 march 2000
    Créé le 17 mars 2000
    Livré le 05 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities due or to become due from the company and each of the obligors to the chargee under the finance documents (or any of them) and this debenture and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The key properties together with all buildings and fixtures (as defined). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dlj Capital Funding, Inc. as Security Agent on Behalf of Itself and Other Secured Parties
    Transactions
    • 05 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0