GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED

GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGBC (UNITED KINGDOM) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01056410
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    IBICO LIMITED31 mai 197231 mai 1972

    Quels sont les derniers comptes de GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem and capital contribution reserve 09/08/2021
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 11 août 2021

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Katherine Alexandra Spence le 10 mai 2021

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Katherine Alexandra Spence le 10 mai 2021

    1 pagesCH03

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Accounts approved, company not required to hold a general meeting 29/01/2021
    RES13

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Christopher Neil Hopkinson en tant qu'administrateur le 05 juin 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Katherine Alexandra Spence en tant qu'administrateur le 05 juin 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Walter Joe Thomas en tant que directeur le 22 mai 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Katherine Alexandra Spence en tant que secrétaire le 05 juin 2020

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Robert Michael Grimes en tant que secrétaire le 01 juin 2020

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 pagesPSC08

    Nomination de Mr Robert Michael Grimes en tant que secrétaire le 30 avr. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Christopher Neil Hopkinson en tant que directeur le 30 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PRIOR, Katherine Alexandra
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    270502710002
    HOPKINSON, Christopher Neil, Mr.
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant270498480001
    PRIOR, Katherine Alexandra
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Secretary248359400002
    BARKER, Ruth
    77 The Crofts
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    77 The Crofts
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    BritishFinancial Controller99632990001
    DOVER, Paul William
    Silverdale Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    Silverdale Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    BritishFinance Director48335550001
    EVANS, Paul William Hywel
    38 Inkpen Gardens
    RG24 8YQ Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    38 Inkpen Gardens
    RG24 8YQ Basingstoke
    Hampshire
    BritishAccountant80520290001
    GEDDIE, Richard Mark
    15 Pine Grove
    Bricket Wood
    AL2 3ST St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    15 Pine Grove
    Bricket Wood
    AL2 3ST St. Albans
    Hertfordshire
    British80783870001
    GRIMES, Robert Michael
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    245928620001
    MORRIS, Ruth Margaret
    61 Wordsworth Road
    TW12 1EW Hampton
    Middlesex
    Secrétaire
    61 Wordsworth Road
    TW12 1EW Hampton
    Middlesex
    BritishFinance Manager39201870001
    VALE, Ronald Edward
    5 Ashwood Drive
    BH18 8LN Broadstone
    Dorset
    Secrétaire
    5 Ashwood Drive
    BH18 8LN Broadstone
    Dorset
    British5033030001
    ATTRIDGE, David Roy
    40 Meadowridge
    Hatch Warren
    RG22 4QH Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    40 Meadowridge
    Hatch Warren
    RG22 4QH Basingstoke
    Hampshire
    BritishCompany Director56376820002
    BEERKENS, Michel Antoon Victor
    Geldropseweg 19
    Heeze 5591ea
    Netherlands
    Administrateur
    Geldropseweg 19
    Heeze 5591ea
    Netherlands
    DutchEuropean Financial Controller80928430002
    DAVIES, Emma Susan
    Lawn Hill Cottage
    OX17 1ET Claydon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Lawn Hill Cottage
    OX17 1ET Claydon
    Oxfordshire
    United KingdomBritishVp Finance Europe126575640001
    DOVER, Paul William
    Silverdale Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Silverdale Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director48335550001
    EVANS, Paul William Hywel
    38 Inkpen Gardens
    RG24 8YQ Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    38 Inkpen Gardens
    RG24 8YQ Basingstoke
    Hampshire
    BritishAccountant80520290001
    FIRTH, Stephen
    2 Lansdowne Road
    Frimley
    GU16 5UW Camberley
    Surrey
    Administrateur
    2 Lansdowne Road
    Frimley
    GU16 5UW Camberley
    Surrey
    BritishCompany Director56829340001
    GEDDIE, Richard Mark
    Bricket Wood
    AL2 3ST St Albans
    15 Pine Grove
    Herts
    England
    Administrateur
    Bricket Wood
    AL2 3ST St Albans
    15 Pine Grove
    Herts
    England
    EnglandBritishAccountant80783870001
    GREEN, Howard Benjamin
    1325 North Sutton Place
    60610 Chicago
    Illinois
    Usa
    Administrateur
    1325 North Sutton Place
    60610 Chicago
    Illinois
    Usa
    AmericanCompany Director57046060002
    GUEST, Richard Hamilton
    7 Townshend Road
    TW9 1XH Richmond
    Administrateur
    7 Townshend Road
    TW9 1XH Richmond
    EnglandBritishVp European Finance122869580001
    HOPKINSON, Christopher Neil, Mr.
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector270498480001
    MOSELEY, Elizabeth Violet
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Oxford House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Oxford House
    Buckinghamshire
    EnglandBritishSenior Vice President Sales193913710001
    MUGRIDGE, Ellis John
    58 Wentworth Crescent
    RG22 4WX Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    58 Wentworth Crescent
    RG22 4WX Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishEuropean Sales Director115153160001
    MUNK, Peter
    58 Geffers Ride
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    58 Geffers Ride
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    United KingdomDanishDirector112581070001
    PAGE, Andrew Stephen
    Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    29
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    29
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritishDirector86557080001
    REDDY, Govi
    14 Long Meadow Drive
    60010 Barrington Hills
    Illinois
    Usa
    Administrateur
    14 Long Meadow Drive
    60010 Barrington Hills
    Illinois
    Usa
    AmericanCompany Director57046400001
    RUBIN, Steven
    4 Norbert Drive
    Hawthorn Woods
    Illinois 60047
    Usa
    Administrateur
    4 Norbert Drive
    Hawthorn Woods
    Illinois 60047
    Usa
    AmericanVp Secretary & General Counsel56376640004
    STENEBRING, Thomas
    Av. Des Alouettes 50
    Rhode-St-Genese
    B-1640
    Belgium
    Administrateur
    Av. Des Alouettes 50
    Rhode-St-Genese
    B-1640
    Belgium
    SwedishPresident71744640001
    THEIL FARTH, Rainer Erwin
    9 Brampton Chase
    Lower Shiplake
    RG9 3BX Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    9 Brampton Chase
    Lower Shiplake
    RG9 3BX Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishManaging Director39201670001
    THOMAS, Walter Joe, Dr
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishSolicitor217919870001
    WOLFENSBERGER, Ulrich Andreas, Dr
    Seestrasse 79
    FOREIGN Rushlikon Zh 8803
    Switzerland
    Administrateur
    Seestrasse 79
    FOREIGN Rushlikon Zh 8803
    Switzerland
    SwissCompany Director11149790001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    01 janv. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 sept. 2009
    Livré le 08 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the other foreign credit parties to the lender creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 08 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 sept. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 30 déc. 2003
    Livré le 03 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited (Security Holder)
    Transactions
    • 03 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 mars 2001
    Livré le 28 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 15 déc. 1997
    Livré le 22 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 15 avr. 1996
    Livré le 18 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all the deposit(s) being all sums of money in any currency (a) deposited or paid by the company to the credit of the account(s) with the bank re: ibico LTD business premium account no. 80389226 and/or any additional and/or substitute account(s) opened with the bank (b) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company and (c) respresenting the renewal or replacement of or for any sums deposited or paid or held as aforesaid, together with all interest accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of transfer
    Créé le 15 févr. 1996
    Livré le 06 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the debenture
    Brèves mentions
    All freehold and leasehold property of the company situate in england and wales. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The First National Bank of Chicago
    Transactions
    • 06 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 12 avr. 1995
    Livré le 24 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all deposits as shown in the schedule and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 avr. 1994
    Livré le 22 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Nbd Bank N.A.
    Transactions
    • 22 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 28 oct. 1991
    Livré le 07 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0