ABX LOGISTICS (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéABX LOGISTICS (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01060116
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ABX LOGISTICS (UK) LIMITED ?

    • (6340) /

    Où se situe ABX LOGISTICS (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cardinal House
    46 St Nicholas Street
    IP1 1TT Ipswich
    Suffolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ABX LOGISTICS (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AVANDERO (UK) LIMITED03 juil. 197203 juil. 1972

    Quels sont les derniers comptes de ABX LOGISTICS (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour ABX LOGISTICS (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 oct. 2011

    7 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Scandinavia House Refinery Road Parkeston Harwich Essex CO12 4QG le 18 oct. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 08 oct. 2010

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Derek Gibson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Rene Olesen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    19 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Rene Falch Olesen le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gary Maurice Ridsdale le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Derek Ian Gibson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Gary Maurice Ridsdale le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Statuts

    14 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de ABX LOGISTICS (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RIDSDALE, Gary Maurice
    46 St Nicholas Street
    IP1 1TT Ipswich
    Cardinal House
    Suffolk
    Secrétaire
    46 St Nicholas Street
    IP1 1TT Ipswich
    Cardinal House
    Suffolk
    Other56040610001
    RIDSDALE, Gary Maurice
    46 St Nicholas Street
    IP1 1TT Ipswich
    Cardinal House
    Suffolk
    Administrateur
    46 St Nicholas Street
    IP1 1TT Ipswich
    Cardinal House
    Suffolk
    EnglandOtherAccountant56040610001
    MORRALL, John Stephen
    30 Aylestone Avenue
    Brondesbury Park
    NW6 7AA London
    Secrétaire
    30 Aylestone Avenue
    Brondesbury Park
    NW6 7AA London
    British38122710002
    WEST, Derek Buckle
    11 Ashdown Road
    KT17 3PL Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    11 Ashdown Road
    KT17 3PL Epsom
    Surrey
    British7273770001
    BAMELIS, Herwig Paul
    Zeedijk Centrum Odk 0472 0104
    Koksijde
    8670
    Belgium
    Administrateur
    Zeedijk Centrum Odk 0472 0104
    Koksijde
    8670
    Belgium
    BelgianCompany Director79946880001
    BOITO, Gebhard
    27 Rowan Walk
    RM11 2JA Hornchurch
    Essex
    Administrateur
    27 Rowan Walk
    RM11 2JA Hornchurch
    Essex
    EnglandItalianFreight Forwarder48526870002
    BOSCHETTI, Gianfranco
    Via Della Moscova 46/1
    Milan
    Italy
    Administrateur
    Via Della Moscova 46/1
    Milan
    Italy
    ItalianCompany Executive14661130001
    DERMAUX, Jean Louise
    9 Wolvenheide
    1861 Wolverten
    Belgium
    Administrateur
    9 Wolvenheide
    1861 Wolverten
    Belgium
    BelgianCo Director75310690001
    GERMINIANI, Gianfranco
    6 The Dene
    Clevelands
    W13 8AY London
    Administrateur
    6 The Dene
    Clevelands
    W13 8AY London
    ItalianCompany Director14597960001
    GEYSELS, Kris Paul Ludo
    Dennenstraat 19
    Aarschot
    3200
    Belgium
    Administrateur
    Dennenstraat 19
    Aarschot
    3200
    Belgium
    BelgianCompany Director79654300001
    GIBSON, Derek Ian
    Refinery Road
    Parkeston
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    Administrateur
    Refinery Road
    Parkeston
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    EnglandBritishCompany Director17527120004
    MALLINSON, Clive Beresford
    Loch Fern Lodge
    DG5 4PL Dalbeattie
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    Loch Fern Lodge
    DG5 4PL Dalbeattie
    Kirkcudbrightshire
    BritishDirector14597970002
    MARSHALL, Lee James
    159 Wingletye Lane
    RM11 3AR Hornchurch
    Essex
    Administrateur
    159 Wingletye Lane
    RM11 3AR Hornchurch
    Essex
    EnglandBritishCompany Director90902270001
    OLESEN, Rene Falch
    Refinery Road
    Parkeston
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    Administrateur
    Refinery Road
    Parkeston
    CO12 4QG Harwich
    Scandinavia House
    Essex
    EnglandDanishDirector65581140002
    PATEL, Rajnikant Jivanji
    Oakmead Oakleigh Road
    Hatch End
    HA5 4HB Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    Oakmead Oakleigh Road
    Hatch End
    HA5 4HB Pinner
    Middlesex
    BritishFinancial Director14661140001
    PRESTON, Alwin Kenneth
    The Croft Church Lane
    Barnwell
    PE8 5PG Peterborough
    Administrateur
    The Croft Church Lane
    Barnwell
    PE8 5PG Peterborough
    BritishDirector43996690001
    SCHLAUSCH, Hans Jurgen
    Upper Borg 28
    FOREIGN Bremen
    28357
    Germany
    Administrateur
    Upper Borg 28
    FOREIGN Bremen
    28357
    Germany
    GermanManaging Director101107440001
    SCHOUPPE, Etienne Adolf
    Kerselarlaan 17
    FOREIGN Liedekerke
    Belgium 1770
    Administrateur
    Kerselarlaan 17
    FOREIGN Liedekerke
    Belgium 1770
    BelgiamCompany Director75359460001
    WILKINSON, Paul William
    74 School Road
    CM11 1QN Downham
    Essex
    Administrateur
    74 School Road
    CM11 1QN Downham
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director147265280001
    WOUTERS, Paul Bert Leo
    Vromenhove 23
    Zwijndrecht
    2070
    Belgium
    Administrateur
    Vromenhove 23
    Zwijndrecht
    2070
    Belgium
    BelgianDirector82767720001

    ABX LOGISTICS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A security over cash collateral accounts agreement
    Créé le 16 août 2006
    Livré le 29 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the deposit being the credit balance from time to time in respect of the account and all rights benefits and proceeds in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.a/N.V. as Security Agent for the Opco Secured Parties (The Security Agent)
    • Fortis Bank S.a/N.V. as Security Agent for the Opco Secured Parties (The Security Agent)
    Transactions
    • 29 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security over collection accounts agreement
    Créé le 03 août 2006
    Livré le 17 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from teh company to any opco secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in each deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 17 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A disclosed deed of pledge of bank accounts (second ranking)
    Créé le 03 août 2006
    Livré le 17 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A right of pledge over all its rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.a/N.A. (The Pledgee)
    Transactions
    • 17 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security assignment over receivables agreement
    Créé le 03 août 2006
    Livré le 17 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to becoem due from the company to any opco secured party on any accountw hatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in under and to the receivables together with all claims and causes in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 17 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge on book and other debts
    Créé le 29 avr. 2005
    Livré le 10 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge all book debts and other debts of the company present and future and the proceeds of payment or realisation of each of them.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Rent deposit deed
    Créé le 24 sept. 2003
    Livré le 08 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £6,462.50.
    Personnes ayant droit
    • Garrick Developments Limited
    Transactions
    • 08 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 2003
    Livré le 08 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings lying to the north east of huntingdon road (now known as halden parkway) thrapston east northamptonshire t/n NN171461. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 22 nov. 2002
    Livré le 26 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Cash deposit of £260,300.
    Personnes ayant droit
    • Anglo St James (Basildon) Limited
    Transactions
    • 26 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 02 déc. 1994
    Livré le 09 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with a facility letter dated 25TH october 1994
    Brèves mentions
    Plot 3 aimi link thrapston northamptonshire and/or the proceeds of sale thereof the goodwill and the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ABX LOGISTICS (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 févr. 2012Dissolved on
    08 oct. 2010Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven M Law
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp Abbotsgate House
    Hollow Road
    IP32 7FA Bury St Edmunds
    Suffolk
    practitioner
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp Abbotsgate House
    Hollow Road
    IP32 7FA Bury St Edmunds
    Suffolk

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0