MOLECULAR PROPERTIES LIMITED

MOLECULAR PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMOLECULAR PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01065581
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MOLECULAR PROPERTIES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe MOLECULAR PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Parkway
    Harlow Business Park
    CM19 5FR Harlow
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MOLECULAR PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MOLECULAR PRODUCTS LIMITED01 sept. 198801 sept. 1988
    M.P. UNITED DRUG COMPANY LIMITED31 déc. 197931 déc. 1979
    MCKERNAN CHEMICAL DEVELOPMENTS LIMITED11 août 197211 août 1972

    Quels sont les derniers comptes de MOLECULAR PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour MOLECULAR PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    6 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Catherine Clark Mckernan en tant que directeur le 05 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 03 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2017

    2 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher David Laws en tant que secrétaire le 19 sept. 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 03 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2015

    État du capital au 20 août 2015

    • Capital: GBP 125,000
    SH01

    Satisfaction de la charge 010655810010 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 010655810011 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 010655810012 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 août 2014

    État du capital au 11 août 2014

    • Capital: GBP 125,000
    SH01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04

    Nomination de Ruth Mckernan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Stuart Mckernan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Inscription de la charge 010655810012

    10 pagesMR01

    Inscription de la charge 010655810010

    25 pagesMR01

    Inscription de la charge 010655810011

    10 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 août 2013

    État du capital au 16 août 2013

    • Capital: GBP 125,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de MOLECULAR PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCKERNAN, Andrew Clark
    Old Barn Park Farm
    Park Street
    CM6 2ND Thaxted
    Essex
    Administrateur
    Old Barn Park Farm
    Park Street
    CM6 2ND Thaxted
    Essex
    United KingdomBritishManaging Director92679650001
    MCKERNAN, Ian William
    24 Borough Lane
    CB11 4AG Saffron Walden
    Bannold
    Essex
    Administrateur
    24 Borough Lane
    CB11 4AG Saffron Walden
    Bannold
    Essex
    EnglandBritishChairman14023560007
    MCKERNAN, Ruth Mitchell
    Harlow Business Park
    CM19 5FR Harlow
    Parkway
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    Harlow Business Park
    CM19 5FR Harlow
    Parkway
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Scientific Officer190075490001
    MCKERNAN, Stuart
    Harlow Business Park
    CM19 5FR Harlow
    Parkway
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    Harlow Business Park
    CM19 5FR Harlow
    Parkway
    Essex
    United Kingdom
    United StatesBritishMaterials Scientist186542660001
    BEARD, James David
    8 Church Field
    CB11 4BG Saffron Walden
    Essex
    Secrétaire
    8 Church Field
    CB11 4BG Saffron Walden
    Essex
    BritishCompany Accountant25609870001
    IGNATIUS, Rishanthan Jude
    15 Friary Way
    N12 9PE London
    Secrétaire
    15 Friary Way
    N12 9PE London
    BritishDirector62521430001
    LAWS, Christopher David
    Harlow Business Park
    CM19 5FR Harlow
    Parkway
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Harlow Business Park
    CM19 5FR Harlow
    Parkway
    Essex
    United Kingdom
    176877310001
    MCKERNAN, Andrew Clark
    Old Barn Park Farm
    Park Street
    CM6 2ND Thaxted
    Essex
    Secrétaire
    Old Barn Park Farm
    Park Street
    CM6 2ND Thaxted
    Essex
    BritishManaging Director92679650001
    MCKERNAN, Andrew Clark
    Old Barn Park Farm
    Park Street
    CM6 2ND Thaxted
    Essex
    Secrétaire
    Old Barn Park Farm
    Park Street
    CM6 2ND Thaxted
    Essex
    BritishCommercial Director92679650001
    MCKERNAN, Catherine Clark
    The Old Manse 55 Audley Road
    CB11 3HD Saffron Walden
    Essex
    Secrétaire
    The Old Manse 55 Audley Road
    CB11 3HD Saffron Walden
    Essex
    British14023550001
    WALLS, Jerome Stewart
    31 Northgate Street
    IP33 1HY Bury St Edmunds
    Suffolk
    Secrétaire
    31 Northgate Street
    IP33 1HY Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishDirector45112610001
    ADDISON, John
    1 Elms Close
    Duxford
    CB2 4RD Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    1 Elms Close
    Duxford
    CB2 4RD Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishWorks Director14132720001
    BEARD, James David
    8 Church Field
    CB11 4BG Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    8 Church Field
    CB11 4BG Saffron Walden
    Essex
    BritishCompany Accountant25609870001
    CRICKMORE, Graham Thomas
    32 Wallace Binder Close
    CM9 6LG Maldon
    Essex
    Administrateur
    32 Wallace Binder Close
    CM9 6LG Maldon
    Essex
    BritishMarketing Director20177240002
    MAHON, Michael
    38 Lyndhurst Drive
    TN13 2HQ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    38 Lyndhurst Drive
    TN13 2HQ Sevenoaks
    Kent
    BritishSales Director42197840001
    MCKERNAN, Catherine Clark
    7 Butler Close
    CB11 3DB Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    7 Butler Close
    CB11 3DB Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishDirector14023550002
    MCKERNAN, Catherine Clark
    The Old Manse 55 Audley Road
    CB11 3HD Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    The Old Manse 55 Audley Road
    CB11 3HD Saffron Walden
    Essex
    BritishSecretary14023550001
    MCKERNAN, William Mitchell, Dr
    The Old Manse 55 Audley Road
    CB11 3HD Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    The Old Manse 55 Audley Road
    CB11 3HD Saffron Walden
    Essex
    BritishIndustrial Consultant14023580001
    MCKERNAN, William Mitchell, Dr
    The Old Manse 55 Audley Road
    CB11 3HD Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    The Old Manse 55 Audley Road
    CB11 3HD Saffron Walden
    Essex
    BritishIndustrial Consultant14023580001
    REYNOLDS, Andrew Kinsey
    Sticklynch Manor West Pennard
    Glastonbury
    Somerset
    Administrateur
    Sticklynch Manor West Pennard
    Glastonbury
    Somerset
    BritishConsultant14132710001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MOLECULAR PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Risa Developments Ltd
    Parkway, Harlow Business Park
    CM19 5FR Harlow
    Molecular
    England
    06 avr. 2016
    Parkway, Harlow Business Park
    CM19 5FR Harlow
    Molecular
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement09170664
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    MOLECULAR PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 28 oct. 2013
    Livré le 30 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H property k/a land at claypits farm, thaxted t/no EX414870. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 30 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 21 oct. 2013
    Livré le 23 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H the maltings mill end thaxted dunmow t/no EX659279. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 23 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 21 oct. 2013
    Livré le 23 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 23 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 2009
    Livré le 04 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property claypits farm thaxted essex t/no EX414870 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 2009
    Livré le 04 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a the maltings mill end thaxted essex t/no EX659279 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 04 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 08 janv. 2001
    Livré le 10 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H mill end thaxted essex CM6 2LT. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 30 nov. 2000
    Livré le 07 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a mill end thaxted essex CM6 2LT. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture deed
    Créé le 06 nov. 2000
    Livré le 09 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 25 sept. 2000
    Livré le 28 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at claypits farm thaxted essex EX414870. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 09 oct. 1987
    Livré le 13 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 14 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1982
    Livré le 09 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land known as the maltings, mill end thaxted in the county of essex. Heriditaments and premises situate and known.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0