KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKOSSWAY AUTOMATICS WESTERN
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 01069441
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?

    Adresse du siège social
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KOSSWAY AUTOMATICS (WESTERN) LIMITED04 sept. 197204 sept. 1972

    Quels sont les derniers comptes de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2018

    14 pagesAA

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 20 déc. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    5 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 18/10/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Steven John Holmes en tant que directeur le 22 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stewart Frank Bradley Baker en tant qu'administrateur le 21 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 sept. 2016

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 sept. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juil. 2015

    État du capital au 24 juil. 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 sept. 2014

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de James William O'halleran en tant que directeur le 02 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James William O'halleran en tant que directeur le 02 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Steven John Holmes en tant qu'administrateur le 24 mars 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Luke Lyon Alvarez en tant que directeur le 24 mars 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Steven John Holmes en tant que secrétaire le 23 mars 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Carys Damon en tant que secrétaire le 23 mars 2015

    2 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 sept. 2013

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 août 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 06 août 2013

    SH01

    Qui sont les dirigeants de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAMON, Carys
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    196165700001
    BAKER, Stewart Frank Bradley
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish230753770001
    ALBION, Susan
    7 Brownsfield Road
    WS13 6BT Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    7 Brownsfield Road
    WS13 6BT Lichfield
    Staffordshire
    British80142740001
    CONWAY, Mark
    Lanaway 14 Cranford Avenue
    EX8 2HT Exmouth
    Devon
    Secrétaire
    Lanaway 14 Cranford Avenue
    EX8 2HT Exmouth
    Devon
    British17198720001
    HOLMES, Steven John
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    British80455940002
    KOSS, Gerald
    62 Montagu Road
    Datchet
    SL3 9DY Slough
    Berkshire
    Secrétaire
    62 Montagu Road
    Datchet
    SL3 9DY Slough
    Berkshire
    British17198710001
    OLDHAM, Annette
    Edwards Farm Road
    Fradley
    WS13 8NR Lichfield
    29
    Staffordshire
    Secrétaire
    Edwards Farm Road
    Fradley
    WS13 8NR Lichfield
    29
    Staffordshire
    British135120610001
    PAGE, David
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    British31059170002
    STANDEN, Reginald James
    7 Warrington Spur
    Old Windsor
    SL4 2NF Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    7 Warrington Spur
    Old Windsor
    SL4 2NF Windsor
    Berkshire
    British36981610002
    ALVAREZ, Luke Lyon
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish63436630003
    BEER, Brian Leslie
    52 Meadow View
    Rolleston On Dove
    DE13 9AN Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    52 Meadow View
    Rolleston On Dove
    DE13 9AN Burton On Trent
    Staffordshire
    British61154670001
    BOARDLEY, Richard Owen
    13 Sandalwood Road
    LE11 3PR Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    13 Sandalwood Road
    LE11 3PR Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish48134520001
    CHILDS, Mervyn Peter
    Riverdale
    Lower High Street
    DE13 9LU Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Riverdale
    Lower High Street
    DE13 9LU Burton On Trent
    Staffordshire
    British4619870002
    CHINN, Neil
    12 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    12 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish61154190002
    CONWAY, Mark
    Lanaway 14 Cranford Avenue
    EX8 2HT Exmouth
    Devon
    Administrateur
    Lanaway 14 Cranford Avenue
    EX8 2HT Exmouth
    Devon
    British17198720001
    CONWAY, Paul Frederick
    32 Queens Acre
    Kings Road
    SL4 2BE Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    32 Queens Acre
    Kings Road
    SL4 2BE Windsor
    Berkshire
    British35400650002
    CONWAY, Raymond Edward
    106 Belmont Rise
    Belmont
    SM2 6EE Sutton
    Surrey
    Administrateur
    106 Belmont Rise
    Belmont
    SM2 6EE Sutton
    Surrey
    British34840600001
    DAY, John Michael
    27 Newfield Lane
    S17 3DB Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    27 Newfield Lane
    S17 3DB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish69255730001
    HARRISON, Gerald Edward
    57 Furlong Lane
    Alrewas
    DE13 7EE Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    57 Furlong Lane
    Alrewas
    DE13 7EE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish47602430001
    HOLMES, Steven John
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish196165310001
    HOYLE, Russell Blackburn
    5 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Administrateur
    5 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    EnglandBritish52822380002
    KOSS, Gerald
    62 Montagu Road
    Datchet
    SL3 9DY Slough
    Berkshire
    Administrateur
    62 Montagu Road
    Datchet
    SL3 9DY Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish17198710001
    LANGLEY, Paul
    9 Besbury Close
    Dorridge
    B93 8NT Solihull
    Administrateur
    9 Besbury Close
    Dorridge
    B93 8NT Solihull
    EnglandBritish99802010001
    MASSEY, Timothy John
    Chestnut Cottage Silver Lane
    Marchington
    ST14 8LL Uttoxeter
    Staffordshire
    Administrateur
    Chestnut Cottage Silver Lane
    Marchington
    ST14 8LL Uttoxeter
    Staffordshire
    United KingdomBritish100259370001
    O'HALLERAN, James William
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish103876820003
    PAGE, David
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish31059170002
    SIMON, Christopher Neil
    89 Ella Road
    West Bridgford
    NG2 5GZ Nottingham
    Administrateur
    89 Ella Road
    West Bridgford
    NG2 5GZ Nottingham
    EnglandBritish95528490001
    SMITH, Keith Ian
    Wythtree
    Manor Park
    DE13 7JA Kings Bromley
    Staffordshire
    Administrateur
    Wythtree
    Manor Park
    DE13 7JA Kings Bromley
    Staffordshire
    United KingdomBritish40284060002
    WITHERS, Roger Dean
    Ivy Cottage The Green
    Dinton
    HP17 8UP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ivy Cottage The Green
    Dinton
    HP17 8UP Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish29586130001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Inspired Gaming (Uk) Limited
    The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton-On-Trent
    3
    Staffordshire
    England
    06 avr. 2016
    The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton-On-Trent
    3
    Staffordshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company (Ltd)
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Acts 1985 To 1989
    Lieu d'enregistrementUk Register Of Private Limited Companies
    Numéro d'enregistrement03565640
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of amendment and restatement to a composite guarantee and debenture dated 3RD august 1998 (the "deed")
    Créé le 26 mars 1999
    Livré le 10 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness and liabilities and obligations due owing or incurred pursuant to the revolving credit facility, the mezzanine loan facility and that part of the term loan facility not used to repay indebtedness due under the facilities agreement to the chargee by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Brèves mentions
    L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 (for further details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Security Beneficiaries)(the "Security Trustee")
    Transactions
    • 10 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 03 août 1998
    Livré le 20 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due pursuant to the revolving credit facility to the security beneficiaries by any group company on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 déc. 1979
    Livré le 14 déc. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) together with fixed plant from time to time thereof.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 14 déc. 1979Enregistrement d'une charge
    • 31 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0