KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN
Vue d'ensemble
| Nom de la société | KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | 01069441 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?
| Adresse du siège social | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2018 | 14 pages | AA | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 déc. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Steven John Holmes en tant que directeur le 22 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Stewart Frank Bradley Baker en tant qu'administrateur le 21 sept. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 24 sept. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 26 sept. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 sept. 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de James William O'halleran en tant que directeur le 02 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de James William O'halleran en tant que directeur le 02 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Steven John Holmes en tant qu'administrateur le 24 mars 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Luke Lyon Alvarez en tant que directeur le 24 mars 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Steven John Holmes en tant que secrétaire le 23 mars 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Mrs Carys Damon en tant que secrétaire le 23 mars 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 sept. 2013 | 1 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMON, Carys | Secrétaire | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | 196165700001 | |||||||
| BAKER, Stewart Frank Bradley | Administrateur | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 230753770001 | |||||
| ALBION, Susan | Secrétaire | 7 Brownsfield Road WS13 6BT Lichfield Staffordshire | British | 80142740001 | ||||||
| CONWAY, Mark | Secrétaire | Lanaway 14 Cranford Avenue EX8 2HT Exmouth Devon | British | 17198720001 | ||||||
| HOLMES, Steven John | Secrétaire | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | British | 80455940002 | ||||||
| KOSS, Gerald | Secrétaire | 62 Montagu Road Datchet SL3 9DY Slough Berkshire | British | 17198710001 | ||||||
| OLDHAM, Annette | Secrétaire | Edwards Farm Road Fradley WS13 8NR Lichfield 29 Staffordshire | British | 135120610001 | ||||||
| PAGE, David | Secrétaire | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | British | 31059170002 | ||||||
| STANDEN, Reginald James | Secrétaire | 7 Warrington Spur Old Windsor SL4 2NF Windsor Berkshire | British | 36981610002 | ||||||
| ALVAREZ, Luke Lyon | Administrateur | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 63436630003 | |||||
| BEER, Brian Leslie | Administrateur | 52 Meadow View Rolleston On Dove DE13 9AN Burton On Trent Staffordshire | British | 61154670001 | ||||||
| BOARDLEY, Richard Owen | Administrateur | 13 Sandalwood Road LE11 3PR Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 48134520001 | |||||
| CHILDS, Mervyn Peter | Administrateur | Riverdale Lower High Street DE13 9LU Burton On Trent Staffordshire | British | 4619870002 | ||||||
| CHINN, Neil | Administrateur | 12 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 61154190002 | |||||
| CONWAY, Mark | Administrateur | Lanaway 14 Cranford Avenue EX8 2HT Exmouth Devon | British | 17198720001 | ||||||
| CONWAY, Paul Frederick | Administrateur | 32 Queens Acre Kings Road SL4 2BE Windsor Berkshire | British | 35400650002 | ||||||
| CONWAY, Raymond Edward | Administrateur | 106 Belmont Rise Belmont SM2 6EE Sutton Surrey | British | 34840600001 | ||||||
| DAY, John Michael | Administrateur | 27 Newfield Lane S17 3DB Sheffield South Yorkshire | England | British | 69255730001 | |||||
| HARRISON, Gerald Edward | Administrateur | 57 Furlong Lane Alrewas DE13 7EE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 47602430001 | |||||
| HOLMES, Steven John | Administrateur | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | England | British | 196165310001 | |||||
| HOYLE, Russell Blackburn | Administrateur | 5 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | 52822380002 | |||||
| KOSS, Gerald | Administrateur | 62 Montagu Road Datchet SL3 9DY Slough Berkshire | United Kingdom | British | 17198710001 | |||||
| LANGLEY, Paul | Administrateur | 9 Besbury Close Dorridge B93 8NT Solihull | England | British | 99802010001 | |||||
| MASSEY, Timothy John | Administrateur | Chestnut Cottage Silver Lane Marchington ST14 8LL Uttoxeter Staffordshire | United Kingdom | British | 100259370001 | |||||
| O'HALLERAN, James William | Administrateur | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | England | British | 103876820003 | |||||
| PAGE, David | Administrateur | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | England | British | 31059170002 | |||||
| SIMON, Christopher Neil | Administrateur | 89 Ella Road West Bridgford NG2 5GZ Nottingham | England | British | 95528490001 | |||||
| SMITH, Keith Ian | Administrateur | Wythtree Manor Park DE13 7JA Kings Bromley Staffordshire | United Kingdom | British | 40284060002 | |||||
| WITHERS, Roger Dean | Administrateur | Ivy Cottage The Green Dinton HP17 8UP Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 29586130001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspired Gaming (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton-On-Trent 3 Staffordshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
KOSSWAY AUTOMATICS WESTERN a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of amendment and restatement to a composite guarantee and debenture dated 3RD august 1998 (the "deed") | Créé le 26 mars 1999 Livré le 10 avr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All indebtedness and liabilities and obligations due owing or incurred pursuant to the revolving credit facility, the mezzanine loan facility and that part of the term loan facility not used to repay indebtedness due under the facilities agreement to the chargee by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Brèves mentions L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 (for further details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 03 août 1998 Livré le 20 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due pursuant to the revolving credit facility to the security beneficiaries by any group company on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 04 déc. 1979 Livré le 14 déc. 1979 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) together with fixed plant from time to time thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0