BMI MARINE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBMI MARINE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01073947
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BMI MARINE LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe BMI MARINE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BMI MARINE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MERVEST (NO. 18) LIMITED27 sept. 197227 sept. 1972

    Quels sont les derniers comptes de BMI MARINE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BMI MARINE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BMI MARINE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 1 Churchill Place London E14 5HP

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Churchill Plaza Churchill Way Basingstoke Hampshire RG21 7GP le 08 juil. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:special resolution ;- "books.records.etc"
    2 pagesLIQ MISC RES

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:special resolution ;- "in specie"
    2 pagesLIQ MISC RES

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Cessation de la nomination de Hazel Anne Marie Watson en tant que directeur le 19 mars 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Duncan John Rowberry en tant que directeur le 23 déc. 2013

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 sept. 2013

    État du capital au 12 sept. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    26 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 20 août 2013 au 31 déc. 2012

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 21 mars 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 20 août 2012

    27 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2012 au 20 août 2012

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de BMI MARINE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARCOSEC LIMITED
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Secrétaire
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2223143
    147523260001
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritishAccountant169142800001
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritishAccountant69140360004
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secrétaire
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishChartered Accountant68601920003
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secrétaire
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    BritishFinance Director92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    BritishFinance Dircetor47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Administrateur
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director2444200001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Administrateur
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    BritishFinancial Controller46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Administrateur
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishBanker121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritishFinance Director147858890001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    BritishHead Of Business Services25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishChartered Accountant68601920003
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritishAccountant108439150001
    PATTERSON, Mark Allan
    6 Vespasian Gardens
    RG24 9SH Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    6 Vespasian Gardens
    RG24 9SH Basingstoke
    Hampshire
    BritishFinancial Management71785630001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritishAccountant155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishAccountant143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    BritishTreasurer49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritishChartered Accountant49237880004
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    BritishCertified Accountant32895910001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrishChartered Accountant122291210001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    Administrateur
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    BritishChartered Accountant71785600001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    BritishAccountant40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    BritishChartered Accountant58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    BMI MARINE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Ship mortgage
    Créé le 29 oct. 1982
    Livré le 29 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from shell international petroleum company limited to the chargee on an account current under the terms of deed of covenant 29-10-82 and demise charter 30-1-79
    Brèves mentions
    64/64 shares in M. S. "isocardia" registered at the post of london with official no 703216 and in her boats guns ammunition, small arms and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • United States Trust Company of New York.
    Transactions
    • 29 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenants
    Créé le 29 oct. 1982
    Livré le 29 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due or to become due from shell international petroleum company limited to the chargee secured by a mortgage to a demise charter dated 30 jan 1979 and all other monies due under the deed of covenant dated 29-10-82
    Brèves mentions
    All right title and interest, present and future of the mortgagor in and to 1) m s "isocardia" registred at the port of london official no 703216 2) the "ancillary benefits" as defined in the deed of covenants.
    Personnes ayant droit
    • United States Trust Company of New York
    Transactions
    • 29 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenants
    Créé le 30 avr. 1982
    Livré le 30 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due ot to become due form shell international petroleum company limited to the chargee charter dated 30 jan 1979 and secured by a mortgage dated 30 april 1982
    Brèves mentions
    All right title and interest present and future of the mortgage in and to 1) m s isomeria registered at the port of london official number 399061 2) the ancillary benefits as defined in the deed of covenant.
    Personnes ayant droit
    • United States Trust Company of New York
    Transactions
    • 30 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Statutory mortgage
    Créé le 30 avr. 1982
    Livré le 30 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from shell international petroleum company limited to the chargee on an account current under the terms of a demise charter dated 30 jan 1979 and a deed of covenant dated 30/04/1982
    Brèves mentions
    64/64 shares in ms isomeriad registered at the part of london with official no 399061 and in her boats guns ammunition small arms and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • United States Trust Company of New York
    Transactions
    • 30 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    BMI MARINE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 juin 2014Commencement of winding up
    09 déc. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0