POLARON MANUFACTURING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | POLARON MANUFACTURING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01078182 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe POLARON MANUFACTURING LIMITED ?
Adresse du siège social | Usk House Llantarnam Park NP44 3HD Cwmbran Gwent |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de POLARON MANUFACTURING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour POLARON MANUFACTURING LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour POLARON MANUFACTURING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 14 nov. 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 15 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2012 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mark Grenelle Bunker en tant qu'administrateur le 11 juin 2013 | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Terrance Valentine Helz en tant que directeur le 01 mai 2013 | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Terrance Valentine Helz en tant que secrétaire le 01 mai 2013 | 2 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 14 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Robert John Davies le 01 avr. 2013 | 3 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Simon Sparrow le 19 déc. 2012 | 3 pages | CH01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de John Boyd Reed en tant que directeur le 30 nov. 2012 | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2011 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 16 pages | AR01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 16 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2010 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Boyd Reed le 08 juin 2010 | 3 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2009 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 16 pages | AR01 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 2 pages | AD03 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de POLARON MANUFACTURING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOGADO NOMINEES LIMITED | Secrétaire | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 73539350001 | |||||||
BUNKER, Mark Grenelle | Administrateur | Highway 74 South Peachtree City 1121 Ga 30269 Usa | Usa | United States | Business Executive | 179348620001 | ||||
DAVIES, Robert John | Administrateur | Llantarnam Park NP44 3HD Cwmbran Usk House Gwent United Kingdom | Wales | British | Business Executive | 108633390001 | ||||
SPARROW, Simon Ellis | Administrateur | Greenhill Crescent Watford Business Park WD18 8JA Watford 20 Herts United Kingdom | England | English | Director | 100179990002 | ||||
BROOKS, Patricia Mary | Secrétaire | Ty Ffynnon Pant Glas Rudry CF83 3EJ Caerphilly | British | 12433900003 | ||||||
CLOUGH, Jonathan | Secrétaire | 26 Moor Road HP5 1SE Chesham Buckinghamshire | British | Director | 82903760001 | |||||
FENWICK, Christopher | Secrétaire | 3 Court Lodge Shenley WD7 9DU Radlett Hertfordshire | British | 12433910001 | ||||||
HELZ, Terrance Valentine | Secrétaire | 11 China Rose Court The Woodlands Texas 77381 Usa | American | Attorney | 61652840001 | |||||
PRIOR, Michael | Secrétaire | 41 Portman Place Bethnal Green E2 0LG London | British | Accountant | 73780640003 | |||||
SEARLE, Fraser Wyman | Secrétaire | 92 Creighton Avenue N10 1NT London | British | Director | 67395910001 | |||||
BROOKS, Peter Howard Edward | Administrateur | Ty Ffynnon Pant Glas Rudry CF83 3EJ Caerphilly | Wales | British | Chartered Elect Engineer | 12433930003 | ||||
CATTERALL, David Michael | Administrateur | 178 Malvern Avenue Rayners Lane HA2 9HD Harrow Middlesex | British | Sales Director | 60071500001 | |||||
CLOUGH, Jonathan | Administrateur | 26 Moor Road HP5 1SE Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 82903760001 | ||||
EALES, Graham | Administrateur | The Flat The Retreat Little Wentwood Farm MP15 1ND Usk Monmouthshire | New Zealand | Sales & Marketing | 77983370001 | |||||
FENWICK, Christopher | Administrateur | 3 Court Lodge Shenley WD7 9DU Radlett Hertfordshire | England | British | Production Engineer | 12433910001 | ||||
HELZ, Terrance Valentine | Administrateur | 11 China Rose Court The Woodlands Texas 77381 Usa | United States | American | Attorney | 61652840001 | ||||
PRIOR, Michael | Administrateur | 41 Portman Place Bethnal Green E2 0LG London | British | Accountant | 73780640003 | |||||
REED, John Boyd | Administrateur | Travis, Suite 5600 Houston 600 Texas 77002 Usa | Usa | United States | Business Executive | 119272520002 | ||||
SEARLE, Fraser Wyman | Administrateur | 92 Creighton Avenue N10 1NT London | England | British | Director | 67395910001 | ||||
ST JOHN LLOYD, Frederick George | Administrateur | 11 Faraday Drive Shenley Lodge MK5 7DD Milton Keynes Buckinghamshire | British | Sales Director | 12433920001 | |||||
STELZER, Joseph Nigel David | Administrateur | 19 Holne Chase N2 0QL London | England | British | Director | 30607940005 | ||||
THORNTON-BROWN, Richard Mark | Administrateur | White Jade Grosmont NP7 8LW Abergavenny Gwent | British | Electrical Engineer | 12433940003 |
POLARON MANUFACTURING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of accession and charge | Créé le 22 juil. 2005 Livré le 12 août 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 09 sept. 2004 Livré le 29 sept. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge on all debts and related reights and floating charge on all other property | Créé le 11 juin 2001 Livré le 14 juin 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the factoring agreement dated 5 june 2001 | |
Brèves mentions By way of fixed charge specified debts any book debts all other debts by way of floating charge all the property companys stock in trade and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 mars 1999 Livré le 12 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of fixed charge all book debts and other debts ans the benefit of all contracts of insurance by way of floating charge the undertaking and all property and assets present and future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
First fixed and floating charge | Créé le 02 juil. 1997 Livré le 03 juil. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Fixed charge on all our book and other debts under an agreement dated 2 july 1997 and a floating charge on all proceeds of book and other debts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplementary legal charge | Créé le 30 nov. 1983 Livré le 15 déc. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the existing security documents | |
Brèves mentions Fixed charge on the book debts and other debts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 oct. 1980 Livré le 22 oct. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, boodebts & uncalled capital with all buildings, fixtures, fixed plant and machinery l/hold land and buildings at hart road, and pageant road, st albans, hertfordshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 27 juin 1978 Livré le 03 juil. 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land situate at hart road and pagaent rd st albans hertfordshire as comprised in a cease dated 8.5.78. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 30 sept. 1976 Livré le 10 juil. 1976 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital tog-with all buildings fixtures, fixed plant & machinery fixed & floating charges (see doc M15). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0