POLARON MANUFACTURING LIMITED

POLARON MANUFACTURING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPOLARON MANUFACTURING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01078182
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de POLARON MANUFACTURING LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe POLARON MANUFACTURING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Usk House
    Llantarnam Park
    NP44 3HD Cwmbran
    Gwent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de POLARON MANUFACTURING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ZERO 88 LIGHTING LIMITED24 oct. 197224 oct. 1972

    Quels sont les derniers comptes de POLARON MANUFACTURING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour POLARON MANUFACTURING LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour POLARON MANUFACTURING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 14 nov. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Reduce share premium and capital reserve 01/10/2014
    RES13

    Comptes établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Nomination de Mark Grenelle Bunker en tant qu'administrateur le 11 juin 2013

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Terrance Valentine Helz en tant que directeur le 01 mai 2013

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Terrance Valentine Helz en tant que secrétaire le 01 mai 2013

    2 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert John Davies le 01 avr. 2013

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Simon Sparrow le 19 déc. 2012

    3 pagesCH01

    Cessation de la nomination de John Boyd Reed en tant que directeur le 30 nov. 2012

    2 pagesTM01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2010

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Boyd Reed le 08 juin 2010

    3 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2009

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    2 pagesAD03

    Qui sont les dirigeants de POLARON MANUFACTURING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secrétaire
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    73539350001
    BUNKER, Mark Grenelle
    Highway 74 South
    Peachtree City
    1121
    Ga 30269
    Usa
    Administrateur
    Highway 74 South
    Peachtree City
    1121
    Ga 30269
    Usa
    UsaUnited StatesBusiness Executive179348620001
    DAVIES, Robert John
    Llantarnam Park
    NP44 3HD Cwmbran
    Usk House
    Gwent
    United Kingdom
    Administrateur
    Llantarnam Park
    NP44 3HD Cwmbran
    Usk House
    Gwent
    United Kingdom
    WalesBritishBusiness Executive108633390001
    SPARROW, Simon Ellis
    Greenhill Crescent
    Watford Business Park
    WD18 8JA Watford
    20
    Herts
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenhill Crescent
    Watford Business Park
    WD18 8JA Watford
    20
    Herts
    United Kingdom
    EnglandEnglishDirector100179990002
    BROOKS, Patricia Mary
    Ty Ffynnon Pant Glas
    Rudry
    CF83 3EJ Caerphilly
    Secrétaire
    Ty Ffynnon Pant Glas
    Rudry
    CF83 3EJ Caerphilly
    British12433900003
    CLOUGH, Jonathan
    26 Moor Road
    HP5 1SE Chesham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    26 Moor Road
    HP5 1SE Chesham
    Buckinghamshire
    BritishDirector82903760001
    FENWICK, Christopher
    3 Court Lodge
    Shenley
    WD7 9DU Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    3 Court Lodge
    Shenley
    WD7 9DU Radlett
    Hertfordshire
    British12433910001
    HELZ, Terrance Valentine
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    Secrétaire
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    AmericanAttorney61652840001
    PRIOR, Michael
    41 Portman Place
    Bethnal Green
    E2 0LG London
    Secrétaire
    41 Portman Place
    Bethnal Green
    E2 0LG London
    BritishAccountant73780640003
    SEARLE, Fraser Wyman
    92 Creighton Avenue
    N10 1NT London
    Secrétaire
    92 Creighton Avenue
    N10 1NT London
    BritishDirector67395910001
    BROOKS, Peter Howard Edward
    Ty Ffynnon Pant Glas
    Rudry
    CF83 3EJ Caerphilly
    Administrateur
    Ty Ffynnon Pant Glas
    Rudry
    CF83 3EJ Caerphilly
    WalesBritishChartered Elect Engineer12433930003
    CATTERALL, David Michael
    178 Malvern Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9HD Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    178 Malvern Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9HD Harrow
    Middlesex
    BritishSales Director60071500001
    CLOUGH, Jonathan
    26 Moor Road
    HP5 1SE Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    26 Moor Road
    HP5 1SE Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector82903760001
    EALES, Graham
    The Flat The Retreat
    Little Wentwood Farm
    MP15 1ND Usk
    Monmouthshire
    Administrateur
    The Flat The Retreat
    Little Wentwood Farm
    MP15 1ND Usk
    Monmouthshire
    New ZealandSales & Marketing77983370001
    FENWICK, Christopher
    3 Court Lodge
    Shenley
    WD7 9DU Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Court Lodge
    Shenley
    WD7 9DU Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishProduction Engineer12433910001
    HELZ, Terrance Valentine
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    Administrateur
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    United StatesAmericanAttorney61652840001
    PRIOR, Michael
    41 Portman Place
    Bethnal Green
    E2 0LG London
    Administrateur
    41 Portman Place
    Bethnal Green
    E2 0LG London
    BritishAccountant73780640003
    REED, John Boyd
    Travis, Suite 5600
    Houston
    600
    Texas 77002
    Usa
    Administrateur
    Travis, Suite 5600
    Houston
    600
    Texas 77002
    Usa
    UsaUnited StatesBusiness Executive119272520002
    SEARLE, Fraser Wyman
    92 Creighton Avenue
    N10 1NT London
    Administrateur
    92 Creighton Avenue
    N10 1NT London
    EnglandBritishDirector67395910001
    ST JOHN LLOYD, Frederick George
    11 Faraday Drive
    Shenley Lodge
    MK5 7DD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    11 Faraday Drive
    Shenley Lodge
    MK5 7DD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishSales Director12433920001
    STELZER, Joseph Nigel David
    19 Holne Chase
    N2 0QL London
    Administrateur
    19 Holne Chase
    N2 0QL London
    EnglandBritishDirector30607940005
    THORNTON-BROWN, Richard Mark
    White Jade
    Grosmont
    NP7 8LW Abergavenny
    Gwent
    Administrateur
    White Jade
    Grosmont
    NP7 8LW Abergavenny
    Gwent
    BritishElectrical Engineer12433940003

    POLARON MANUFACTURING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession and charge
    Créé le 22 juil. 2005
    Livré le 12 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 09 sept. 2004
    Livré le 29 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Polaron PLC
    Transactions
    • 29 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge on all debts and related reights and floating charge on all other property
    Créé le 11 juin 2001
    Livré le 14 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the factoring agreement dated 5 june 2001
    Brèves mentions
    By way of fixed charge specified debts any book debts all other debts by way of floating charge all the property companys stock in trade and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • First National Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 14 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mars 1999
    Livré le 12 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all book debts and other debts ans the benefit of all contracts of insurance by way of floating charge the undertaking and all property and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 12 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First fixed and floating charge
    Créé le 02 juil. 1997
    Livré le 03 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed charge on all our book and other debts under an agreement dated 2 july 1997 and a floating charge on all proceeds of book and other debts.
    Personnes ayant droit
    • Alex. Lawrie Receivables Financing Limited
    Transactions
    • 03 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 1999Enregistrement d'une charge
    Supplementary legal charge
    Créé le 30 nov. 1983
    Livré le 15 déc. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the existing security documents
    Brèves mentions
    Fixed charge on the book debts and other debts.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 15 déc. 1983Enregistrement d'une charge
    • 29 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 oct. 1980
    Livré le 22 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, boodebts & uncalled capital with all buildings, fixtures, fixed plant and machinery l/hold land and buildings at hart road, and pageant road, st albans, hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 22 oct. 1980Enregistrement d'une charge
    • 29 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 juin 1978
    Livré le 03 juil. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situate at hart road and pagaent rd st albans hertfordshire as comprised in a cease dated 8.5.78.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 03 juil. 1978Enregistrement d'une charge
    • 25 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 1976
    Livré le 10 juil. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital tog-with all buildings fixtures, fixed plant & machinery fixed & floating charges (see doc M15).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 10 juil. 1976Enregistrement d'une charge
    • 24 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0