RAKON EUROPE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRAKON EUROPE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01081678
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RAKON EUROPE LIMITED ?

    • Commerce de gros d'équipements électroniques et de télécommunications et de pièces détachées (46520) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe RAKON EUROPE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Dowsett House
    Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RAKON EUROPE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    C-MAC FREQUENCY PRODUCTS LIMITED12 août 199912 août 1999
    IQD LIMITED11 janv. 198311 janv. 1983
    INTERFACE QUARTZ DEVICES LIMITED14 nov. 197214 nov. 1972

    Quels sont les derniers comptes de RAKON EUROPE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour RAKON EUROPE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 27 déc. 2012

    • Capital: GBP 100
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Graham Rodney Leaming en tant que directeur le 21 nov. 2012

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    Résolutions

    Resolutions
    35 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    15 pagesAA

    Nomination de Mr Richard James Wilson en tant que secrétaire le 19 sept. 2011

    1 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de Mitre House 160 Aldersgate Street London EC1A 4DD United Kingdom le 19 sept. 2011

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Mitre Secretaries Limited en tant que secrétaire le 19 sept. 2011

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mitre Secretaries Limited le 14 mai 2011

    2 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de Mitre House 160 Aldersgate Street London EC1A 4DD Uk le 16 mai 2011

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mitre Secretaries Limited le 31 mai 2010

    2 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    19 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Darren Paul Robinson le 10 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Brent John Robinson le 10 mars 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de RAKON EUROPE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILSON, Richard James
    Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Dowsett House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Dowsett House
    United Kingdom
    163157870001
    ROBINSON, Brent John
    Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Dowsett House
    United Kingdom
    Administrateur
    Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Dowsett House
    United Kingdom
    New ZealandNew Zealander118898330001
    ROBINSON, Darren Paul
    Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Dowsett House
    United Kingdom
    Administrateur
    Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Dowsett House
    United Kingdom
    New ZealandNew Zealander118898410001
    ADAMS, Graham Paul
    Norcombe Hayes
    Toller Whelme
    DT8 3NU Beaminster
    Dorset
    Secrétaire
    Norcombe Hayes
    Toller Whelme
    DT8 3NU Beaminster
    Dorset
    British7800950002
    BENNETT, Jennifer Priscilla
    Blackdown View
    TA19 0BG Ilminster
    145
    Somerset
    England
    Secrétaire
    Blackdown View
    TA19 0BG Ilminster
    145
    Somerset
    England
    British130897890001
    BENNETT, Jennifer Priscilla
    Blackdown View
    TA19 0BG Ilminster
    145
    Somerset
    England
    Secrétaire
    Blackdown View
    TA19 0BG Ilminster
    145
    Somerset
    England
    British130897890001
    BENNETT, Jennifer Priscilla
    24 Hillingdon Court
    Abbey Manor Park
    BA21 3TA Yeovil
    Somerset
    Secrétaire
    24 Hillingdon Court
    Abbey Manor Park
    BA21 3TA Yeovil
    Somerset
    British102333220001
    CLARKE, Jonathan Charles
    13 Artisans Dwellings
    CB10 1LW Saffron Walden
    Essex
    Secrétaire
    13 Artisans Dwellings
    CB10 1LW Saffron Walden
    Essex
    British29117290001
    KEANEY, Dale Christian
    11 Bredon Road
    RG41 1HW Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    11 Bredon Road
    RG41 1HW Wokingham
    Berkshire
    British115465910001
    MCGREEVY, Kevin Dominic
    15 Rue Du Petit Musc
    Paris
    75004
    France
    Secrétaire
    15 Rue Du Petit Musc
    Paris
    75004
    France
    British94172630001
    PROVENCHER, Michael
    14 De Chantilly
    Candiac
    J5R 6C5 Quebec
    Canada
    Canada
    Secrétaire
    14 De Chantilly
    Candiac
    J5R 6C5 Quebec
    Canada
    Canada
    British50960100002
    RALPH, Duncan Stewart
    Hatfield
    The Avenue
    TA1 1ED Taunton
    Somerset
    Secrétaire
    Hatfield
    The Avenue
    TA1 1ED Taunton
    Somerset
    British94082570001
    ROBINSON, Hugh Alvaro
    Pilsdon Barn
    Pilsdon
    DT6 5NY Bridport
    Dorset
    Secrétaire
    Pilsdon Barn
    Pilsdon
    DT6 5NY Bridport
    Dorset
    British30161190001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    160
    Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House
    United Kingdom
    Secrétaire
    160
    Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1447749
    38565160001
    ADAMS, Graham Paul
    Norcombe Hayes
    Toller Whelme
    DT8 3NU Beaminster
    Dorset
    Administrateur
    Norcombe Hayes
    Toller Whelme
    DT8 3NU Beaminster
    Dorset
    UkBritish7800950002
    ANTELL, Brian Hamilton
    Bancrest
    57 Seaview Rise
    NR31 9SE Hopton On Sea
    Norfolk
    Administrateur
    Bancrest
    57 Seaview Rise
    NR31 9SE Hopton On Sea
    Norfolk
    British95428660001
    ARMSTRONG, Kathleen Mary
    Victoria Cottage 4 Shorts Lane
    DT8 3BD Beaminster
    Dorset
    Administrateur
    Victoria Cottage 4 Shorts Lane
    DT8 3BD Beaminster
    Dorset
    British7800960001
    BREESE, David
    89 Church Lane
    Eaton
    NR4 6NY Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    89 Church Lane
    Eaton
    NR4 6NY Norwich
    Norfolk
    British63749710001
    BROWN, David Edward
    8 Wicklands Road
    Hunsdon
    SG12 8PD Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Wicklands Road
    Hunsdon
    SG12 8PD Ware
    Hertfordshire
    British34247810001
    CARDOZO, Rebecca
    7 Arundel Court
    Jubilee Place
    SW3 3PJ London
    Administrateur
    7 Arundel Court
    Jubilee Place
    SW3 3PJ London
    British66350760002
    CLIFTON, Stuart
    The Orchard West Road
    Caister
    NR30 5TB Great Yarmouth
    Norfolk
    Administrateur
    The Orchard West Road
    Caister
    NR30 5TB Great Yarmouth
    Norfolk
    British101789820001
    EKPENYONG, Paul
    16 Marley Road
    AL7 4BS Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    16 Marley Road
    AL7 4BS Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55370400002
    FEAR, Paul Daniel
    The Coach House
    Yeabridge
    TA13 5LW South Petherton
    Somerset
    Administrateur
    The Coach House
    Yeabridge
    TA13 5LW South Petherton
    Somerset
    British7800970002
    HAYES, Perry Gustav
    3067 Bersano Court,
    Pleasanton
    California
    94566
    Usa
    Administrateur
    3067 Bersano Court,
    Pleasanton
    California
    94566
    Usa
    American94184150001
    KENYON, Peter Willaim
    33 Rye Gardens
    BA20 2TF Yeovil
    Somerset
    Administrateur
    33 Rye Gardens
    BA20 2TF Yeovil
    Somerset
    British41985750002
    LEAMING, Graham Rodney
    Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Dowsett House
    United Kingdom
    Administrateur
    Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Dowsett House
    United Kingdom
    New ZealandNew Zealand149616190001
    LEUNG, Julio Sze Wai
    3136 Pellara Ct
    Pleasanton
    California Ca 94566
    Usa
    Administrateur
    3136 Pellara Ct
    Pleasanton
    California Ca 94566
    Usa
    Usa86044270001
    LIGAN, Warren James
    2142 Hall Circle, Livermore
    California
    94550
    Usa
    Administrateur
    2142 Hall Circle, Livermore
    California
    94550
    Usa
    UsaAmerican94251260001
    MICHAEL, Woolley
    Llamedos Bews Lane
    Chard
    TA20 1JU Somerset
    Administrateur
    Llamedos Bews Lane
    Chard
    TA20 1JU Somerset
    British94319200003
    MUKERJEE, Indro Mario
    The Vine House
    Bushfield Road, Bovingdon
    HP3 0DR Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Vine House
    Bushfield Road, Bovingdon
    HP3 0DR Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritish111658220001
    OLDHAM, William Andrew
    12 Shenfield Place
    Shenfield
    CM15 9AG Brentwood
    Essex
    Administrateur
    12 Shenfield Place
    Shenfield
    CM15 9AG Brentwood
    Essex
    British11970760001
    RALPH, Duncan Stewart
    Hatfield
    The Avenue
    TA1 1ED Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Hatfield
    The Avenue
    TA1 1ED Taunton
    Somerset
    United KingdomBritish94082570001
    ROBINSON, Hugh Alvaro
    Pilsdon Barn
    Pilsdon
    DT6 5NY Bridport
    Dorset
    Administrateur
    Pilsdon Barn
    Pilsdon
    DT6 5NY Bridport
    Dorset
    United KingdomBritish30161190001
    ROBINSON, Susan Alexandra
    Pilsdon Barn
    Pilsdon
    DT6 5NY Bridport
    Dorset
    Administrateur
    Pilsdon Barn
    Pilsdon
    DT6 5NY Bridport
    Dorset
    British30161180001
    ROUND, Michael Andrew
    Lukes
    The Common
    SN8 1DL Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Lukes
    The Common
    SN8 1DL Marlborough
    Wiltshire
    EnglandEnglish40324810001

    RAKON EUROPE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 août 2007
    Livré le 29 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 18 oct. 2004
    Livré le 25 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 15 déc. 1994
    Livré le 16 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof.schedule:one new 5350/5400 crystal/oscillator plater machine,serial no:1557,together with ancillary equipment.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 16 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 23 sept. 1993
    Livré le 29 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge over all book debts,invoice debts,accounts,notes,bills and other forms all title property right and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Factors Limited
    Transactions
    • 29 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 15 sept. 1993
    Livré le 16 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mai 1988
    Livré le 01 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 26 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 15 juil. 1981
    Livré le 20 juil. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 08 août 1980
    Livré le 21 août 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 29 & 29A market street, crewkerre, somerset.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0