RAKON EUROPE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RAKON EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01081678 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RAKON EUROPE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Dowsett House Sadler Road LN6 3RS Lincoln United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RAKON EUROPE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour RAKON EUROPE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 27 déc. 2012
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Rodney Leaming en tant que directeur le 21 nov. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 35 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2011 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Richard James Wilson en tant que secrétaire le 19 sept. 2011 | 1 pages | AP03 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Mitre House 160 Aldersgate Street London EC1A 4DD United Kingdom le 19 sept. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mitre Secretaries Limited en tant que secrétaire le 19 sept. 2011 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mitre Secretaries Limited le 14 mai 2011 | 2 pages | CH04 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Mitre House 160 Aldersgate Street London EC1A 4DD Uk le 16 mai 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2010 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mitre Secretaries Limited le 31 mai 2010 | 2 pages | CH04 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2009 | 19 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Darren Paul Robinson le 10 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Brent John Robinson le 10 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de RAKON EUROPE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON, Richard James | Secrétaire | Sadler Road LN6 3RS Lincoln Dowsett House United Kingdom | 163157870001 | |||||||||||
| ROBINSON, Brent John | Administrateur | Sadler Road LN6 3RS Lincoln Dowsett House United Kingdom | New Zealand | New Zealander | 118898330001 | |||||||||
| ROBINSON, Darren Paul | Administrateur | Sadler Road LN6 3RS Lincoln Dowsett House United Kingdom | New Zealand | New Zealander | 118898410001 | |||||||||
| ADAMS, Graham Paul | Secrétaire | Norcombe Hayes Toller Whelme DT8 3NU Beaminster Dorset | British | 7800950002 | ||||||||||
| BENNETT, Jennifer Priscilla | Secrétaire | Blackdown View TA19 0BG Ilminster 145 Somerset England | British | 130897890001 | ||||||||||
| BENNETT, Jennifer Priscilla | Secrétaire | Blackdown View TA19 0BG Ilminster 145 Somerset England | British | 130897890001 | ||||||||||
| BENNETT, Jennifer Priscilla | Secrétaire | 24 Hillingdon Court Abbey Manor Park BA21 3TA Yeovil Somerset | British | 102333220001 | ||||||||||
| CLARKE, Jonathan Charles | Secrétaire | 13 Artisans Dwellings CB10 1LW Saffron Walden Essex | British | 29117290001 | ||||||||||
| KEANEY, Dale Christian | Secrétaire | 11 Bredon Road RG41 1HW Wokingham Berkshire | British | 115465910001 | ||||||||||
| MCGREEVY, Kevin Dominic | Secrétaire | 15 Rue Du Petit Musc Paris 75004 France | British | 94172630001 | ||||||||||
| PROVENCHER, Michael | Secrétaire | 14 De Chantilly Candiac J5R 6C5 Quebec Canada Canada | British | 50960100002 | ||||||||||
| RALPH, Duncan Stewart | Secrétaire | Hatfield The Avenue TA1 1ED Taunton Somerset | British | 94082570001 | ||||||||||
| ROBINSON, Hugh Alvaro | Secrétaire | Pilsdon Barn Pilsdon DT6 5NY Bridport Dorset | British | 30161190001 | ||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom |
| 38565160001 | ||||||||||
| ADAMS, Graham Paul | Administrateur | Norcombe Hayes Toller Whelme DT8 3NU Beaminster Dorset | Uk | British | 7800950002 | |||||||||
| ANTELL, Brian Hamilton | Administrateur | Bancrest 57 Seaview Rise NR31 9SE Hopton On Sea Norfolk | British | 95428660001 | ||||||||||
| ARMSTRONG, Kathleen Mary | Administrateur | Victoria Cottage 4 Shorts Lane DT8 3BD Beaminster Dorset | British | 7800960001 | ||||||||||
| BREESE, David | Administrateur | 89 Church Lane Eaton NR4 6NY Norwich Norfolk | British | 63749710001 | ||||||||||
| BROWN, David Edward | Administrateur | 8 Wicklands Road Hunsdon SG12 8PD Ware Hertfordshire | British | 34247810001 | ||||||||||
| CARDOZO, Rebecca | Administrateur | 7 Arundel Court Jubilee Place SW3 3PJ London | British | 66350760002 | ||||||||||
| CLIFTON, Stuart | Administrateur | The Orchard West Road Caister NR30 5TB Great Yarmouth Norfolk | British | 101789820001 | ||||||||||
| EKPENYONG, Paul | Administrateur | 16 Marley Road AL7 4BS Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 55370400002 | ||||||||||
| FEAR, Paul Daniel | Administrateur | The Coach House Yeabridge TA13 5LW South Petherton Somerset | British | 7800970002 | ||||||||||
| HAYES, Perry Gustav | Administrateur | 3067 Bersano Court, Pleasanton California 94566 Usa | American | 94184150001 | ||||||||||
| KENYON, Peter Willaim | Administrateur | 33 Rye Gardens BA20 2TF Yeovil Somerset | British | 41985750002 | ||||||||||
| LEAMING, Graham Rodney | Administrateur | Sadler Road LN6 3RS Lincoln Dowsett House United Kingdom | New Zealand | New Zealand | 149616190001 | |||||||||
| LEUNG, Julio Sze Wai | Administrateur | 3136 Pellara Ct Pleasanton California Ca 94566 Usa | Usa | 86044270001 | ||||||||||
| LIGAN, Warren James | Administrateur | 2142 Hall Circle, Livermore California 94550 Usa | Usa | American | 94251260001 | |||||||||
| MICHAEL, Woolley | Administrateur | Llamedos Bews Lane Chard TA20 1JU Somerset | British | 94319200003 | ||||||||||
| MUKERJEE, Indro Mario | Administrateur | The Vine House Bushfield Road, Bovingdon HP3 0DR Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 111658220001 | |||||||||
| OLDHAM, William Andrew | Administrateur | 12 Shenfield Place Shenfield CM15 9AG Brentwood Essex | British | 11970760001 | ||||||||||
| RALPH, Duncan Stewart | Administrateur | Hatfield The Avenue TA1 1ED Taunton Somerset | United Kingdom | British | 94082570001 | |||||||||
| ROBINSON, Hugh Alvaro | Administrateur | Pilsdon Barn Pilsdon DT6 5NY Bridport Dorset | United Kingdom | British | 30161190001 | |||||||||
| ROBINSON, Susan Alexandra | Administrateur | Pilsdon Barn Pilsdon DT6 5NY Bridport Dorset | British | 30161180001 | ||||||||||
| ROUND, Michael Andrew | Administrateur | Lukes The Common SN8 1DL Marlborough Wiltshire | England | English | 40324810001 |
RAKON EUROPE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 28 août 2007 Livré le 29 août 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 18 oct. 2004 Livré le 25 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattels mortgage | Créé le 15 déc. 1994 Livré le 16 déc. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof.schedule:one new 5350/5400 crystal/oscillator plater machine,serial no:1557,together with ancillary equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed equitable charge | Créé le 23 sept. 1993 Livré le 29 sept. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed equitable charge over all book debts,invoice debts,accounts,notes,bills and other forms all title property right and interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 15 sept. 1993 Livré le 16 sept. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 20 mai 1988 Livré le 01 juin 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Single debenture | Créé le 15 juil. 1981 Livré le 20 juil. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 08 août 1980 Livré le 21 août 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 29 & 29A market street, crewkerre, somerset. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0