INTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED

INTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01084723
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED ?

    • Commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires, de boissons et de tabac (46390) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe INTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KINGSWAY KANDY COMPANY LIMITED23 janv. 199023 janv. 1990
    R.E. & B. HANCOCK (BULK SALES) LIMITED28 févr. 198428 févr. 1984
    CHILTERN CONFECTIONERY LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    KINGSWAY CONFECTIONERY LIMITED01 déc. 197201 déc. 1972

    Quels sont les derniers comptes de INTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour INTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 15 juil. 2019

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    That 3,996 of the 4,000 issued ordinary shares of £0.25 each in the capital of the companies be cancelled 01/07/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Vishal Madhu en tant que directeur le 23 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Edward Foster en tant qu'administrateur le 23 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Wayne Beedle en tant qu'administrateur le 23 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jonathan Fitzgerald Summerley en tant que directeur le 11 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Hancocks Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC02

    Nomination de Mr Vishal Madhu en tant qu'administrateur le 12 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard James Garner en tant que directeur le 12 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard James Garner en tant que secrétaire le 12 avr. 2017

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juil. 2016

    État du capital au 06 juil. 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juil. 2015

    État du capital au 07 juil. 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juil. 2014

    État du capital au 07 juil. 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de INTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEEDLE, Wayne
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Administrateur
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    United KingdomBritishDirector96713740002
    FOSTER, Stephen Edward
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Administrateur
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    EnglandBritishDirector211010330001
    GARNER, Richard James
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Secrétaire
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    160760650001
    HANCOCK, Andrew David
    Riverside
    Hallstone Meadow Mill Lane
    DE74 2GD Kegworth
    Derby
    Secrétaire
    Riverside
    Hallstone Meadow Mill Lane
    DE74 2GD Kegworth
    Derby
    British28588740001
    MCDONALD, Stuart Alexander Baird
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Secrétaire
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    British64758210001
    WHELDON, Andrea
    28 Westfield Drive
    LE11 3QL Loughborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    28 Westfield Drive
    LE11 3QL Loughborough
    Leicestershire
    British18201750002
    BRITTLE, Richard James
    The Sycamores
    32 Moorgate Road
    S60 2AG Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Sycamores
    32 Moorgate Road
    S60 2AG Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director28588750001
    FULLER, Rodney David
    6 Windmill Close
    Mountsorrel
    LE12 7HR Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    6 Windmill Close
    Mountsorrel
    LE12 7HR Loughborough
    Leicestershire
    New ZealanderFinance Director46831110001
    GARNER, Richard James
    Jubilee Drive
    LE11 5TX Loughborough
    25
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Jubilee Drive
    LE11 5TX Loughborough
    25
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector174156130001
    HANCOCK, Adrian Peter
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Administrateur
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director52250340001
    HANCOCK, Andrew David
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Administrateur
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director28588740006
    MADHU, Vishal
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Administrateur
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director132103190002
    MCDONALD, Stuart Alexander Baird
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Administrateur
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    United KingdomBritishFinance Director64758210001
    SUMMERLEY, Jonathan Fitzgerald
    Jubilee Drive
    LE11 5TX Loughborough
    25
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Jubilee Drive
    LE11 5TX Loughborough
    25
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector174156880001
    WATSON, Mark Anthony
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Administrateur
    25 Jubilee Drive
    Loughborough
    LE11 5TX Leicestershire
    Great BritainBritishCompany Director28663360002
    WHELDON, Andrea
    28 Westfield Drive
    LE11 3QL Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    28 Westfield Drive
    LE11 3QL Loughborough
    Leicestershire
    BritishCo Sec/Dir18201750002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Jubilee Drive
    LE11 5TX Loughborough
    25
    England
    06 avr. 2016
    Jubilee Drive
    LE11 5TX Loughborough
    25
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2884267
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    INTERNATIONAL CONFECTIONERY AGENCIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 mars 2014
    Livré le 07 mars 2014
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank PLC
    Transactions
    • 07 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of accession
    Créé le 16 nov. 2012
    Livré le 26 nov. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank PLC (As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 26 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 28 mars 1988
    Livré le 08 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC.
    Transactions
    • 08 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 17 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 1986
    Livré le 27 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lands hereditaments and premises being land & buildings on S.W. side of imperial road, bulwell nottingham tn: nt 187265.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 27 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 17 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 07 juil. 1983
    Livré le 12 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    • 17 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 04 oct. 1977
    Livré le 12 oct. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 1977Enregistrement d'une charge
    • 17 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0