SWANSEA SOUND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSWANSEA SOUND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01089326
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SWANSEA SOUND LIMITED ?

    • Radiodiffusion (60100) / Information et communication

    Où se situe SWANSEA SOUND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 London Bridge Street
    SE1 9GF London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SWANSEA SOUND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au03 juil. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour SWANSEA SOUND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 03 juil. 2022

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Emma Caroline Humphreys le 25 juil. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Emma Caroline Humphreys le 25 juil. 2022

    2 pagesCH01

    Nomination de Emma Caroline Humphreys en tant qu'administrateur le 25 juil. 2022

    2 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    15 déc. 2022Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 15/12/2022 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cessation de la nomination de Christopher Charles Stoddart Longcroft en tant que directeur le 25 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 juin 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 juin 2020

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 01 juil. 2018

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Scott William Taunton le 02 mars 2018

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Anthony David Tompkins en tant que directeur le 30 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Norman Mckeown en tant que directeur le 30 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2016 au 30 juin 2017

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de SWANSEA SOUND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GILL, Michael Charles
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Administrateur
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    United KingdomBritishAccountant123013340001
    HUMPHREYS, Emma Caroline
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Administrateur
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    United KingdomBritishChief Financial Officer, News Uk302048380002
    TAUNTON, Scott William
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    United Kingdom
    United KingdomAustralianCompany Director80505610007
    ALLEN, Stephen
    1 Avenue Cottages
    High Street Mill Hill
    NW7 1QY London
    Secrétaire
    1 Avenue Cottages
    High Street Mill Hill
    NW7 1QY London
    British68299700001
    ASHTON, Keir
    Top Flat
    82 Brondesbury Road
    NW6 6RX London
    Secrétaire
    Top Flat
    82 Brondesbury Road
    NW6 6RX London
    British68400270001
    DOWNEY, James Robinson
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Secrétaire
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    BritishFinance Director107097580001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director4250810002
    SADLER, Keith John
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    Secrétaire
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    British73173100006
    STROUD, David Colin
    18 Wern Road
    Ystalyfera
    SA9 2LY Swansea
    West Glamorgan
    Secrétaire
    18 Wern Road
    Ystalyfera
    SA9 2LY Swansea
    West Glamorgan
    British33030270001
    TOMPKINS, Anthony
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Secrétaire
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    165681390001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Secrétaire
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    83864780002
    ALLISON, John
    155 Vicarage Road
    Morriston
    SA6 6DT Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    155 Vicarage Road
    Morriston
    SA6 6DT Swansea
    West Glamorgan
    BritishDirector33030290001
    BRAHAM, Charles James, Mister
    Winscott 172 Felinfoel Road
    SA15 3NJ Llanelli
    Dyfed
    Administrateur
    Winscott 172 Felinfoel Road
    SA15 3NJ Llanelli
    Dyfed
    BritishDirector76899370001
    BROWN, William
    19 Bainton Close
    BA15 1SE Bradford On Avon
    Wiltshire
    Administrateur
    19 Bainton Close
    BA15 1SE Bradford On Avon
    Wiltshire
    BritishDirector33761720002
    CORTIS, Roger James
    Keepers Cottage The Common
    Dunston
    NR14 8PF Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Keepers Cottage The Common
    Dunston
    NR14 8PF Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director57478700001
    DAVIES, Ian Alexander
    Park Farm Barn
    Topcroft
    NR35 2BE Bungay
    Suffolk
    Administrateur
    Park Farm Barn
    Topcroft
    NR35 2BE Bungay
    Suffolk
    BritishCompany Director58318990002
    DAVIES, Vernon Rees
    8 Langland Court Road
    Langland
    SA3 4TB Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    8 Langland Court Road
    Langland
    SA3 4TB Swansea
    West Glamorgan
    BritishRees Davies Group Of Companies32679010001
    DOBSON, Michael John
    15 St Oswalds Road
    NE46 2HF Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    15 St Oswalds Road
    NE46 2HF Hexham
    Northumberland
    BritishCommercial Radio/Sales Directo60693280001
    DOWNEY, James Robinson
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Administrateur
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    United KingdomBritishFinance Director107097580001
    GOLDSTONE, David Joseph
    22 Grosvenor Hill Court
    15 Bourdon Street
    W1K 3PX London
    Administrateur
    22 Grosvenor Hill Court
    15 Bourdon Street
    W1K 3PX London
    United KingdomBritishDirector67902310002
    GOODWIN, Jonathan Philip Pryce
    29 Broadhinton Road
    SW4 0LT London
    Administrateur
    29 Broadhinton Road
    SW4 0LT London
    BritishInvestment Banker68743940001
    GRIFFITHS, Andrew James Albert
    8 Pentwyn Drive
    Baglan
    SA12 8EF Port Talbot
    West Glamorgan
    Administrateur
    8 Pentwyn Drive
    Baglan
    SA12 8EF Port Talbot
    West Glamorgan
    WalesWelshDirector60693180001
    HARRIS, Keith
    Danescroft 37 Kingsway
    SL9 8NX Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Danescroft 37 Kingsway
    SL9 8NX Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishDirector2542580001
    JOSEPHS, John Irving
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCompany Director3830990001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director4250810002
    LONGCROFT, Christopher Charles Stoddart
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    Administrateur
    London Bridge Street
    SE1 9GF London
    1
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer163116880001
    MACKENZIE, Ashley Calder
    6 Springshaw Close
    TN13 2QE Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    6 Springshaw Close
    TN13 2QE Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector59529980005
    MACKENZIE, Kelvin Calder
    Christophers
    Lockstone Close
    KT13 8EF Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Christophers
    Lockstone Close
    KT13 8EF Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishDirector141795340001
    MANN, Terrence Keith
    17b Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    17b Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    BritishCompany Director37372220001
    MCCANN, John
    175 Malone Road
    BT9 6TB Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Administrateur
    175 Malone Road
    BT9 6TB Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishManaging Director75447990001
    MCKEOWN, Norman
    Ormeau Road
    BT7 1EB Belfast
    Havelock House
    County Antrim
    Northern Ireland
    Administrateur
    Ormeau Road
    BT7 1EB Belfast
    Havelock House
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishDirector165664890001
    MORTON, Esther Marie
    8 Victoria Court
    Caswell Drive
    SA3 4RW Swansea
    Administrateur
    8 Victoria Court
    Caswell Drive
    SA3 4RW Swansea
    BritishSales Director76356950001
    PURNELL, John Howard, Professor
    1 Bishopston Road
    Bishopston
    SA3 3EH Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    1 Bishopston Road
    Bishopston
    SA3 3EH Swansea
    West Glamorgan
    BritishProfessor24120870001
    SADLER, Keith John
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    Administrateur
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    BritishAccountant73173100006
    STROUD, David Colin
    18 Wern Road
    Ystalyfera
    SA9 2LY Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    18 Wern Road
    Ystalyfera
    SA9 2LY Swansea
    West Glamorgan
    BritishDirector33030270001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SWANSEA SOUND LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    401 Faraday Street, Birchwood Park
    WA3 6GA Warrington
    Ground Floor
    England
    06 avr. 2016
    401 Faraday Street, Birchwood Park
    WA3 6GA Warrington
    Ground Floor
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 1989
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03115084
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    SWANSEA SOUND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee
    Créé le 21 oct. 1999
    Livré le 03 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys expenses and charges due from the principal. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale,London Branch
    Transactions
    • 03 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 21 oct. 1999
    Livré le 03 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale,London Branch
    Transactions
    • 03 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 29 sept. 1999
    Livré le 20 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever save for those liabilities specifically excluded by the terms of a letter executed as a deed by the companies and the bank
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 07 oct. 1997
    Livré le 09 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 24 juin 1996
    Livré le 25 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 06 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eastern Counties Newspapers Group Limited
    Transactions
    • 06 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 05 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 05 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 sept. 1991
    Livré le 24 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land having a frontage of 150 feet or thereabouts to victoria road gowerton west glamorgan containing 1.500 acres or thereabouts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 26 juin 1980
    Livré le 11 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land - premises having frontage to victoria road gowerton county of west glamorgan together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyns Bank Limited
    Transactions
    • 11 juil. 1980Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 1974
    Livré le 10 déc. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land fronting victoria rd, gowerton, glam.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 10 déc. 1974Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0