NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC

NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 01091347
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC ?

    • Activités des sociétés d'investissement mobilier (64301) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC ?

    Adresse du siège social
    6 Stratton Street
    W1J 8LD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CONSOLIDATED VENTURE TRUST PLC20 mars 198420 mars 1984
    MONTAGU BOSTON INVESTMENT TRUST PLC18 janv. 197318 janv. 1973

    Quels sont les derniers comptes de NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 janv. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 juil. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au02 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation16 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au02 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    20 mars 2025Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPROPRITE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS REPURCHASED

    Annulation d'actions. État du capital au 07 févr. 2025

    • Capital: GBP 660,960.05
    4 pagesSH06

    Annulation d'actions. État du capital au 22 nov. 2024

    • Capital: GBP 661,187.80
    4 pagesSH06

    Annulation d'actions. État du capital au 29 nov. 2024

    • Capital: GBP 661,000
    4 pagesSH06

    Annulation d'actions. État du capital au 08 nov. 2024

    • Capital: GBP 662,252.10
    4 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 janv. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 janv. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 janv. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Annulation d'actions. État du capital au 01 nov. 2024

    • Capital: GBP 662,861.05
    4 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    16 déc. 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Annulation d'actions. État du capital au 02 oct. 2024

    • Capital: GBP 663,500
    4 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 nov. 2024Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIEVED THAT APPROPRITE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS REPURCHASED.

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    20 août 2024Clarification HMRC CONFIRMATION DUTY PAID

    Annulation d'actions. État du capital au 25 juil. 2024

    • Capital: GBP 664,166.90
    4 pagesSH06

    Annulation d'actions. État du capital au 24 juil. 2024

    • Capital: GBP 664,430.45
    4 pagesSH06

    Annulation d'actions. État du capital au 19 juil. 2024

    • Capital: GBP 667,822.35
    4 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    12 août 2024Clarification HMRC CONFIRMATION DUTY PAID

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    12 août 2024Clarification HMRC CONFIRMATION DUTY PAID

    Annulation d'actions. État du capital au 10 juil. 2024

    • Capital: GBP 669,072.35
    4 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    08 août 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    Short notice of general meetings other than an annual general meeting/wiaver of rule 9NOF the takeover code 27/06/2024
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 juin 2024Clarification HMRC CONFIRMATION DUTY PAID

    Annulation d'actions. État du capital au 13 mai 2024

    • Capital: GBP 669,114.50
    4 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    17 juin 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2024

    81 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SGH COMPANY SECRETARIES LIMITED
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement05513400
    153537380001
    FAGGE, Julian David Kenelm
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    Administrateur
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United KingdomBritishDirector310340730001
    GILBERT, Fiona Jane, Professor
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    Administrateur
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    EnglandBritishDoctor299834290001
    HOWARD, Greville Patrick Charles, The Lord Howard Of Rising
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    Administrateur
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United KingdomBritishPeer Of The Realm182790210001
    LOEWENBAUM, George Walter
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    Administrateur
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United StatesAmericanInvestor239700010001
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    Administrateur
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United KingdomBritishInvestment Manager35557050001
    MONCREIFFE, Peregrine David Euan Malcolm
    La Pouquelaye
    JE2 3GG St Helier
    Highfield Place
    Jersey
    Administrateur
    La Pouquelaye
    JE2 3GG St Helier
    Highfield Place
    Jersey
    JerseyBritishCompany Director134893770002
    WAKE, Hereward Charles, Sir
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    Administrateur
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United KingdomBritishSemi-Retired Farmer And Company Director247994560001
    GUNTRIP, Bonita
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United Kingdom
    Secrétaire
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United Kingdom
    168809330001
    INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Secrétaire
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    86602430001
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    Ground Floor Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ryder Court
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ground Floor Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ryder Court
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01091347
    36581310005
    KIN COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    5 Manfred Road
    SW15 2RS London
    Hyde Park House
    England
    Secrétaire
    5 Manfred Road
    SW15 2RS London
    Hyde Park House
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5799076
    146493700002
    ADAMS, Brian Roger
    Hill House
    Church Lane Debpen
    CB11 3LD Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Hill House
    Church Lane Debpen
    CB11 3LD Saffron Walden
    Essex
    BritishCompany Director34843120001
    BROOKE, Richard David Christopher, Sir
    The Manor House
    Cholderton
    SP4 0DW Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    The Manor House
    Cholderton
    SP4 0DW Salisbury
    Wiltshire
    BritishBanker46880370001
    GITTES, Enrique Foster
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United Kingdom
    UsaAmericanCompany Director34970630004
    GRACE JUNIOR, Oliver Russell
    55 Brookville Road
    Glen Head
    New York
    11545
    U S A
    Administrateur
    55 Brookville Road
    Glen Head
    New York
    11545
    U S A
    United StatesU S ACompany Executive113063290001
    IRBY, Charles Leonard Anthony
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United Kingdom
    LondonBritishDirector9074690001
    MONCREIFFE, Peregrine David Euan Malcolm, Hon
    Easter Moncreiffe
    PH2 8QA Bridge Of Earn
    Perthshire
    Administrateur
    Easter Moncreiffe
    PH2 8QA Bridge Of Earn
    Perthshire
    BritishCompany Director79267610001
    NATION, Douglas Percy Coddrington
    117 East 72nd Street
    New York
    10021 New York
    Usa
    Administrateur
    117 East 72nd Street
    New York
    10021 New York
    Usa
    BritishStock Broker7195230002
    PALMAR, Derek, Sir
    Longwood Lodge
    Newton
    YO6 5TU York
    Administrateur
    Longwood Lodge
    Newton
    YO6 5TU York
    BritishCompany Director25995930001
    POWER, Robert Denton Le Poer
    1111 Park Avenue
    New York Ny 10128
    FOREIGN
    Usa
    Administrateur
    1111 Park Avenue
    New York Ny 10128
    FOREIGN
    Usa
    AmericanMerchant Banker10477130001
    SIEM, Kristian
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Stratton Street
    W1J 8LD London
    6
    United Kingdom
    MonacoNorwegianDirector34724690002
    STEVENS, David Robert, Lord Stevens Of Ludgate
    Ludgate House
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Administrateur
    Ludgate House
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    BritishBanker8429680002
    SWINSTEAD, Philip Edgar
    Bentveldsduinweg 3
    Aerdenhout
    2111ak
    The Netherlands
    Administrateur
    Bentveldsduinweg 3
    Aerdenhout
    2111ak
    The Netherlands
    BritishDirector101634050008

    NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 21 déc. 2017
    Livré le 28 déc. 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge of deposit
    Créé le 20 oct. 2009
    Livré le 05 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 451502147, sort code 50-41-01 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Third party account charge
    Créé le 01 août 2009
    Livré le 11 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The account number 32052281 and all money standing to the credit of the account, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank Nv
    Transactions
    • 11 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over bank accounts
    Créé le 13 mars 2009
    Livré le 26 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge all its right title and interest in and to the accounts and the deposits see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guernsey law security inteerst agreement
    Créé le 14 mai 2007
    Livré le 17 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the secured parties or to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assign title to the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Amendment agreement relating to a security interest agreement dated 31 august 2006 and
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 17 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and crendon industrial partnership limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The collateral being 100 shares in the capital of crendon industrial partnership limited including derivative assets,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Security interest agreement
    Créé le 31 août 2006
    Livré le 19 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from crendon industrial partnership limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigned title to the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 19 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Subordination agreement
    Créé le 05 août 2004
    Livré le 18 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from an obligor or received by the subordinated creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    If any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; the subordinated creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mable Commercial Funding Limited
    Transactions
    • 18 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An accession agreement
    Créé le 05 août 2004
    Livré le 16 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company as a junior creditor under the subordination agreement has undertaken to the agent that if, any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities, or any junior creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mable Commercial Funding Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 16 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 06 juil. 1994
    Livré le 13 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from consolidated venture finance limited to the governor and company of the bank of scotland under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland .
    Transactions
    • 13 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of charge
    Créé le 02 déc. 1991
    Livré le 16 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee dated 2ND december 1991 as defined in and under this charge
    Brèves mentions
    All dividends and rights in the shares (see doc ref M440C for full details).
    Personnes ayant droit
    • D G Investment Bank Limited
    Transactions
    • 16 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0