D G PRODUCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéD G PRODUCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01102968
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de D G PRODUCE LIMITED ?

    • Culture de légumes et melons, racines et tubercules (01130) / Agriculture, sylviculture et pêche
    • Autres activités de transformation et conservation de fruits et légumes (10390) / Industries manufacturières

    Où se situe D G PRODUCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sycamore House
    Cannister Lane
    PE22 7HG Frithville, Lincolnshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de D G PRODUCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GORDON GRANT & SONS LIMITED21 mars 197321 mars 1973

    Quels sont les derniers comptes de D G PRODUCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour D G PRODUCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2019

    2 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 08 avr. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium a/c be cancelled 25/03/2019
    RES13

    Déclaration de confirmation établie le 07 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2018

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2017

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 janv. 2016

    État du capital au 07 janv. 2016

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr George Read le 07 janv. 2016

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2016

    État du capital au 05 janv. 2016

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 mars 2015

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Nigel Peter Clare en tant que directeur le 31 mars 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Grant en tant que directeur le 31 mars 2015

    2 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de D G PRODUCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    READ, George
    Seadyke Lane
    Old Leake
    PE22 9HY Boston
    Mill Farm
    Lincolnshire
    England
    Administrateur
    Seadyke Lane
    Old Leake
    PE22 9HY Boston
    Mill Farm
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritish31448210003
    READ, Vernon Edward
    Main Road
    Langrick
    PE22 7AJ Boston
    Witham House
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Main Road
    Langrick
    PE22 7AJ Boston
    Witham House
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish53474660002
    GRANT, Freda
    Sycamore House Canister Lane
    Frithville
    PE22 7HG Boston
    Lincolnshire
    Secrétaire
    Sycamore House Canister Lane
    Frithville
    PE22 7HG Boston
    Lincolnshire
    British20894350001
    GRANT, Sally
    Holly House
    Fishtoft Drove, Frithville
    PE22 7ES Boston
    Lincolnshire
    Secrétaire
    Holly House
    Fishtoft Drove, Frithville
    PE22 7ES Boston
    Lincolnshire
    British64597660001
    CLARE, Nigel Peter
    Wyberton West Road
    Wyberton
    PE21 7JL Boston
    The Nightins
    Lincolnshire
    Administrateur
    Wyberton West Road
    Wyberton
    PE21 7JL Boston
    The Nightins
    Lincolnshire
    EnglandBritish246911590001
    GRANT, David
    Holly House
    Fishtoft Drove, Frithville
    PE22 7ES Boston
    Lincolnshire
    Administrateur
    Holly House
    Fishtoft Drove, Frithville
    PE22 7ES Boston
    Lincolnshire
    EnglandBritish63497770001
    GRANT, Freda
    Sycamore House Canister Lane
    Frithville
    PE22 7HG Boston
    Lincolnshire
    Administrateur
    Sycamore House Canister Lane
    Frithville
    PE22 7HG Boston
    Lincolnshire
    British20894350001
    GRANT, Sally
    Holly House
    Fishtoft Drove, Frithville
    PE22 7ES Boston
    Lincolnshire
    Administrateur
    Holly House
    Fishtoft Drove, Frithville
    PE22 7ES Boston
    Lincolnshire
    EnglandBritish64597660001
    GRANT, William
    The Grove
    Frithville
    Boston
    Lincs
    Administrateur
    The Grove
    Frithville
    Boston
    Lincs
    British20894370001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur D G PRODUCE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Staples Brothers Limited
    Station Road
    Sibsey
    PE22 0SE Boston
    Station Farm
    Lincolnshire
    England
    06 avr. 2016
    Station Road
    Sibsey
    PE22 0SE Boston
    Station Farm
    Lincolnshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCardiff
    Numéro d'enregistrement00568996
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    D G PRODUCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage deed
    Créé le 18 avr. 2012
    Livré le 20 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a sycamore farm cannister lane frithville boston lincolnshire together with land on the south side of cannister lane and land to the rear of sycamore house t/n's LL166227, LL226402 and LL84508 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 19 nov. 2010
    Livré le 23 nov. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a approx 2.5 acres of land at sycamore farm cannister lane frithville boston lincs together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 22 août 2003
    Livré le 28 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property being 9.65 acres of land at frithville boston lincolnshire title number LL226402. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 19 févr. 1999
    Livré le 24 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a land at the rear of sycamore house cannister lane frithville lincolnshire t/n LL84508. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 19 févr. 1999
    Livré le 24 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 2 coronation cottage cannister lane and sycamore house cannister lane frithville lincolnshire. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1999
    Livré le 20 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property comprised in title number LL84508 being land to the rear of sycamore house cannister lane frithville including any part thereof.
    Personnes ayant droit
    • Marshall Bros (Holdings) Limited
    Transactions
    • 20 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1999
    Livré le 20 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a sycamore house cannister lane frithville lincolnshire and the outbuildings and land adjoining together with the cottage (k/a 2 coronation cottages) fronting cannister lane aforesaid being enclosure number 538 and parts 542 and 541 on the ordnance survey plan for the said parish.
    Personnes ayant droit
    • Marshall Bros (Holdings) Limited
    Transactions
    • 20 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 févr. 1999
    Livré le 20 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    For full details please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Marshall Bros (Holdings) Limited
    Transactions
    • 20 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 09 oct. 1998
    Livré le 12 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 juil. 1992
    Livré le 06 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage 60.126 acres approx part of kents farm frithville lincolnshire fixed charge the benefit of all covenants and rights affecting the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 02 juil. 1992
    Livré le 06 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £120,000.00 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Please see doc M792C for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Marshall Bros (Butterwick) Limited
    Transactions
    • 06 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 oct. 1985
    Livré le 08 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See doc M21). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    • 09 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0