REDHALL ENGINEERING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREDHALL ENGINEERING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01104293
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REDHALL ENGINEERING LIMITED ?

    • Autres travaux de construction spécialisés n.d.a. (43999) / Construction
    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe REDHALL ENGINEERING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REDHALL ENGINEERING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BOOTH WATER ENGINEERING LIMITED20 avr. 199420 avr. 1994
    TRUF TANKS LIMITED27 mars 197327 mars 1973

    Quels sont les derniers comptes de REDHALL ENGINEERING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour REDHALL ENGINEERING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    12 pagesLIQ14

    Changement d'adresse du siège social de 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB à 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB le 12 nov. 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 sept. 2021

    13 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 sept. 2020

    14 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA England à 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB le 18 sept. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration des affaires

    6 pagesLIQ02

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 05 sept. 2019

    LRESEX

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2018 au 31 mars 2019

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Russell David Haworth le 10 janv. 2019

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Wayne Pearson en tant que directeur le 03 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Russell David Haworth en tant qu'administrateur le 03 nov. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 05 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Philip Comer le 09 août 2018

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Christopher John Kelly en tant que secrétaire le 01 juil. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Simon Philip Comer en tant que secrétaire le 02 juil. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Christopher John Kelly en tant que directeur le 29 juin 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Simon Philip Comer en tant qu'administrateur le 02 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip Brierley en tant que directeur le 31 mars 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Wayne Pearson en tant qu'administrateur le 19 mars 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de REDHALL ENGINEERING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COMER, Simon Philip
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    Secrétaire
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    248222860001
    COMER, Simon Philip
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    Administrateur
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    EnglandBritishDirector206088760003
    HAWORTH, Russell David
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    Administrateur
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    EnglandBritishDirector201533400002
    BOOTH, Anthony Miles Philip
    39 Finchley Road
    Hale
    WA15 9RE Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    39 Finchley Road
    Hale
    WA15 9RE Altrincham
    Cheshire
    BritishChartered Accountant32499750001
    ENTWISTLE, Alan John
    4 Moorlands View
    BL3 3TN Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    4 Moorlands View
    BL3 3TN Bolton
    Lancashire
    British2079060001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Secrétaire
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    187640220001
    LEWIS JONES, Christopher
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    Secrétaire
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    BritishDirector94645950001
    ROBSON, William
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    Secrétaire
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    BritishCompany Director74793730002
    BOOTH, Anthony Miles Philip
    39 Finchley Road
    Hale
    WA15 9RE Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    39 Finchley Road
    Hale
    WA15 9RE Altrincham
    Cheshire
    BritishChartered Accountant32499750001
    BOOTH, James Gerrard
    Forest Side
    Lostock Junction Lane
    BL6 4JR Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    Forest Side
    Lostock Junction Lane
    BL6 4JR Bolton
    Lancashire
    BritishStructural Engineer2079070001
    BOOTH, Robert Leyland
    24 Lostock Junction Lane
    Lostock
    BL6 4JR Bolton
    Administrateur
    24 Lostock Junction Lane
    Lostock
    BL6 4JR Bolton
    BritishEngineer41595700001
    BRIERLEY, Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishChief Executive54808010002
    CHILTON, Keith
    Willow Cottage Barrow Lane
    Swarkestone
    DE73 1JA Derby
    Administrateur
    Willow Cottage Barrow Lane
    Swarkestone
    DE73 1JA Derby
    BritishCompany Director52051390001
    ENTWISTLE, Alan John
    4 Moorlands View
    BL3 3TN Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    4 Moorlands View
    BL3 3TN Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Secretary2079060001
    FOSTER, Robert Simon
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford,
    Devon
    England
    Administrateur
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford,
    Devon
    England
    EnglandBritishDirector134973970001
    HOWARD, Geoffrey
    582 Bury Road
    OL11 4DN Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    582 Bury Road
    OL11 4DN Rochdale
    Lancashire
    BritishDirector35485480001
    JORDAN, Roy Gregory
    15 Monroe Close
    LE16 7QN Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    15 Monroe Close
    LE16 7QN Market Harborough
    Leicestershire
    UsaCompany Director52042650002
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishGroup Finance Director188444350001
    LEE, William Peter
    5 Jordan Croft
    Fradley
    Staffordshire
    Administrateur
    5 Jordan Croft
    Fradley
    Staffordshire
    British47057060001
    LEWIS JONES, Christopher
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director94645950001
    O'KANE, John Peter
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    England
    United KingdomIrishDirector106172200001
    PEARSON, Wayne
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector212154420001
    ROBSON, William
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    Administrateur
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    BritishCompany Director74793730002
    SHUTTLEWORTH, Richard Peter
    c/o Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector58727820002
    STOTT, Michael
    11 Oakdale Drive
    Astley, Tyldesley
    M29 7NX Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    11 Oakdale Drive
    Astley, Tyldesley
    M29 7NX Manchester
    Lancashire
    BritishSales Engineer64700580003
    WELLS, Ian Kenneth
    27 Thornhill Road
    Harworth
    DN11 8LQ Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    27 Thornhill Road
    Harworth
    DN11 8LQ Doncaster
    South Yorkshire
    BritishSales Engineer64705120002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REDHALL ENGINEERING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Redhall Group Plc
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    06 avr. 2016
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement263995
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    REDHALL ENGINEERING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 13/02/01 (the agreement)
    Créé le 16 nov. 2004
    Livré le 18 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 18 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 13 february 2001
    Créé le 24 août 2004
    Livré le 14 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any account.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 14 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 13 févr. 2001
    Livré le 17 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 27 mai 1988
    Livré le 10 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 19 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 24 juin 1987
    Livré le 03 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 08 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 oct. 1986
    Livré le 08 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 08 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 06 nov. 1981
    Livré le 16 nov. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (incl trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 1981Enregistrement d'une charge
    • 08 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    REDHALL ENGINEERING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 sept. 2019Commencement of winding up
    30 juin 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Petts
    2nd Floor Rotterdam House 116 Quayside
    NE1 3DY Newcastle Upon Tyne
    practitioner
    2nd Floor Rotterdam House 116 Quayside
    NE1 3DY Newcastle Upon Tyne
    Sarah O'Toole
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    practitioner
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0