REDHALL ENGINEERING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | REDHALL ENGINEERING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01104293 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe REDHALL ENGINEERING LIMITED ?
Adresse du siège social | 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de REDHALL ENGINEERING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour REDHALL ENGINEERING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 12 pages | LIQ14 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB à 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB le 12 nov. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 sept. 2021 | 13 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 sept. 2020 | 14 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA England à 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB le 18 sept. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration des affaires | 6 pages | LIQ02 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2018 au 31 mars 2019 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Russell David Haworth le 10 janv. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Wayne Pearson en tant que directeur le 03 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Russell David Haworth en tant qu'administrateur le 03 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Philip Comer le 09 août 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher John Kelly en tant que secrétaire le 01 juil. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Philip Comer en tant que secrétaire le 02 juil. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher John Kelly en tant que directeur le 29 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Philip Comer en tant qu'administrateur le 02 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Brierley en tant que directeur le 31 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Wayne Pearson en tant qu'administrateur le 19 mars 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 oct. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de REDHALL ENGINEERING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMER, Simon Philip | Secrétaire | Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester 11th Floor | 248222860001 | |||||||
COMER, Simon Philip | Administrateur | Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester 11th Floor | England | British | Director | 206088760003 | ||||
HAWORTH, Russell David | Administrateur | Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester 11th Floor | England | British | Director | 201533400002 | ||||
BOOTH, Anthony Miles Philip | Secrétaire | 39 Finchley Road Hale WA15 9RE Altrincham Cheshire | British | Chartered Accountant | 32499750001 | |||||
ENTWISTLE, Alan John | Secrétaire | 4 Moorlands View BL3 3TN Bolton Lancashire | British | 2079060001 | ||||||
KELLY, Christopher John | Secrétaire | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 187640220001 | |||||||
LEWIS JONES, Christopher | Secrétaire | The Smithy Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich Cheshire | British | Director | 94645950001 | |||||
ROBSON, William | Secrétaire | Woodlands Main Street LE7 9YB Skeffington Leicestershire | British | Company Director | 74793730002 | |||||
BOOTH, Anthony Miles Philip | Administrateur | 39 Finchley Road Hale WA15 9RE Altrincham Cheshire | British | Chartered Accountant | 32499750001 | |||||
BOOTH, James Gerrard | Administrateur | Forest Side Lostock Junction Lane BL6 4JR Bolton Lancashire | British | Structural Engineer | 2079070001 | |||||
BOOTH, Robert Leyland | Administrateur | 24 Lostock Junction Lane Lostock BL6 4JR Bolton | British | Engineer | 41595700001 | |||||
BRIERLEY, Philip | Administrateur | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | Chief Executive | 54808010002 | ||||
CHILTON, Keith | Administrateur | Willow Cottage Barrow Lane Swarkestone DE73 1JA Derby | British | Company Director | 52051390001 | |||||
ENTWISTLE, Alan John | Administrateur | 4 Moorlands View BL3 3TN Bolton Lancashire | British | Company Secretary | 2079060001 | |||||
FOSTER, Robert Simon | Administrateur | Aish TQ10 9JG South Brent Stamford, Devon England | England | British | Director | 134973970001 | ||||
HOWARD, Geoffrey | Administrateur | 582 Bury Road OL11 4DN Rochdale Lancashire | British | Director | 35485480001 | |||||
JORDAN, Roy Gregory | Administrateur | 15 Monroe Close LE16 7QN Market Harborough Leicestershire | Usa | Company Director | 52042650002 | |||||
KELLY, Christopher John | Administrateur | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | Group Finance Director | 188444350001 | ||||
LEE, William Peter | Administrateur | 5 Jordan Croft Fradley Staffordshire | British | 47057060001 | ||||||
LEWIS JONES, Christopher | Administrateur | The Smithy Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich Cheshire | England | British | Finance Director | 94645950001 | ||||
O'KANE, John Peter | Administrateur | Station Lane Burton Leonard HG3 3RU Harrogate Holly Cottage North Yorkshire England | United Kingdom | Irish | Director | 106172200001 | ||||
PEARSON, Wayne | Administrateur | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | Director | 212154420001 | ||||
ROBSON, William | Administrateur | Woodlands Main Street LE7 9YB Skeffington Leicestershire | British | Company Director | 74793730002 | |||||
SHUTTLEWORTH, Richard Peter | Administrateur | c/o Redhall Group Plc Red Hall Court WF1 2UN Wakefield 1 West Yorkshire England | England | British | Director | 58727820002 | ||||
STOTT, Michael | Administrateur | 11 Oakdale Drive Astley, Tyldesley M29 7NX Manchester Lancashire | British | Sales Engineer | 64700580003 | |||||
WELLS, Ian Kenneth | Administrateur | 27 Thornhill Road Harworth DN11 8LQ Doncaster South Yorkshire | British | Sales Engineer | 64705120002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REDHALL ENGINEERING LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redhall Group Plc | 06 avr. 2016 | Calder Close Durkar WF4 3BA Wakefield Unit 3 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
REDHALL ENGINEERING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 13/02/01 (the agreement) | Créé le 16 nov. 2004 Livré le 18 nov. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 13 february 2001 | Créé le 24 août 2004 Livré le 14 sept. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture deed | Créé le 13 févr. 2001 Livré le 17 févr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 27 mai 1988 Livré le 10 juin 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 24 juin 1987 Livré le 03 juil. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 01 oct. 1986 Livré le 08 oct. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 06 nov. 1981 Livré le 16 nov. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (incl trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
REDHALL ENGINEERING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0