HALLITE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHALLITE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01104611
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HALLITE LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HALLITE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HALLITE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HALLITE HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY28 mars 197328 mars 1973

    Quels sont les derniers comptes de HALLITE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour HALLITE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 janv. 2021

    8 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 janv. 2020

    8 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Hesslewood Country Office Park Ferriby Road Hessle East Yorkshire HU13 0PW à C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House Lowgate Hull HU1 1EL le 04 févr. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 janv. 2019

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 08 janv. 2019

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    The share premium account of the company be cancelled 13/12/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des détails de Fenner Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 déc. 2018

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William John Pratt le 10 sept. 2018

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 04 août 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 août 2018 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 août 2017

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William John Pratt le 16 mars 2018

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Simon Alan Davies en tant que directeur le 05 mars 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 04 août 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2016

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 août 2015

    État du capital au 04 août 2015

    • Capital: GBP 1,403,811
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Maitland Caley le 03 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de HALLITE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRADBURY, Debra
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    Secrétaire
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    British72879990002
    CALEY, Andrew Maitland
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    Administrateur
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    United KingdomBritish49060800002
    PRATT, William John
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    Administrateur
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    United KingdomBritish194710300003
    GILLETT, Christopher Joseph
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Secrétaire
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    British69961270001
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    Secrétaire
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    British119450490001
    LYALL, Gordon John
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    British15413660003
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Secrétaire
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    British10035580002
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Secrétaire
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    British10035580002
    WELLER, Christopher
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    British80664920001
    BENNETT, Peter Ian
    24 Coulter Close
    Cuffley
    EN6 4RR Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    24 Coulter Close
    Cuffley
    EN6 4RR Potters Bar
    Hertfordshire
    British4154020001
    CHAFFIN, Peter
    The Croft 21 The Ridgeway
    TN10 4NH Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    The Croft 21 The Ridgeway
    TN10 4NH Tonbridge
    Kent
    British1508410001
    DAVIES, Simon Alan
    28 Stonebridge Field
    Eton
    SL4 6PS Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    28 Stonebridge Field
    Eton
    SL4 6PS Windsor
    Berkshire
    British44598860003
    GILLETT, Christopher Joseph
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Great BritainBritish69961270001
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    Administrateur
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    EnglandBritish119450490001
    JONES, David Henry
    Neen Court
    DY14 0AH Neen Sollars
    Worcestershire
    Administrateur
    Neen Court
    DY14 0AH Neen Sollars
    Worcestershire
    United KingdomBritish101383260001
    KINGSNORTH, Robert Stanley
    The Dolphins 23 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    Administrateur
    The Dolphins 23 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    British58131230001
    LYALL, Gordon John
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    British15413660003
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish10035580002
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish10035580002
    PERRY, Richard John
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    East Yorkshire
    Administrateur
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    East Yorkshire
    United KingdomBritish40260860002
    WELLER, Christopher
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    British80664920001
    WILKINS, Christopher Stuart Henry
    Banktop House
    Hopton Lane Hopton
    ST18 0AH Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    Banktop House
    Hopton Lane Hopton
    ST18 0AH Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish127017930001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HALLITE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    Unit 5
    East Yorkshire
    England
    06 avr. 2016
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    Unit 5
    East Yorkshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00329377
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    HALLITE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 17 sept. 1998
    Livré le 22 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 31 janv. 1994
    Livré le 21 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement (as defined in the original debenture) and any document evidencing the provision of an ancillary facility and/or such of the security documents and under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limited, as Agent and Trustee for Itself, the Arranger and the Banks
    Transactions
    • 21 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 23 févr. 1990
    Livré le 13 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself, the arranger and the banks under the terms of an agreement (as defined in the original debenture) and any document evidencing the provision of an ancillary facility and/or such of the security documents and under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transactions
    • 13 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 31 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 1989
    Livré le 05 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the bank (as defined) at the banks (or any of them) under the terms of the agreement and the security documents referred to in the charge.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transactions
    • 05 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 30 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & second debenture
    Créé le 25 août 1989
    Livré le 05 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27/7/89
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • First Britannia Mezzanine Capital B V(For Itself and as Trustee for the Lenders)
    Transactions
    • 05 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 31 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & second debenture
    Créé le 27 juil. 1989
    Livré le 17 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • First Britannia Mezzanine Capital B V
    Transactions
    • 17 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 31 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 juil. 1989
    Livré le 07 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) on any account whatsoever. Under the terms of a facility agreement of even dated and the charge.
    Brèves mentions
    (See form 395 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transactions
    • 07 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 31 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and second debenture.
    Créé le 27 juil. 1989
    Livré le 07 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a mezzamine loan agreement dated 27TH july 1989 and the deed.
    Brèves mentions
    (See form 395 reg M536C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • First Britannia Mezzanine Capital B V(As Trustee for the Lenders)
    Transactions
    • 07 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 31 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 août 1985
    Livré le 13 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings on the north western and south western side of holly road and on the south eastern side of sherland road, london borough of richmond upon thames title no mx 129433.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 29 août 1985
    Livré le 13 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    108,Sherland road and land and buildings on the south eastern and south western sides of sherland road and with north western side of holly road london borough of richmond upon thames title no mx 129432.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 1985Enregistrement d'une charge

    HALLITE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 janv. 2019Commencement of winding up
    13 nov. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sarah Louise Burge
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    practitioner
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0