BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED

BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01104681
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HECKLER & KOCH (U.K.) LIMITED28 mars 197328 mars 1973

    Quels sont les derniers comptes de BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 nov. 2014

    4 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Warwick House, PO Box 87 Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU le 26 nov. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juin 2013

    État du capital au 03 juin 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Nomination de Mr Matthew Stephen Miller en tant qu'administrateur le 30 avr. 2013

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christopher Neil James Sparkes en tant que directeur le 30 avr. 2013

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Brian William Ierland en tant que directeur le 04 févr. 2013

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Christopher Neil James Sparkes en tant qu'administrateur le 04 févr. 2013

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Alan Bond en tant qu'administrateur le 04 févr. 2013

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Charles Anthony Blakemore en tant que directeur le 04 févr. 2013

    1 pagesTM01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Charles Anthony Blakemore le 15 mai 2012

    2 pagesCH01

    Nomination de Charles Anthony Blakemore en tant qu'administrateur le 12 sept. 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Leonard Allott en tant que directeur le 12 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Comptes établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Brian William Ierland le 15 mars 2011

    2 pagesCH01

    Statuts

    29 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Qui sont les dirigeants de BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Secrétaire
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    British25179240002
    BOND, David Alan
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish175529150001
    MILLER, Matthew Stephen
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    United KingdomBritish177892300001
    FRASER, Alan William Gray
    Burnknock 22 Tannoch Road
    G78 4AD Uplawmoor
    Glasgow
    Secrétaire
    Burnknock 22 Tannoch Road
    G78 4AD Uplawmoor
    Glasgow
    British199134280001
    JARMAN, Patrick Edmund
    120 Station Road
    Croston
    PR5 7RP Preston
    Secrétaire
    120 Station Road
    Croston
    PR5 7RP Preston
    British61848400001
    KOCH, Susanne Irmgard
    75 Heron Drive
    Lenton
    NG7 2DF Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    75 Heron Drive
    Lenton
    NG7 2DF Nottingham
    Nottinghamshire
    British15254090003
    MAXWELL, Ian Henry
    Borwicks
    Caton
    LA2 9NB Lancaster
    Secrétaire
    Borwicks
    Caton
    LA2 9NB Lancaster
    British38742020001
    STARLING, Christopher
    Millbrook
    Underhill Lane
    BN6 9PJ Clayton
    West Sussex
    Secrétaire
    Millbrook
    Underhill Lane
    BN6 9PJ Clayton
    West Sussex
    British87150600001
    ALLOTT, David Leonard
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish89710790002
    BILLINGHAM, Nigel Anthony
    20 Smithbarn
    RH13 6EB Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    20 Smithbarn
    RH13 6EB Horsham
    West Sussex
    British2403250001
    BLAKEMORE, Charles Anthony
    Warwick House PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick House PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    United KingdomBritish126468520001
    CURTIS, Roger Keith
    24 Roopers
    Speldhurst
    TN3 0QL Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    24 Roopers
    Speldhurst
    TN3 0QL Tunbridge Wells
    Kent
    British57879740001
    DAVIES, Andrew Oswell Bede
    KT22
    Administrateur
    KT22
    EnglandBritish257544070001
    FRASER, Alan William Gray
    Burnknock 22 Tannoch Road
    G78 4AD Uplawmoor
    Glasgow
    Administrateur
    Burnknock 22 Tannoch Road
    G78 4AD Uplawmoor
    Glasgow
    United KingdomBritish199134280001
    GOLDSMITH, Ronald Leonard
    West Lodge Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    West Lodge Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    British15254100001
    GRANT, Jonathan Paul
    18 Sunnyside Road
    TW11 0RT Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    18 Sunnyside Road
    TW11 0RT Teddington
    Middlesex
    British103331130001
    HAINSWORTH, Keith Alan
    24 Great Notley Avenue
    Notley Green
    CM77 7UW Braintree
    Essex
    Administrateur
    24 Great Notley Avenue
    Notley Green
    CM77 7UW Braintree
    Essex
    United KingdomBritish82207330001
    IERLAND, Brian William
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish90349460003
    KOCH, Susanne Irmgard
    15 Pelham Crescent
    NG7 1AS Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    15 Pelham Crescent
    NG7 1AS Nottingham
    Nottinghamshire
    British15254090002
    MALIA, Kenneth
    11 Rothbury Grove
    NG13 8TG Bingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    11 Rothbury Grove
    NG13 8TG Bingham
    Nottinghamshire
    British32488590001
    MAXWELL, Ian Henry
    Borwicks
    Caton
    LA2 9NB Lancaster
    Administrateur
    Borwicks
    Caton
    LA2 9NB Lancaster
    EnglandBritish38742020001
    MILLS, Shaun Michael
    Grove Cottage
    Beardsmore Drive
    WA3 2JH Lowton
    Cheshire
    Administrateur
    Grove Cottage
    Beardsmore Drive
    WA3 2JH Lowton
    Cheshire
    United KingdomBritish153886050001
    RICHARDSON, Clive Robert
    79 Grange Road
    Saltford
    BS31 3AQ Bristol
    Administrateur
    79 Grange Road
    Saltford
    BS31 3AQ Bristol
    United KingdomBritish62140970001
    SPARKES, Christopher Neil James
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    United KingdomBritish91861410001
    STARLING, Christopher
    Millbrook
    Underhill Lane
    BN6 9PJ Clayton
    West Sussex
    Administrateur
    Millbrook
    Underhill Lane
    BN6 9PJ Clayton
    West Sussex
    British87150600001

    BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over credit balances
    Créé le 18 sept. 1990
    Livré le 24 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Dm 874,428.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the counter indemnity dated 18.9.90
    Brèves mentions
    All sums standing from time to time to the credit of the company's account no. 010 14 10/0000/dm/001 opened in the banks books including any sub-account and redesignation of that account.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 24 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 28 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    Charge over credit balances
    Créé le 03 janv. 1990
    Livré le 05 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Dm 18085,450.00 to be received by way of advance payment under a contract entered into by the co. With the office at the president police headquarter's nairobi,kenya in respect of which deutsche bank ag, london branch is to guarantee against the co's counter indemnity dated 2/1/90.
    Brèves mentions
    All sums from time to time standing to the credit of the co's call account no. 010 14 10/0300/dm/001 (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 05 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 25 avr. 1990Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 17 août 1989
    Livré le 22 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Dm 1,136,800 due from the company to the chargee under the terms of a counter-indemnity dated 19/5/89
    Brèves mentions
    All sums (including interest) from time to time standing to the credit of the company call account no. 0101410/0001 (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 22 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 12 oct. 1989Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of charge on cash deposits
    Créé le 02 juil. 1988
    Livré le 14 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The amount of dem 8,560.00 deposited with the chargee at its office at 10/11 austin friars, london EC2P 2JD and any other amount denominated in any currency or unit of account deposited by the company with the chargee.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 14 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 27 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Memorandum of charge on cash deposit
    Créé le 15 juin 1988
    Livré le 04 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The amounts of dem 5,700.00 deposited with the chargee at its office at 10/11 austin friars, london EC2P 2JD and any other amount denominated in any currency or unit or account deposited by the company with the chargee.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 04 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    BAE SYSTEMS (FARNBOROUGH 5) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 mars 2015Dissolved on
    13 nov. 2013Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0