ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED

ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01105441
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FTBF LEASING DECEMBER (A) LIMITED15 févr. 199515 févr. 1995
    FORWARD ASSET LEASING DECEMBER (A) LIMITED14 août 199214 août 1992
    MIDLAND MONTAGU EQUIPMENT FINANCE LIMITED30 mars 197330 mars 1973

    Quels sont les derniers comptes de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Robin Louise Henning Bencard en tant qu'administrateur

    5 pagesRP04TM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Cessation de la nomination de Robin Louis Henning Bencard en tant que directeur le 08 août 2016

    2 pagesTM01
    Annotations
    DateAnnotation
    09 sept. 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 09/09/2016

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 mai 2016

    État du capital au 05 mai 2016

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nomination de Mr Simon Einar Long en tant qu'administrateur le 15 mars 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Cavanna en tant que directeur le 31 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael Connelly Anderson en tant qu'administrateur le 16 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    19 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Cessation de la nomination de Hannah Elizabeth Shepherd en tant que secrétaire le 28 mai 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Ms Romana Lewis en tant que secrétaire le 28 mai 2015

    2 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2015

    État du capital au 08 mai 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nomination de Hannah Elizabeth Shepherd en tant que secrétaire le 05 janv. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Tony Bhambhra en tant que secrétaire le 05 janv. 2015

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    20 pagesAA

    Nomination de Tony Bhambhra en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Katherine Dean en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2014

    État du capital au 08 mai 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    52 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Secrétaire
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    198057230001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Secrétaire
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    187824150001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180092200001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Secrétaire
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Secrétaire
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Secrétaire
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Secrétaire
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Secrétaire
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Secrétaire
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194209400001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154911860001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    166967460001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    BROOKES, Malcolm James
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    Administrateur
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    British61727900003
    CARNEY, Brian
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    British100001170001
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Administrateur
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Administrateur
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Administrateur
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HARRIS, Christopher David
    8 Verdon Place
    Barford
    CV35 8BT Warwick
    Administrateur
    8 Verdon Place
    Barford
    CV35 8BT Warwick
    British28742940002
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Administrateur
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KELL, Christopher Raymond
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    Administrateur
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    British87307470001
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Administrateur
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    LANE, Robert David
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    Administrateur
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    EnglandBritish150099050001
    LEECH, Ian Robert
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    Administrateur
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    British52909330001
    LESTER, Edward Paul
    26 St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    26 St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    British4300370001
    MEAD, David Harry
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish254170760001

    ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Amended and restated intercreditor agreement
    Créé le 19 déc. 1997
    Livré le 31 déc. 1997
    En cours
    Montant garanti
    In favour of chase manhattan international limited as security agent and trustee for the senior creditors (as defined) and the lessors (as defined) (1)the senior debt, subject to clause 11.2, clause 11.4, clause 27.3(iii) and clause 27.4(b) of the intercreditor agreement all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents (as defined), (2)the lease debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the lessors under or in connection with the lease finance documents (as defined) and (3) the subordinated debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the subordinated creditors (as defined) under or in connection with the subordinated debt documents or in connection with treasury debt and all indemnity rights
    Brèves mentions
    If at any time prior to the later of the senior discharge date the company receives a payment or distribution in cash or kind of or on account of any lease debt or prior to the senior discharge date any lease debt is discharged in each case in a manner not permitted by clause 6 (permitted lease payments) by clause 7 (permitted subordinated payments) or clause 15.1 (permitted lease enforcement) clause 15.2 (permitted enforcement action in respect of vat) or by clause 17 (proceeds of enforcement of security) the company will subject to clause 10.9 (exclusion of trust) hold such recovery payment distribution proceeds set-off or other amount in trust for the security trustee.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited
    Transactions
    • 31 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 19 déc. 1997
    Livré le 31 déc. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the chattel mortgage under and in accordance with clause 4 (sales representative) of the direct agreement
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the english assets ,the scottish assets and the northern irish assets including the sale proceeds thereof for full details of charged assets please refer to form 395.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited
    Transactions
    • 31 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Lessor's security assignment (as defined)
    Créé le 19 déc. 1996
    Livré le 27 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage
    Brèves mentions
    All rights,title and interest in respect of clause 5.1 of the conditional sale agreement to acquire ownership of the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samoco 1233 Trust
    Transactions
    • 27 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 10 déc. 1996
    Livré le 20 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage
    Brèves mentions
    All rights,title,interest,insurances and proceeds of sale in the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samoco 1233 Trust
    Transactions
    • 20 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0