ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED

ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéST. AUBIN PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01112539
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GAYDALE PROPERTIES LIMITED08 mai 197308 mai 1973

    Quels sont les derniers comptes de ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Genting Club Star City Watson Road Birmingham B7 5SA à C/O Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham West Midlands B4 6GH le 09 juil. 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 25 juin 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Modification des coordonnées du secrétaire Elizabeth Jill Tarn le 23 oct. 2014

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 oct. 2014

    État du capital au 19 oct. 2014

    • Capital: GBP 320,100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 oct. 2013

    État du capital au 11 oct. 2013

    • Capital: GBP 320,100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    1 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Genting Club Birmingham Star City Watson Road Birmingham B7 5SA England* le 17 janv. 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Circus Casino Star City Watson Road Birmingham B7 5SA England* le 29 déc. 2011

    1 pagesAD01

    Nomination de Richard Robert Salmond en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nicholas Perrin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * Stanley House 151 Dale Street Liverpool Merseyside L2 2JW* le 20 oct. 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas John Perrin le 28 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas John Perrin le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Qui sont les dirigeants de ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TARN, Elizabeth Jill
    c/o Kpmg Llp
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    Secrétaire
    c/o Kpmg Llp
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    British131467900001
    BROOKS, Peter Malcolm
    38 Margaretta Terrace
    Chelsea
    SW3 5NX London
    Administrateur
    38 Margaretta Terrace
    Chelsea
    SW3 5NX London
    EnglandBritishDirector84067460001
    SALMOND, Richard Robert
    Star City
    Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Circus Casino
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Star City
    Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Circus Casino
    West Midlands
    England
    EnglandBritishDirector164973490001
    GOULBOURNE, Sarah-Jane
    36 Wynnstay Lane
    Marford
    LL12 8LG Wrexham
    Clwyd
    Secrétaire
    36 Wynnstay Lane
    Marford
    LL12 8LG Wrexham
    Clwyd
    British64347190002
    JACKSON, Anthony Grahame
    Lavender Cottage The Green North
    OX10 7DW Warborough
    Oxon
    Secrétaire
    Lavender Cottage The Green North
    OX10 7DW Warborough
    Oxon
    British63026430001
    MILLER, Ian Leonard
    38 Beamish Way
    Winslow
    MK18 3EU Buckingham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    38 Beamish Way
    Winslow
    MK18 3EU Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishAccountant27197660001
    MOORE, Gillian
    13 Basil Way
    South Shields
    NE34 8UA Tyne And Waer
    Secrétaire
    13 Basil Way
    South Shields
    NE34 8UA Tyne And Waer
    British113027650001
    NORTH, Leslie Lorraine
    61 The Boulevard
    Wylde Green
    B73 5JB Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    61 The Boulevard
    Wylde Green
    B73 5JB Birmingham
    West Midlands
    British79640310001
    CHILD, Colin Charles
    Waterside House
    Headbourne Worthy
    SO23 7JR Winchester
    Hants
    Administrateur
    Waterside House
    Headbourne Worthy
    SO23 7JR Winchester
    Hants
    EnglandBritishDirector125146440001
    JACKSON, Anthony Grahame
    Lavender Cottage The Green North
    OX10 7DW Warborough
    Oxon
    Administrateur
    Lavender Cottage The Green North
    OX10 7DW Warborough
    Oxon
    BritishCompany Director63026430001
    KENDLE, Richard John
    Stidulfe Meade
    Seal
    TN15 0AG Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Stidulfe Meade
    Seal
    TN15 0AG Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishCompany Director148997780001
    LANE, James
    Sandpipers, The Bulwarks
    St. Aubin
    JE3 8AB Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    Sandpipers, The Bulwarks
    St. Aubin
    JE3 8AB Jersey
    Channel Islands
    Channel IslandsBritishCompany Director51688590001
    PERRIN, Nicholas John
    Henley Road
    B95 5NN Ullenhall
    Treboro House
    Warwickshire
    Administrateur
    Henley Road
    B95 5NN Ullenhall
    Treboro House
    Warwickshire
    EnglandBritishAccountant174660810001
    RIDDY, Alan Michael
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    Administrateur
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    EnglandBritishDirector62615300004
    RIDDY, Alan Michael
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    Administrateur
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director62615300004
    WIPER, Robert
    The Hollow
    Moggie Lane
    SK10 4NY Adlington
    Cheshire
    Administrateur
    The Hollow
    Moggie Lane
    SK10 4NY Adlington
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director73690420002

    ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1991
    Livré le 05 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or patrick amos and/or barry broome to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    115,117 and 119 oak street, norwich, norfolk title no: nk 14446.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1991
    Livré le 05 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or patrick amos and/or barry broome to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    25,127, 129 oak streets norwich, norfolk title no: nk 81405.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1991
    Livré le 05 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or patrick amos and/or barry broome to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land and buildings on the west side oak street, norwich, norfolk title no: nk 46378.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1991
    Livré le 05 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or patrick amos and/or barry broome to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land at rear of 115,117 annd 119 oak strreet, norwich, norfolk title no: nk 14445.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1991
    Livré le 05 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or patrick amos and/or barry broome to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land at the rear of 125 oak street, norwich, norfolk title no: nk 62424.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mai 1989
    Livré le 02 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 01 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1985
    Livré le 02 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property known as 27, park road., Moreley, b'ham. T.n: wk 66376.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 02 mars 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1985
    Livré le 02 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property known as 29 park road., And land at back of 31 and 33 park rd., Moreley, b'ham. T.n: wk 227479.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 02 mars 1985Enregistrement d'une charge
    Single debenture
    Créé le 31 oct. 1984
    Livré le 09 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1984Enregistrement d'une charge

    ST. AUBIN PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 juin 2016Dissolved on
    25 juin 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0