JENWAY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJENWAY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01119693
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JENWAY LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe JENWAY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de JENWAY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour JENWAY LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour JENWAY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 5

    2 pagesMR05

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Eric Nevin le 01 juin 2015

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Adam David Robson en tant que directeur le 12 avr. 2015

    TM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 févr. 2015

    État du capital au 02 févr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Eric Nevin le 09 oct. 2014

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 janv. 2014

    État du capital au 23 janv. 2014

    • Capital: GBP 415,639
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Adam David Robson le 15 févr. 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Adam David Robson le 15 févr. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Adam David Robson le 06 déc. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Eric Nevin le 06 déc. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de JENWAY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMESTOWN INVESTMENTS LIMITED
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    Secrétaire
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    43844040001
    NEVIN, Michael Eric
    Suite 1924
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House
    United Kingdom
    Administrateur
    Suite 1924
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Partner112409940001
    BASHFORD, Sidney George
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    British2938770002
    BEAN, Roger James
    10 Highwood Close
    SL7 3PG Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    10 Highwood Close
    SL7 3PG Marlow
    Buckinghamshire
    British8855620001
    CULSHAW, Alasdair Douglas
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    Secrétaire
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    BritishDirector5333430001
    FAHY, Michael Jon
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary12938290003
    MORTON, John George
    13 Fermoy Road
    SS1 3HA Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    13 Fermoy Road
    SS1 3HA Southend On Sea
    Essex
    BritishFund Accountant45914390002
    SMITH, Eugene Luke
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    Secrétaire
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    BritishFinance Director55201820001
    BANNISTER, Andrew Charles
    Buckleigh
    Oval Way
    SL9 8QB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Buckleigh
    Oval Way
    SL9 8QB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director64381410001
    BASHFORD, Sidney George
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Janroma
    Bartholomew Green
    CM3 1QG Chelmsford
    Essex
    BritishElectronics Engineer2938770002
    BOYD, Simon John
    The Stables
    Millfarm Black Bourton
    OX18 2PE Bampton
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Stables
    Millfarm Black Bourton
    OX18 2PE Bampton
    Oxfordshire
    BritishCompany Director59715820002
    CHRISTIE, James Archibald
    Belmont
    2 Plums Lane Bardfield Saling
    CM7 5EH Braintree
    Essex
    Administrateur
    Belmont
    2 Plums Lane Bardfield Saling
    CM7 5EH Braintree
    Essex
    BritishManaging Director14773320002
    CULSHAW, Alasdair Douglas
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    Administrateur
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    BritishDirector5333430001
    DE FLORIN, Jill Wendy
    Lower Lodge
    Hope End
    HR8 1JG Ledbury
    Herefordshire
    Administrateur
    Lower Lodge
    Hope End
    HR8 1JG Ledbury
    Herefordshire
    BritishCompany Director14773310001
    FAHY, Michael Jon
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Farm Crescent
    Napsbury Park
    AL2 1UQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary12938290003
    FALL, Martyn John
    Slough Farm
    Stambourne
    CO9 4PD Halstead
    Essex
    Administrateur
    Slough Farm
    Stambourne
    CO9 4PD Halstead
    Essex
    EnglandBritishManaging Director106960880001
    HART, Paul Clifford
    11 Bulford Lane
    Black Notley
    CM7 8NW Braintree
    Essex
    Administrateur
    11 Bulford Lane
    Black Notley
    CM7 8NW Braintree
    Essex
    EnglandBritishManufacturing Director164220500001
    HORSFIELD, Philip
    Woodbine Cottage
    Priest Hutton
    LA6 1JL Carnforth
    Lancashire
    Administrateur
    Woodbine Cottage
    Priest Hutton
    LA6 1JL Carnforth
    Lancashire
    BritishFinance Director1842690001
    JONES, Kathryn Ada
    11b Osward Road
    SW17 7SS London
    Administrateur
    11b Osward Road
    SW17 7SS London
    United KingdomBritishInvestment Associate117914790001
    MAY, Richard Michael
    Garretts Garretts Lane
    Shalford
    CM7 5BA Braintree
    Essex
    Administrateur
    Garretts Garretts Lane
    Shalford
    CM7 5BA Braintree
    Essex
    BritishChairman30835240001
    MAYBURY, Peter Joseph
    Glenburn 13 Riddings Road
    Hale
    WA15 9DS Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Glenburn 13 Riddings Road
    Hale
    WA15 9DS Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishChief Executive2889740001
    O'CONNOR, Christopher James
    Canterbury House
    191 Huntingdon Road
    CB3 0DL Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Canterbury House
    191 Huntingdon Road
    CB3 0DL Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishManaging Director126446780001
    PARTRIDGE, David John
    Beauchamp House 26 Leam Terrace
    CV31 1BB Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Beauchamp House 26 Leam Terrace
    CV31 1BB Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector3880730002
    PERROTT, Hugh Richard Iliff
    Gilletts Farm Oast
    Water Lane
    TN27 8QB Smarden
    Kent
    Administrateur
    Gilletts Farm Oast
    Water Lane
    TN27 8QB Smarden
    Kent
    BritishCompany Director61012290001
    POSSEE, David Rowland
    22 Stubbs Lane
    CM7 3NR Braintree
    Essex
    Administrateur
    22 Stubbs Lane
    CM7 3NR Braintree
    Essex
    BritishAccountant77192600001
    RAMPTON, Geoffrey Roy
    Gunn Cottage
    Station Road South Leigh
    OX8 6XJ Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    Gunn Cottage
    Station Road South Leigh
    OX8 6XJ Witney
    Oxfordshire
    BritishDirector12413300001
    ROBSON, Adam David
    Floor
    Cayzer House 30 Buckingham Gate
    SW1E 6NN London
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Cayzer House 30 Buckingham Gate
    SW1E 6NN London
    1st
    United Kingdom
    EnglandBritishOperating Partner125503850001
    RUTHERFORD, James
    97 High Street
    CB2 5QB Harston
    Cambridgeshire
    Administrateur
    97 High Street
    CB2 5QB Harston
    Cambridgeshire
    BritishDirector92778600001
    SMITH, Desmond John
    5 The Rettery
    Hoxne Road
    IT23 7NJ Eye
    Suffolk
    Administrateur
    5 The Rettery
    Hoxne Road
    IT23 7NJ Eye
    Suffolk
    BritishDirector57814530001
    SMITH, Eugene Luke
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    33 The Oaks
    KT14 6RN West Byfleet
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director55201820001
    SPINK, Geoffrey
    Fiddlers Green
    Clandon Road, West Clandon
    GU4 7TL Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Fiddlers Green
    Clandon Road, West Clandon
    GU4 7TL Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector84940730001
    WHEELER, Mervyn James
    43 Nether Court
    CO9 2HN Halstead
    Essex
    Administrateur
    43 Nether Court
    CO9 2HN Halstead
    Essex
    BritishSales Director14773330001
    WICKS, Jonathon Neil
    2 Northbrook Copse
    Forest Park
    RG12 0UA Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    2 Northbrook Copse
    Forest Park
    RG12 0UA Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director56518060001
    WYNN, Edward Charles
    34 Windmill Lane
    DE6 1EY Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    34 Windmill Lane
    DE6 1EY Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritishSales And Marketing Director60801950001

    JENWAY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession
    Créé le 30 nov. 2007
    Livré le 08 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The mortgaged property means the real property listed in the schedule 2 to the debenture, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 08 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Créé le 19 août 1993
    Livré le 01 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £19,176.35 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 01 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge over book debts
    Créé le 18 déc. 1990
    Livré le 29 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement leasing agreement or on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    The ultimate balance due or owing to the company by tih under any present or future factoring agreement providing for the purchase by tih of book debts of the company. All other book and other debts and claims both present and future. (Please see doc M395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Trade Indemnity -Heller Commercial Financial Limited
    Transactions
    • 29 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 nov. 1990
    Livré le 26 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The cottage gransmore green, felsted, essex.
    Personnes ayant droit
    • Sidney George Bashford
    • Richard Michael May
    Transactions
    • 26 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 août 1978
    Livré le 13 sept. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & factory premises at grasmore green felsted essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank LTD
    Transactions
    • 13 sept. 1978Enregistrement d'une charge
    • 13 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0