JENWAY LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | JENWAY LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01119693 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe JENWAY LIMITED ?
Adresse du siège social | 4 Felstead Gardens Ferry Street E14 3BS London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de JENWAY LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour JENWAY LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour JENWAY LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 5 | 2 pages | MR05 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Eric Nevin le 01 juin 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Adam David Robson en tant que directeur le 12 avr. 2015 | TM01 | |||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Eric Nevin le 09 oct. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Adam David Robson le 15 févr. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Adam David Robson le 15 févr. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Adam David Robson le 06 déc. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Eric Nevin le 06 déc. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de JENWAY LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMESTOWN INVESTMENTS LIMITED | Secrétaire | 4 Felstead Gardens Ferry Street E14 3BS London | 43844040001 | |||||||
NEVIN, Michael Eric | Administrateur | Suite 1924 Bressenden Place SW1E 5RS London Portland House United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Partner | 112409940001 | ||||
BASHFORD, Sidney George | Secrétaire | Janroma Bartholomew Green CM3 1QG Chelmsford Essex | British | 2938770002 | ||||||
BEAN, Roger James | Secrétaire | 10 Highwood Close SL7 3PG Marlow Buckinghamshire | British | 8855620001 | ||||||
CULSHAW, Alasdair Douglas | Secrétaire | 20 Old Malt Way Horsell GU21 4QD Woking Surrey | British | Director | 5333430001 | |||||
FAHY, Michael Jon | Secrétaire | 2 Farm Crescent Napsbury Park AL2 1UQ St Albans Hertfordshire | British | Company Secretary | 12938290003 | |||||
MORTON, John George | Secrétaire | 13 Fermoy Road SS1 3HA Southend On Sea Essex | British | Fund Accountant | 45914390002 | |||||
SMITH, Eugene Luke | Secrétaire | 33 The Oaks KT14 6RN West Byfleet Surrey | British | Finance Director | 55201820001 | |||||
BANNISTER, Andrew Charles | Administrateur | Buckleigh Oval Way SL9 8QB Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Finance Director | 64381410001 | ||||
BASHFORD, Sidney George | Administrateur | Janroma Bartholomew Green CM3 1QG Chelmsford Essex | British | Electronics Engineer | 2938770002 | |||||
BOYD, Simon John | Administrateur | The Stables Millfarm Black Bourton OX18 2PE Bampton Oxfordshire | British | Company Director | 59715820002 | |||||
CHRISTIE, James Archibald | Administrateur | Belmont 2 Plums Lane Bardfield Saling CM7 5EH Braintree Essex | British | Managing Director | 14773320002 | |||||
CULSHAW, Alasdair Douglas | Administrateur | 20 Old Malt Way Horsell GU21 4QD Woking Surrey | British | Director | 5333430001 | |||||
DE FLORIN, Jill Wendy | Administrateur | Lower Lodge Hope End HR8 1JG Ledbury Herefordshire | British | Company Director | 14773310001 | |||||
FAHY, Michael Jon | Administrateur | 2 Farm Crescent Napsbury Park AL2 1UQ St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 12938290003 | ||||
FALL, Martyn John | Administrateur | Slough Farm Stambourne CO9 4PD Halstead Essex | England | British | Managing Director | 106960880001 | ||||
HART, Paul Clifford | Administrateur | 11 Bulford Lane Black Notley CM7 8NW Braintree Essex | England | British | Manufacturing Director | 164220500001 | ||||
HORSFIELD, Philip | Administrateur | Woodbine Cottage Priest Hutton LA6 1JL Carnforth Lancashire | British | Finance Director | 1842690001 | |||||
JONES, Kathryn Ada | Administrateur | 11b Osward Road SW17 7SS London | United Kingdom | British | Investment Associate | 117914790001 | ||||
MAY, Richard Michael | Administrateur | Garretts Garretts Lane Shalford CM7 5BA Braintree Essex | British | Chairman | 30835240001 | |||||
MAYBURY, Peter Joseph | Administrateur | Glenburn 13 Riddings Road Hale WA15 9DS Altrincham Cheshire | England | British | Chief Executive | 2889740001 | ||||
O'CONNOR, Christopher James | Administrateur | Canterbury House 191 Huntingdon Road CB3 0DL Cambridge Cambridgeshire | England | British | Managing Director | 126446780001 | ||||
PARTRIDGE, David John | Administrateur | Beauchamp House 26 Leam Terrace CV31 1BB Leamington Spa Warwickshire | British | Director | 3880730002 | |||||
PERROTT, Hugh Richard Iliff | Administrateur | Gilletts Farm Oast Water Lane TN27 8QB Smarden Kent | British | Company Director | 61012290001 | |||||
POSSEE, David Rowland | Administrateur | 22 Stubbs Lane CM7 3NR Braintree Essex | British | Accountant | 77192600001 | |||||
RAMPTON, Geoffrey Roy | Administrateur | Gunn Cottage Station Road South Leigh OX8 6XJ Witney Oxfordshire | British | Director | 12413300001 | |||||
ROBSON, Adam David | Administrateur | Floor Cayzer House 30 Buckingham Gate SW1E 6NN London 1st United Kingdom | England | British | Operating Partner | 125503850001 | ||||
RUTHERFORD, James | Administrateur | 97 High Street CB2 5QB Harston Cambridgeshire | British | Director | 92778600001 | |||||
SMITH, Desmond John | Administrateur | 5 The Rettery Hoxne Road IT23 7NJ Eye Suffolk | British | Director | 57814530001 | |||||
SMITH, Eugene Luke | Administrateur | 33 The Oaks KT14 6RN West Byfleet Surrey | England | British | Finance Director | 55201820001 | ||||
SPINK, Geoffrey | Administrateur | Fiddlers Green Clandon Road, West Clandon GU4 7TL Guildford Surrey | United Kingdom | British | Director | 84940730001 | ||||
WHEELER, Mervyn James | Administrateur | 43 Nether Court CO9 2HN Halstead Essex | British | Sales Director | 14773330001 | |||||
WICKS, Jonathon Neil | Administrateur | 2 Northbrook Copse Forest Park RG12 0UA Bracknell Berkshire | England | British | Company Director | 56518060001 | ||||
WYNN, Edward Charles | Administrateur | 34 Windmill Lane DE6 1EY Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | Sales And Marketing Director | 60801950001 |
JENWAY LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of accession | Créé le 30 nov. 2007 Livré le 08 déc. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The mortgaged property means the real property listed in the schedule 2 to the debenture, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A credit agreement entitled "prompt credit application" | Créé le 19 août 1993 Livré le 01 sept. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £19,176.35 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Brèves mentions All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge over book debts | Créé le 18 déc. 1990 Livré le 29 déc. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement leasing agreement or on any account whatsoever. | |
Brèves mentions The ultimate balance due or owing to the company by tih under any present or future factoring agreement providing for the purchase by tih of book debts of the company. All other book and other debts and claims both present and future. (Please see doc M395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 22 nov. 1990 Livré le 26 nov. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The cottage gransmore green, felsted, essex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 24 août 1978 Livré le 13 sept. 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land & factory premises at grasmore green felsted essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0