PYEROY LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PYEROY LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01126224 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PYEROY LIMITED ?
Adresse du siège social | Riverside House 9 Rolling Mill Road NE32 3DP Jarrow United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PYEROY LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PYEROY LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 avr. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 02 mai 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 avr. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PYEROY LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Jon Foulkes le 11 nov. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 6 pages | AA | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2023 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Kaefer Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 févr. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||
Cessation de Ralf Jürgen Koch en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 févr. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||
Changement d'adresse du siège social de Kirkstone House St. Omers Road Gateshead NE11 9EZ England à Riverside House 9 Rolling Mill Road Jarrow NE32 3DP le 25 janv. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 63 Portland Street Mansfield Woodhouse Mansfield Nottinghamshire NG19 8BE England à Kirkstone House St. Omers Road Gateshead NE11 9EZ le 09 mars 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 6 pages | AA | ||
Notification de Kaefer Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2020 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Wood Group Industrial Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2020 | 1 pages | PSC07 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Wood Group Industrial Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 mai 2020 | 2 pages | PSC05 | ||
Nomination de Mr Ian John Tattersall en tant qu'administrateur le 02 mars 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Compass Point 79-87 Kingston Road Staines Middlesex TW18 1DT à 63 Portland Street Mansfield Woodhouse Mansfield Nottinghamshire NG19 8BE le 06 mars 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Notification de Ralf Jürgen Koch en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 févr. 2020 | 2 pages | PSC01 | ||
Cessation de la nomination de Grant Rae Angus en tant que directeur le 05 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Christopher Jon Foulkes en tant qu'administrateur le 05 févr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de PYEROY LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOULKES, Christopher Jon | Administrateur | 9 Rolling Mill Road NE32 3DP Jarrow Riverside House United Kingdom | England | British | Snr Vice President | 266409050002 | ||||
TATTERSALL, Ian John | Administrateur | 9 Rolling Mill Road NE32 3DP Jarrow Riverside House United Kingdom | England | British | Managing Director Uk | 199885240001 | ||||
SPENCE, Douglas | Secrétaire | 14 Elston Close NE5 1JZ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 27975650001 | ||||||
ANDERSON, James Ernest | Administrateur | 79-87 Kingston Road TW18 1DT Staines Compass Point Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 169049660001 | ||||
ANGUS, Grant Rae | Administrateur | 79-87 Kingston Road TW18 1DT Staines Compass Point Middlesex | Scotland | British | Company Director | 197743170001 | ||||
BARR, John | Administrateur | 37 Springfield Park NE66 2NH Alnwick Northumberland | United Kingdom | British | Contracts Director | 27975680001 | ||||
BYRNE, Derek | Administrateur | St. Omers Road Western Riverside Route NE11 9EZ Gateshead Kirkstone House Tyne And Wear | Ireland | Irish | Director | 236605280001 | ||||
CRAIGS, Grahame | Administrateur | 34 Humford Way Bayard Wood NE22 5ET Bedlington Northumberland | United Kingdom | British | Quantity Surveyor | 36796550001 | ||||
DAYMOND, Kevon Peter | Administrateur | 79-87 Kingston Road TW18 1DT Staines Compass Point Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 169900900001 | ||||
DUFFY, Mark | Administrateur | St. Omers Road NE11 9EZ Gateshead Kirkstone House Tyne And Wear Great Britain | United Kingdom | British | Company Director | 183438800001 | ||||
FITZSIMONS, Brendan Michael | Administrateur | East Farm Monkton Village NE32 5NN Jarrow Tyne & Wear | United Kingdom | British | Manager | 30841010002 | ||||
GAMMAGE, Julian | Administrateur | 99 High Road Warmsworth DN4 9LZ Doncaster South Yorkshire | England | British | Director | 13299700001 | ||||
HALL, Darren | Administrateur | 90 The Wynd NE30 2TE Tynemouth Tyne & Wear | United Kingdom | British | Construction Director | 55198220002 | ||||
HARROW, Andrew David | Administrateur | 27 Kintyre Drive TS17 0HN Thornaby On Tees Cleveland | British | Company Director | 43521080002 | |||||
HAYTON, John | Administrateur | 7 Linden Road Ashbrooke SR2 9AU Sunderland Tyne & Wear | England | British | Director | 87007260001 | ||||
JEFFREY, John Alexander | Administrateur | Willow Lees, Mods Lane Commonside Road, Barlow S18 7RZ Dronfield Derbyshire | England | British | Consultant | 53969220002 | ||||
JORDAN, James | Administrateur | 17 Axwell Park Road NE21 5PB Blaydon On Tyne Tyne & Wear | British | Operations Director Marine | 49170970001 | |||||
MATTHEWS, Mark Allan | Administrateur | 22 Barrington Close Winstanley WN3 6JU Wigan Lancashire | British | Industrial Painting | 91286680001 | |||||
MAURER, Phillip Howard | Administrateur | The Front Middleton One Row DL2 1AP Darlington Briarfields Cottage | British | Director | 136161590001 | |||||
MOORHEAD, John William | Administrateur | 58 Woodburn Drive NE26 3HY Whitley Bay | British | General Manager | 576480001 | |||||
NICOL, Stephen James | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | Company Director | 162632260012 | ||||
O'DONNELL, John | Administrateur | 79-87 Kingston Road TW18 1DT Staines Compass Point Middlesex | Scotland | Scottish | Company Director | 203033680001 | ||||
PEEK, Robert | Administrateur | 40 Formby Close TS27 3PT Hartlepool Cleveland | British | Director | 75277850001 | |||||
PELHAM, Hugh Marcus | Administrateur | Bolton Old Hall Bolton On Swale DL10 6AQ Richmond Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 81390950001 | ||||
ROBINSON, David Frederick Paul | Administrateur | 1 Derwent Road Tynemouth NE30 3AH North Shields Tyne & Wear | British | Manager | 59133430001 | |||||
ROBINSON, Paul Thomas | Administrateur | Corner House Preston North Road NE29 9PX North Shields Tyne & Wear | United Kingdom | British | Civil Engineer | 55198240001 | ||||
SKIVINGTON, Hugh | Administrateur | 10 Robert Westalls Way Royal Quays NE29 6YF North Shields Tyne & Wear | Other | Company Director | 112240500001 | |||||
SPENCE, Douglas | Administrateur | 14 Elston Close NE5 1JZ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | Company Secretary | 27975650001 | ||||
STEPHENS, Gerald | Administrateur | Elysium 21 Hackwood Park NE46 1AX Hexham Northumberland | British | Commercial Director | 43520960001 | |||||
THOMPSON, Robert Frazer | Administrateur | 12 Larbre Crescent Whickham NE16 5YF Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | Flooring Manager | 46969990007 | ||||
THOMPSON, Robert | Administrateur | Leadgates NE19 2HB Great Whittington Northumberland | United Kingdom | British | Director | 576460003 | ||||
WELSH, John Lawrence Robertson | Administrateur | AB21 0TZ Kinellar Unit 1 & 2 Meikle Clinterty Aberdeen United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 121446760001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PYEROY LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaefer Limited | 31 août 2020 | Rolling Mill Road Viking Industrial Estate NE32 3DP Jarrow Riverside House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Ralf Jürgen Koch | 05 févr. 2020 | C/O Hpk Verwaltungs-Gmbh Hrb 3202 Bremen Bremen District Court Germany | Oui | ||||||||||
Nationalité: German Pays de résidence: Germany | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Wood Group Industrial Services Limited | 06 avr. 2016 | Portland Street Mansfield Woodhouse NG19 8BE Mansfield 63 Nottinghamshire England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
PYEROY LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 13 mars 2008 Livré le 14 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings on the north west side of fellside road whickham by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 19 déc. 2007 Livré le 22 déc. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land on the north side of fellside road whickham tyne & wear t/no TY135713. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 22 juil. 2005 Livré le 03 août 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/H land being moor park house, west churton t/no TY213238. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 03 févr. 1995 Livré le 09 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a land and buildings lying to the north of st omers road dunston tyne & wear t/no.TY241136 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 21 mai 1994 Livré le 08 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a kirkstone house shields road heworth gateshead tyne and wear t/n TY129514 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 20 mai 1994 Livré le 08 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti £72250 and other money due from the company to the chargee under the terms of the deed (as defined therein) | |
Brèves mentions F/H property k/a kirkstone house sheilds road heworth tyne and wear t/n TY129514. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Credit application | Créé le 04 août 1992 Livré le 13 août 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £29818-40 under the terms of the credit application | |
Brèves mentions All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See form 395 relevant to this charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Credit agreement | Créé le 27 févr. 1992 Livré le 10 mars 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £72,086.90 | |
Brèves mentions All rights title and interest in and to all sums payable under the insurances. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Credit agreement | Créé le 28 janv. 1991 Livré le 07 févr. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti £29,648 due from the company to the chargee under the terms of the agreement. | |
Brèves mentions All its right, title & interest in & to all sums payable under the insurance see form 395/m/309/c/ for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Credit agreement dated 16.7.90 | Créé le 16 juil. 1990 Livré le 28 juil. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the credit application. | |
Brèves mentions All right, title and interest on all sums payable under the insurance see form 395 ref: M222C for further details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 16 mai 1983 Livré le 19 mai 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property known as kirkstone house, shields rd, heworth gateshead, tyne & wear. And/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 27 sept. 1978 Livré le 03 oct. 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts stocks, shares and all other securities uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0