PYEROY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPYEROY LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01126224
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PYEROY LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe PYEROY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Riverside House
    9 Rolling Mill Road
    NE32 3DP Jarrow
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PYEROY LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PYEROY LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au18 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au18 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour PYEROY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Jon Foulkes le 11 nov. 2022

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023

    6 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2023 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Kaefer Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 févr. 2022

    2 pagesPSC05

    Cessation de Ralf Jürgen Koch en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 févr. 2022

    1 pagesPSC07

    Changement d'adresse du siège social de Kirkstone House St. Omers Road Gateshead NE11 9EZ England à Riverside House 9 Rolling Mill Road Jarrow NE32 3DP le 25 janv. 2022

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 63 Portland Street Mansfield Woodhouse Mansfield Nottinghamshire NG19 8BE England à Kirkstone House St. Omers Road Gateshead NE11 9EZ le 09 mars 2021

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    6 pagesAA

    Notification de Kaefer Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2020

    2 pagesPSC02

    Cessation de Wood Group Industrial Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2020

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Wood Group Industrial Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 mai 2020

    2 pagesPSC05

    Nomination de Mr Ian John Tattersall en tant qu'administrateur le 02 mars 2020

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Compass Point 79-87 Kingston Road Staines Middlesex TW18 1DT à 63 Portland Street Mansfield Woodhouse Mansfield Nottinghamshire NG19 8BE le 06 mars 2020

    1 pagesAD01

    Notification de Ralf Jürgen Koch en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 févr. 2020

    2 pagesPSC01

    Cessation de la nomination de Grant Rae Angus en tant que directeur le 05 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Christopher Jon Foulkes en tant qu'administrateur le 05 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de PYEROY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FOULKES, Christopher Jon
    9 Rolling Mill Road
    NE32 3DP Jarrow
    Riverside House
    United Kingdom
    Administrateur
    9 Rolling Mill Road
    NE32 3DP Jarrow
    Riverside House
    United Kingdom
    EnglandBritishSnr Vice President266409050002
    TATTERSALL, Ian John
    9 Rolling Mill Road
    NE32 3DP Jarrow
    Riverside House
    United Kingdom
    Administrateur
    9 Rolling Mill Road
    NE32 3DP Jarrow
    Riverside House
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director Uk199885240001
    SPENCE, Douglas
    14 Elston Close
    NE5 1JZ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    14 Elston Close
    NE5 1JZ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British27975650001
    ANDERSON, James Ernest
    79-87 Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point
    Middlesex
    Administrateur
    79-87 Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director169049660001
    ANGUS, Grant Rae
    79-87 Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point
    Middlesex
    Administrateur
    79-87 Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point
    Middlesex
    ScotlandBritishCompany Director197743170001
    BARR, John
    37 Springfield Park
    NE66 2NH Alnwick
    Northumberland
    Administrateur
    37 Springfield Park
    NE66 2NH Alnwick
    Northumberland
    United KingdomBritishContracts Director27975680001
    BYRNE, Derek
    St. Omers Road
    Western Riverside Route
    NE11 9EZ Gateshead
    Kirkstone House
    Tyne And Wear
    Administrateur
    St. Omers Road
    Western Riverside Route
    NE11 9EZ Gateshead
    Kirkstone House
    Tyne And Wear
    IrelandIrishDirector236605280001
    CRAIGS, Grahame
    34 Humford Way
    Bayard Wood
    NE22 5ET Bedlington
    Northumberland
    Administrateur
    34 Humford Way
    Bayard Wood
    NE22 5ET Bedlington
    Northumberland
    United KingdomBritishQuantity Surveyor36796550001
    DAYMOND, Kevon Peter
    79-87 Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point
    Middlesex
    Administrateur
    79-87 Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director169900900001
    DUFFY, Mark
    St. Omers Road
    NE11 9EZ Gateshead
    Kirkstone House
    Tyne And Wear
    Great Britain
    Administrateur
    St. Omers Road
    NE11 9EZ Gateshead
    Kirkstone House
    Tyne And Wear
    Great Britain
    United KingdomBritishCompany Director183438800001
    FITZSIMONS, Brendan Michael
    East Farm
    Monkton Village
    NE32 5NN Jarrow
    Tyne & Wear
    Administrateur
    East Farm
    Monkton Village
    NE32 5NN Jarrow
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishManager30841010002
    GAMMAGE, Julian
    99 High Road
    Warmsworth
    DN4 9LZ Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    99 High Road
    Warmsworth
    DN4 9LZ Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector13299700001
    HALL, Darren
    90 The Wynd
    NE30 2TE Tynemouth
    Tyne & Wear
    Administrateur
    90 The Wynd
    NE30 2TE Tynemouth
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishConstruction Director55198220002
    HARROW, Andrew David
    27 Kintyre Drive
    TS17 0HN Thornaby On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    27 Kintyre Drive
    TS17 0HN Thornaby On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director43521080002
    HAYTON, John
    7 Linden Road
    Ashbrooke
    SR2 9AU Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    7 Linden Road
    Ashbrooke
    SR2 9AU Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector87007260001
    JEFFREY, John Alexander
    Willow Lees, Mods Lane
    Commonside Road, Barlow
    S18 7RZ Dronfield
    Derbyshire
    Administrateur
    Willow Lees, Mods Lane
    Commonside Road, Barlow
    S18 7RZ Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritishConsultant53969220002
    JORDAN, James
    17 Axwell Park Road
    NE21 5PB Blaydon On Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    17 Axwell Park Road
    NE21 5PB Blaydon On Tyne
    Tyne & Wear
    BritishOperations Director Marine49170970001
    MATTHEWS, Mark Allan
    22 Barrington Close
    Winstanley
    WN3 6JU Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    22 Barrington Close
    Winstanley
    WN3 6JU Wigan
    Lancashire
    BritishIndustrial Painting91286680001
    MAURER, Phillip Howard
    The Front
    Middleton One Row
    DL2 1AP Darlington
    Briarfields Cottage
    Administrateur
    The Front
    Middleton One Row
    DL2 1AP Darlington
    Briarfields Cottage
    BritishDirector136161590001
    MOORHEAD, John William
    58 Woodburn Drive
    NE26 3HY Whitley Bay
    Administrateur
    58 Woodburn Drive
    NE26 3HY Whitley Bay
    BritishGeneral Manager576480001
    NICOL, Stephen James
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Administrateur
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director162632260012
    O'DONNELL, John
    79-87 Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point
    Middlesex
    Administrateur
    79-87 Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point
    Middlesex
    ScotlandScottishCompany Director203033680001
    PEEK, Robert
    40 Formby Close
    TS27 3PT Hartlepool
    Cleveland
    Administrateur
    40 Formby Close
    TS27 3PT Hartlepool
    Cleveland
    BritishDirector75277850001
    PELHAM, Hugh Marcus
    Bolton Old Hall
    Bolton On Swale
    DL10 6AQ Richmond
    Yorkshire
    Administrateur
    Bolton Old Hall
    Bolton On Swale
    DL10 6AQ Richmond
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector81390950001
    ROBINSON, David Frederick Paul
    1 Derwent Road
    Tynemouth
    NE30 3AH North Shields
    Tyne & Wear
    Administrateur
    1 Derwent Road
    Tynemouth
    NE30 3AH North Shields
    Tyne & Wear
    BritishManager59133430001
    ROBINSON, Paul Thomas
    Corner House Preston North Road
    NE29 9PX North Shields
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Corner House Preston North Road
    NE29 9PX North Shields
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCivil Engineer55198240001
    SKIVINGTON, Hugh
    10 Robert Westalls Way
    Royal Quays
    NE29 6YF North Shields
    Tyne & Wear
    Administrateur
    10 Robert Westalls Way
    Royal Quays
    NE29 6YF North Shields
    Tyne & Wear
    OtherCompany Director112240500001
    SPENCE, Douglas
    14 Elston Close
    NE5 1JZ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    14 Elston Close
    NE5 1JZ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritishCompany Secretary27975650001
    STEPHENS, Gerald
    Elysium 21 Hackwood Park
    NE46 1AX Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    Elysium 21 Hackwood Park
    NE46 1AX Hexham
    Northumberland
    BritishCommercial Director43520960001
    THOMPSON, Robert Frazer
    12 Larbre Crescent
    Whickham
    NE16 5YF Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    12 Larbre Crescent
    Whickham
    NE16 5YF Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishFlooring Manager46969990007
    THOMPSON, Robert
    Leadgates
    NE19 2HB Great Whittington
    Northumberland
    Administrateur
    Leadgates
    NE19 2HB Great Whittington
    Northumberland
    United KingdomBritishDirector576460003
    WELSH, John Lawrence Robertson
    AB21 0TZ Kinellar
    Unit 1 & 2 Meikle Clinterty
    Aberdeen
    United Kingdom
    Administrateur
    AB21 0TZ Kinellar
    Unit 1 & 2 Meikle Clinterty
    Aberdeen
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director121446760001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PYEROY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Rolling Mill Road
    Viking Industrial Estate
    NE32 3DP Jarrow
    Riverside House
    England
    31 août 2020
    Rolling Mill Road
    Viking Industrial Estate
    NE32 3DP Jarrow
    Riverside House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleLaw Of England And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03132937
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Ralf Jürgen Koch
    C/O Hpk Verwaltungs-Gmbh
    Hrb 3202
    Bremen
    Bremen District Court
    Germany
    05 févr. 2020
    C/O Hpk Verwaltungs-Gmbh
    Hrb 3202
    Bremen
    Bremen District Court
    Germany
    Oui
    Nationalité: German
    Pays de résidence: Germany
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Wood Group Industrial Services Limited
    Portland Street
    Mansfield Woodhouse
    NG19 8BE Mansfield
    63
    Nottinghamshire
    England
    06 avr. 2016
    Portland Street
    Mansfield Woodhouse
    NG19 8BE Mansfield
    63
    Nottinghamshire
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies In England And Wales
    Numéro d'enregistrement05159696
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PYEROY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 13 mars 2008
    Livré le 14 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the north west side of fellside road whickham by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 19 déc. 2007
    Livré le 22 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north side of fellside road whickham tyne & wear t/no TY135713. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Acting as Agent for National Westminster Bank PLC)
    Transactions
    • 22 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 juil. 2005
    Livré le 03 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land being moor park house, west churton t/no TY213238. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 03 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 03 févr. 1995
    Livré le 09 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land and buildings lying to the north of st omers road dunston tyne & wear t/no.TY241136 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 mai 1994
    Livré le 08 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a kirkstone house shields road heworth gateshead tyne and wear t/n TY129514 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 mai 1994
    Livré le 08 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £72250 and other money due from the company to the chargee under the terms of the deed (as defined therein)
    Brèves mentions
    F/H property k/a kirkstone house sheilds road heworth tyne and wear t/n TY129514. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of Pyeroy Limited Pension Scheme Robert Thompson, Sheila Patricia Thompsonand Suntrust Limited
    Transactions
    • 08 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit application
    Créé le 04 août 1992
    Livré le 13 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £29818-40 under the terms of the credit application
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See form 395 relevant to this charge.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 13 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 27 févr. 1992
    Livré le 10 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £72,086.90
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and to all sums payable under the insurances.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 10 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 28 janv. 1991
    Livré le 07 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £29,648 due from the company to the chargee under the terms of the agreement.
    Brèves mentions
    All its right, title & interest in & to all sums payable under the insurance see form 395/m/309/c/ for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement dated 16.7.90
    Créé le 16 juil. 1990
    Livré le 28 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the credit application.
    Brèves mentions
    All right, title and interest on all sums payable under the insurance see form 395 ref: M222C for further details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited.
    Transactions
    • 28 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 mai 1983
    Livré le 19 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property known as kirkstone house, shields rd, heworth gateshead, tyne & wear. And/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 sept. 1978
    Livré le 03 oct. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts stocks, shares and all other securities uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 oct. 1978Enregistrement d'une charge
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0