ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED

ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01129454
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES PLC16 août 197316 août 1973

    Quels sont les derniers comptes de ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 011294540025 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 011294540026 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Michael Ben Jenkins en tant que directeur le 31 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Philip Simon Slavin en tant qu'administrateur le 13 févr. 2020

    2 pagesAP01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 13 déc. 2019

    • Capital: GBP 100
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    The company capital redemption reserve account of the company be cancelled 09/12/2019
    RES13

    Cessation de la nomination de Angus Alexander Dodd en tant que directeur le 07 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 03 avr. 2018

    • Capital: GBP 100
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium a/c cancelled 12/03/2018
    RES13

    État du capital au 15 févr. 2018

    • Capital: GBP 100
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Qui sont les dirigeants de ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEAZELL, Frances Victoria
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    215875630001
    SAUNDERS, James Michael Edward
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish192568400002
    SLAVIN, Philip Simon
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish267205160001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Secrétaire
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Secrétaire
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    GIBSON, Timothy David
    52a Grenville Road
    N19 4EH London
    Secrétaire
    52a Grenville Road
    N19 4EH London
    British50070710001
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175104150001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    ROBSON SKEETE, Gail
    17 Field Close
    Locks Heath
    SO31 6TX Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    17 Field Close
    Locks Heath
    SO31 6TX Southampton
    Hampshire
    British58498140001
    WOOLLEY, Peter Thomas Griffith
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British39676720001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Secrétaire
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    AL-SAGER, Mohammed Jassem
    Dahiyat Abdullah Al Salem
    Area 4 Street No 43 Viilla 24
    FOREIGN Kuwait City Kuwaiti
    Administrateur
    Dahiyat Abdullah Al Salem
    Area 4 Street No 43 Viilla 24
    FOREIGN Kuwait City Kuwaiti
    British36413770001
    ARRA, Giorgio
    26 Hereford House
    66 North Row
    W1R 1DE London
    Administrateur
    26 Hereford House
    66 North Row
    W1R 1DE London
    Italian71142090001
    BROOKER, Alfred Thomas
    Crispin
    The Approach, Dormans Park
    RH19 3NU East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    Crispin
    The Approach, Dormans Park
    RH19 3NU East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritish29444930001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Administrateur
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish184444990001
    CLARK, James Robert
    Logmore 37 The Avenue
    SM2 7QA Cheam
    Surrey
    Administrateur
    Logmore 37 The Avenue
    SM2 7QA Cheam
    Surrey
    United KingdomBritish52063220001
    DEAR, Michael Raymond
    16 Calvin Close
    GU15 1DN Camberley
    Surrey
    Administrateur
    16 Calvin Close
    GU15 1DN Camberley
    Surrey
    British11171470001
    DODD, Angus Alexander
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish201606390001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Administrateur
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritish35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Administrateur
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Administrateur
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritish151855940001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Administrateur
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Administrateur
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritish84913850002
    HOOPER, Patrick Paul
    Thornfield 92 Station Road
    Balsall Common
    CV7 7FL Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    Thornfield 92 Station Road
    Balsall Common
    CV7 7FL Coventry
    West Midlands
    British455570001
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Administrateur
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish164108510003
    JENKINS, Michael Ben
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish221017630001
    KATZ, Jonathan
    60 Mount Ephraim Lane
    SW16 1JD London
    Administrateur
    60 Mount Ephraim Lane
    SW16 1JD London
    EnglandBritish33805490001
    KNIGHT, Eric
    7 Boulevard Des Moulins
    MC9800 Monaco
    Administrateur
    7 Boulevard Des Moulins
    MC9800 Monaco
    Italian55114600003
    LAZARUS, James Nicholas
    Misbourne 47 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Misbourne 47 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish8315580001
    PARRY, John Richard
    High Barn The Paddocks
    Dog Kennel Lane
    WD3 5EE Chorleywood
    Hertfordshire
    Administrateur
    High Barn The Paddocks
    Dog Kennel Lane
    WD3 5EE Chorleywood
    Hertfordshire
    British2995850001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SANDERSON, Eric Fenton
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish126848980001
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Administrateur
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2694983
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 nov. 2017
    Livré le 07 nov. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Homes and Communities Agency
    Transactions
    • 07 nov. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 03 nov. 2016
    Livré le 15 nov. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch, 90 Long Acre, London, WC2E 9RA (As Common Security Agent for Each of the Secured Parties)
    Transactions
    • 15 nov. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge security agreement
    Créé le 14 mars 2008
    Livré le 17 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transactions
    • 17 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement
    Créé le 04 févr. 2008
    Livré le 15 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transactions
    • 15 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security agreement
    Créé le 29 janv. 2008
    Livré le 07 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transactions
    • 07 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security agreement
    Créé le 29 janv. 2008
    Livré le 01 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transactions
    • 01 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 22 oct. 2007
    Livré le 25 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transactions
    • 25 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 26 oct. 2005
    Livré le 11 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 26 oct. 2005
    Livré le 11 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage by way of assignment
    Créé le 03 mars 2000
    Livré le 09 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a legal mortgage dated 25TH march 1999
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in and to a building contract dated 4TH october 1999 made between holmes building PLC (1) and the company (2) (the "building contract").. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 09 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 mars 1999
    Livré le 30 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land lying to the north of holloway lane harmondsworth hillingdon t/n AGL17932 along with the goodwill of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 30 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 07 déc. 1998
    Livré le 11 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever except for any obligation which, if it were so included, would result in a contravention of section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 11 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 mai 1998
    Livré le 08 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    22 buckingham gate l/b of city of westminster t/n 61747.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 janv. 1998
    Livré le 17 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H mevile house 8 10 & 12 woodhouse road finchley london N3 t/n NGL429496.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 17 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 févr. 1996
    Livré le 20 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    29 buckingham gate, l/b of city of westminster t/no: 44712.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Shares charge
    Créé le 23 janv. 1995
    Livré le 31 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under each of a credit agreement of even date,the debenture dated 26TH january 1995,the subordination deed dated 23RD january 1995 and this charge
    Brèves mentions
    100 ordinary shares of £1 each fully paid up and 50,000 ordinary £1 shares paid up as to 25 pence each in the issued capital; all other shares in english & overseas investments PLC.......all stocks,shares and other securities.............etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 31 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 avr. 1989
    Livré le 06 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    77 st john street, london EC1.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 06 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 avr. 1989
    Livré le 14 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The coalyard marsh lane hampton in arden west midlands t/n wm 441272.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 avr. 1989
    Livré le 14 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Enterprise house fentham road hampton in arden west midlands t/nos: wm 294348 & wm 439700.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 juil. 1988
    Livré le 13 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or blegberry limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H property k/a 94 & 94A st john's wood high street london NW8 T.N. ln 104564.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 12 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    28/30 coppergate york north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 12 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5/6 horsemarket darlington durham. Title no:- du 22186.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 12 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at pembroke park waterbeach cambridge cambridgeshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 12 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at maskell road and garratt lane l/b of wandsworth.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 12 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17 st sepulchre gate doncaster south yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0