AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01130005 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | 8th Floor 5 Merchant Square W2 1AS London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Mark David Ranyard en tant que directeur le 21 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Erika Brennan en tant que secrétaire le 01 nov. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Jonathan Wilson en tant qu'administrateur le 01 oct. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Leslie Dobinson en tant que directeur le 11 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Maximilian Dressendoerfer le 26 mai 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark David Ranyard le 26 mai 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Hartwig Masuch le 26 mai 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Alexi Cory-Smith le 26 mai 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Leslie Dobinson le 26 mai 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 33 Wigmore Street London W1U 1QX à 8th Floor 5 Merchant Square London W2 1AS le 26 mai 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Maximilian Dressendoerfer le 17 oct. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Alexi Cory-Smith le 17 oct. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark David Ranyard le 17 oct. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN England à Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London England W1D 3JB | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN | 1 pages | AD03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 23 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Julian French en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENNAN, Erika | Secrétaire | 5 Merchant Square W2 1AS London 8th Floor United Kingdom | 202754140001 | |||||||
CORY-SMITH, Alexi | Administrateur | 5 Merchant Square W2 1AS London 8th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Senior Vice President | 130148150002 | ||||
DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr | Administrateur | 5 Merchant Square W2 1AS London 8th Floor United Kingdom | Germany | German | None | 157717080010 | ||||
MASUCH, Hartwig | Administrateur | 5 Merchant Square W2 1AS London 8th Floor United Kingdom | Germany | German | Chief Executive Officer | 157716080001 | ||||
WILSON, Paul Jonathan | Administrateur | 5 Merchant Square W2 1AS London 8th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 201764770001 | ||||
FRENCH, Julian | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 United Kingdom | 181311950001 | |||||||
HARVEY, Simon | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 United Kingdom | British | 159313010001 | ||||||
MOLLETT, Andrew John | Secrétaire | Crieff Road Wandsworth SW18 2EB London 19 United Kingdom | British | 84808940002 | ||||||
POTTERELL, Clive Ronald | Secrétaire | Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue KT7 0HF Thames Ditton Surrey | British | 3182530002 | ||||||
BURGESS, John Edward | Administrateur | 2 Sudbury Hill Harrow On The Hill HA1 3SB Harrow Middlesex | British | Managing Director | 1987530001 | |||||
BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson | Administrateur | Bullrush Farm Hillgrove Lurgashall GU28 9EP Petworth West Sussex | United Kingdom | British | Financial Director | 36186210001 | ||||
CONNOLE, Michael Damien | Administrateur | 117 Thornbury Road TW7 4ND Isleworth Middlesex | England | Irish | Accountant | 47934750001 | ||||
DOBINSON, John Leslie | Administrateur | 5 Merchant Square W2 1AS London 8th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 34942720003 | ||||
FENTON, Neil Robert | Administrateur | 2 Arbuthnot Road SE14 5NP New Cross London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 39021340002 | ||||
LASCELLES, Robert Jeremy Hugh, Mr. | Administrateur | Keble Place SW13 8HL London 15 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 150637740002 | ||||
LEWIS, Stephen Graeme | Administrateur | 40 Litchfield Way NW11 6NG London | British | Music Publisher | 34323630001 | |||||
MOLLETT, Andrew John | Administrateur | Crieff Road Wandsworth SW18 2EB London 19 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 84808940002 | ||||
POTTERELL, Clive Ronald | Administrateur | Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue KT7 0HF Thames Ditton Surrey | England | British | Company Secretary | 3182530002 | ||||
RANYARD, Mark David | Administrateur | 5 Merchant Square W2 1AS London 8th Floor United Kingdom | England | British | Finance Director | 154884950002 |
AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture between chrysalis music limited (the borrower) each of the chargors (as defined) and music finance corp. (The "mf lender") | Créé le 02 mars 2001 Livré le 22 mars 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti A covenant by the borrower with the mf lender to discharge each and every liability which the chargors may now or hereafter have to the mf lender under or pursuant to the facility agreement the debenture or any other chrysalis transaction document and to discharge or pay to the mf lender when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) now or hereafter owing due or incurred by chargors to the mf lender in respect of any such liabilities in accordance with the terms set out in the facility agreement the debenture or any other chrysalis transaction document (the "secured amounts") | |
Brèves mentions All of the company's right title benefit and interest in and to each of the chrysalis transaction documents to which it is a party including a). The facility agreement b). The assignment agreement dated 2ND march 2001 between, inter alia,chrysalis music publishing B.V. and chrysalis music international B.V. c). The assignment agreement dated 2ND march 2001 between the mf lender,the borrower and chrysalis music publishing limited, d). The master admistration agreement e). The hedge agreement f). The german security agreement dated 27TH february 2001 between fanfare kg and the borrower g). The assignment agreement dated 2ND march 2001 between acsl, the borrower and air chrysalis scandinavia ab and h). The hedge administration agreement together with floating charge over all undertaking and assets other than assets charged by way of fixed charge above.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0