AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED

AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01130005
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8th Floor 5 Merchant Square
    W2 1AS London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    A.I.R. RADIO PRODUCTIONS LIMITED20 août 197320 août 1973

    Quels sont les derniers comptes de AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 févr. 2016

    État du capital au 07 févr. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Mark David Ranyard en tant que directeur le 21 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Erika Brennan en tant que secrétaire le 01 nov. 2015

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Paul Jonathan Wilson en tant qu'administrateur le 01 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Leslie Dobinson en tant que directeur le 11 juin 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Maximilian Dressendoerfer le 26 mai 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark David Ranyard le 26 mai 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Hartwig Masuch le 26 mai 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Alexi Cory-Smith le 26 mai 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Leslie Dobinson le 26 mai 2015

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 33 Wigmore Street London W1U 1QX à 8th Floor 5 Merchant Square London W2 1AS le 26 mai 2015

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 janv. 2015

    État du capital au 28 janv. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Maximilian Dressendoerfer le 17 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Alexi Cory-Smith le 17 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark David Ranyard le 17 oct. 2014

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN England à Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London England W1D 3JB

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN

    1 pagesAD03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    23 pagesAA

    Cessation de la nomination de Julian French en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Qui sont les dirigeants de AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRENNAN, Erika
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    202754140001
    CORY-SMITH, Alexi
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Vice President130148150002
    DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    GermanyGermanNone157717080010
    MASUCH, Hartwig
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    GermanyGermanChief Executive Officer157716080001
    WILSON, Paul Jonathan
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector201764770001
    FRENCH, Julian
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    181311950001
    HARVEY, Simon
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    British159313010001
    MOLLETT, Andrew John
    Crieff Road
    Wandsworth
    SW18 2EB London
    19
    United Kingdom
    Secrétaire
    Crieff Road
    Wandsworth
    SW18 2EB London
    19
    United Kingdom
    British84808940002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    BURGESS, John Edward
    2 Sudbury Hill
    Harrow On The Hill
    HA1 3SB Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    2 Sudbury Hill
    Harrow On The Hill
    HA1 3SB Harrow
    Middlesex
    BritishManaging Director1987530001
    BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritishFinancial Director36186210001
    CONNOLE, Michael Damien
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    Administrateur
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    EnglandIrishAccountant47934750001
    DOBINSON, John Leslie
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Operating Officer34942720003
    FENTON, Neil Robert
    2 Arbuthnot Road
    SE14 5NP New Cross
    London
    Administrateur
    2 Arbuthnot Road
    SE14 5NP New Cross
    London
    United KingdomBritishChartered Accountant39021340002
    LASCELLES, Robert Jeremy Hugh, Mr.
    Keble Place
    SW13 8HL London
    15
    United Kingdom
    Administrateur
    Keble Place
    SW13 8HL London
    15
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector150637740002
    LEWIS, Stephen Graeme
    40 Litchfield Way
    NW11 6NG London
    Administrateur
    40 Litchfield Way
    NW11 6NG London
    BritishMusic Publisher34323630001
    MOLLETT, Andrew John
    Crieff Road
    Wandsworth
    SW18 2EB London
    19
    United Kingdom
    Administrateur
    Crieff Road
    Wandsworth
    SW18 2EB London
    19
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant84808940002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritishCompany Secretary3182530002
    RANYARD, Mark David
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director154884950002

    AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture between chrysalis music limited (the borrower) each of the chargors (as defined) and music finance corp. (The "mf lender")
    Créé le 02 mars 2001
    Livré le 22 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A covenant by the borrower with the mf lender to discharge each and every liability which the chargors may now or hereafter have to the mf lender under or pursuant to the facility agreement the debenture or any other chrysalis transaction document and to discharge or pay to the mf lender when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) now or hereafter owing due or incurred by chargors to the mf lender in respect of any such liabilities in accordance with the terms set out in the facility agreement the debenture or any other chrysalis transaction document (the "secured amounts")
    Brèves mentions
    All of the company's right title benefit and interest in and to each of the chrysalis transaction documents to which it is a party including a). The facility agreement b). The assignment agreement dated 2ND march 2001 between, inter alia,chrysalis music publishing B.V. and chrysalis music international B.V. c). The assignment agreement dated 2ND march 2001 between the mf lender,the borrower and chrysalis music publishing limited, d). The master admistration agreement e). The hedge agreement f). The german security agreement dated 27TH february 2001 between fanfare kg and the borrower g). The assignment agreement dated 2ND march 2001 between acsl, the borrower and air chrysalis scandinavia ab and h). The hedge administration agreement together with floating charge over all undertaking and assets other than assets charged by way of fixed charge above.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Music Finance Corp. (The "Mf Lender")
    Transactions
    • 22 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0