J.M. COMPUTING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | J.M. COMPUTING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01131358 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe J.M. COMPUTING LIMITED ?
Adresse du siège social | Found Studios 1 Lindsey Street EC1A 9HP London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de J.M. COMPUTING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour J.M. COMPUTING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sebastian Christopher Gray le 04 oct. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2016 | 22 pages | AA | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2016 au 30 juin 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Big Studios 1 East Poultry Avenue London EC1A 9PT England à Found Studios 1 Lindsey Street London EC1A 9HP | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Big Studios 1 East Poultry Avenue London EC1A 9PT à Found Studios 1 Lindsey Street London EC1A 9HP le 13 janv. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2016 au 31 mars 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 011313580015 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 011313580016 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 011313580014 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rosa Kathleen Howard en tant que directeur le 23 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rosa Howard en tant que secrétaire le 23 juin 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 01 mai 2015 | 20 pages | AA | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2015 au 30 avr. 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Brabners Chaffe Street Llp 55 King Street Manchester M2 4LQ England à Big Studios 1 East Poultry Avenue London EC1A 9PT | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Inscription de la charge 011313580016, créée le 22 déc. 2015 | 54 pages | MR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Riverside Agecroft Road, Swinton Manchester Lancashire M27 8SJ à Big Studios 1 East Poultry Avenue London EC1A 9PT le 11 juin 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Malcolm Sykes en tant que directeur le 01 mai 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de J.M. COMPUTING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAY, Sebastian Christopher | Administrateur | 1 Lindsey Street EC1A 9HP London Found Studios England | United Kingdom | British | Company Director | 80251590006 | ||||
GILL, David | Secrétaire | Bradgreen Road M30 8BZ Monton 8 Manchester United Kingdom | British | Financial Controler | 91363310001 | |||||
HOWARD, Rosa | Secrétaire | 1 East Poultry Avenue EC1A 9PT London Big Studios England | 198447090001 | |||||||
TOBIN, Paul Denis | Secrétaire | 30 Longcroft Tyldesley M29 7EN Manchester Lancashire | British | 32246840001 | ||||||
BENTLEY, Michael James | Administrateur | Riverside Agecroft Road, Swinton M27 8SJ Manchester Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 91340350004 | ||||
BUCHAN, George Allan | Administrateur | White Lodge 3 Whitehall Road M33 3WJ Sale Cheshire | United Kingdom | British | Director | 5639810002 | ||||
BURGESS, Andrew Colin | Administrateur | Gleneagles Way BL0 9QN Ramsbottom 2 Lancashire United Kingdom | England | British | Director | 198565320001 | ||||
COLEMAN, David John | Administrateur | 24 Quayside Mews WA13 0HZ Lymm Cheshire | British | Director | 51293000002 | |||||
DALTON, John Ralph | Administrateur | 78 Meadway Bramhall SK7 1NL Stockport Cheshire | British | Director | 51292940001 | |||||
GILL, David | Administrateur | Bradgreen Road M30 8BZ Monton 8 Manchester United Kingdom | England | British | Financial Controler | 91363310001 | ||||
HOWARD, Rosa Kathleen | Administrateur | 1 East Poultry Avenue EC1A 9PT London Big Studios England | England | British | Company Director | 126564410001 | ||||
ISHERWOOD, Nicholas Jonathan | Administrateur | 37 Kiers Court Arcon Village Horwich BL6 6TN Bolton Lancashire | England | British | Company Director | 91340110006 | ||||
JONES, Robert Powis | Administrateur | 223 Mosley Common Road Worsley M28 1SF Manchester Lancashire | England | British | Company Director | 114639940001 | ||||
MAXWELL, Timothy Charles | Administrateur | 232 Broad Lane Burnedge Lane OL16 4PR Rochdale Lancashire | England | British | Company Director | 91340020001 | ||||
STEELE, Lauren | Administrateur | 1 Hamilton Mews St Anns Road Prestwich M25 9LE Manchester Lancashire | England | British | Company Director | 124040990001 | ||||
SYKES, Malcolm | Administrateur | 31 Parsons Drive Middleton M24 5DJ Manchester Lancashire | England | British | Technical Director | 32256900001 | ||||
TOBIN, Paul Denis | Administrateur | 30 Longcroft Tyldesley M29 7EN Manchester Lancashire | British | Managing Director | 32246840001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur J.M. COMPUTING LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Sebastian Christopher Gray | 06 avr. 2016 | 1 Lindsey Street EC1A 9HP London Found Studios England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
|
J.M. COMPUTING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 22 déc. 2015 Livré le 29 déc. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Lease of premises at riverside house riverside agecroft road pendlebury swinton manchester,lease of land and buildings to the north and west of riverside house please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 01 mai 2015 Livré le 07 mai 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Lease of premises at riverside house riverside agecroft road pendlebury swinton manchester. Lease of land and buildings to the north and west of riverside house (the second lease). La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 01 mai 2015 Livré le 07 mai 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 19 déc. 2006 Livré le 21 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Créé le 19 déc. 2006 Livré le 21 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 21 juil. 2003 Livré le 23 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 juil. 2003 Livré le 23 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from jmc.it group limited to the loan note holders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 16 juin 1994 Livré le 21 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Prompt credit application | Créé le 13 mai 1993 Livré le 26 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £16,271.20 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Brèves mentions All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A credit agreement | Créé le 21 sept. 1992 Livré le 01 oct. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £23427.91 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance for full details see form 395. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A credit agreement | Créé le 20 sept. 1991 Livré le 08 oct. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti £17,236.80 due or to become due from the company to the chargeee under the terms of the charge | |
Brèves mentions All its right title and interest in and to all sums payable (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A credit agreement | Créé le 14 sept. 1990 Livré le 28 sept. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti £28,223-39 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement. | |
Brèves mentions All its right, title and interest in and to all sums payable under the insurance (please see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 févr. 1988 Livré le 26 févr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement dated 29/1/88 | |
Brèves mentions All the book and other debts due to the company. From time to time howsoever by way of a first fixed charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 29 janv. 1988 Livré le 09 févr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Stocks shares & securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Collateral debenture | Créé le 29 janv. 1988 Livré le 03 févr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from judge 0TABLE LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions The basement & ground floors & part of the first floor of heritage house 393-395 bury new road, salford manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 21 déc. 1981 Livré le 31 déc. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0