J.M. COMPUTING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJ.M. COMPUTING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01131358
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de J.M. COMPUTING LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe J.M. COMPUTING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Found Studios
    1 Lindsey Street
    EC1A 9HP London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de J.M. COMPUTING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOUNDBROW LIMITED28 août 197328 août 1973

    Quels sont les derniers comptes de J.M. COMPUTING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour J.M. COMPUTING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sebastian Christopher Gray le 04 oct. 2018

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2016

    22 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2016 au 30 juin 2016

    1 pagesAA01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Big Studios 1 East Poultry Avenue London EC1A 9PT England à Found Studios 1 Lindsey Street London EC1A 9HP

    1 pagesAD02

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Big Studios 1 East Poultry Avenue London EC1A 9PT à Found Studios 1 Lindsey Street London EC1A 9HP le 13 janv. 2017

    1 pagesAD01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2016 au 31 mars 2016

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 011313580015 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 011313580016 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 011313580014 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Rosa Kathleen Howard en tant que directeur le 23 juin 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Rosa Howard en tant que secrétaire le 23 juin 2016

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 01 mai 2015

    20 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2015 au 30 avr. 2015

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2016

    État du capital au 05 janv. 2016

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Brabners Chaffe Street Llp 55 King Street Manchester M2 4LQ England à Big Studios 1 East Poultry Avenue London EC1A 9PT

    1 pagesAD02

    Inscription de la charge 011313580016, créée le 22 déc. 2015

    54 pagesMR01

    Changement d'adresse du siège social de Riverside Agecroft Road, Swinton Manchester Lancashire M27 8SJ à Big Studios 1 East Poultry Avenue London EC1A 9PT le 11 juin 2015

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Malcolm Sykes en tant que directeur le 01 mai 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de J.M. COMPUTING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRAY, Sebastian Christopher
    1 Lindsey Street
    EC1A 9HP London
    Found Studios
    England
    Administrateur
    1 Lindsey Street
    EC1A 9HP London
    Found Studios
    England
    United KingdomBritishCompany Director80251590006
    GILL, David
    Bradgreen Road
    M30 8BZ Monton
    8
    Manchester
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bradgreen Road
    M30 8BZ Monton
    8
    Manchester
    United Kingdom
    BritishFinancial Controler91363310001
    HOWARD, Rosa
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    England
    Secrétaire
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    England
    198447090001
    TOBIN, Paul Denis
    30 Longcroft
    Tyldesley
    M29 7EN Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    30 Longcroft
    Tyldesley
    M29 7EN Manchester
    Lancashire
    British32246840001
    BENTLEY, Michael James
    Riverside
    Agecroft Road, Swinton
    M27 8SJ Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    Riverside
    Agecroft Road, Swinton
    M27 8SJ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director91340350004
    BUCHAN, George Allan
    White Lodge
    3 Whitehall Road
    M33 3WJ Sale
    Cheshire
    Administrateur
    White Lodge
    3 Whitehall Road
    M33 3WJ Sale
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector5639810002
    BURGESS, Andrew Colin
    Gleneagles Way
    BL0 9QN Ramsbottom
    2
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Gleneagles Way
    BL0 9QN Ramsbottom
    2
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector198565320001
    COLEMAN, David John
    24 Quayside Mews
    WA13 0HZ Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    24 Quayside Mews
    WA13 0HZ Lymm
    Cheshire
    BritishDirector51293000002
    DALTON, John Ralph
    78 Meadway
    Bramhall
    SK7 1NL Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    78 Meadway
    Bramhall
    SK7 1NL Stockport
    Cheshire
    BritishDirector51292940001
    GILL, David
    Bradgreen Road
    M30 8BZ Monton
    8
    Manchester
    United Kingdom
    Administrateur
    Bradgreen Road
    M30 8BZ Monton
    8
    Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Controler91363310001
    HOWARD, Rosa Kathleen
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    England
    Administrateur
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    England
    EnglandBritishCompany Director126564410001
    ISHERWOOD, Nicholas Jonathan
    37 Kiers Court
    Arcon Village Horwich
    BL6 6TN Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    37 Kiers Court
    Arcon Village Horwich
    BL6 6TN Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director91340110006
    JONES, Robert Powis
    223 Mosley Common Road
    Worsley
    M28 1SF Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    223 Mosley Common Road
    Worsley
    M28 1SF Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director114639940001
    MAXWELL, Timothy Charles
    232 Broad Lane
    Burnedge Lane
    OL16 4PR Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    232 Broad Lane
    Burnedge Lane
    OL16 4PR Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director91340020001
    STEELE, Lauren
    1 Hamilton Mews
    St Anns Road Prestwich
    M25 9LE Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    1 Hamilton Mews
    St Anns Road Prestwich
    M25 9LE Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director124040990001
    SYKES, Malcolm
    31 Parsons Drive
    Middleton
    M24 5DJ Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    31 Parsons Drive
    Middleton
    M24 5DJ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishTechnical Director32256900001
    TOBIN, Paul Denis
    30 Longcroft
    Tyldesley
    M29 7EN Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    30 Longcroft
    Tyldesley
    M29 7EN Manchester
    Lancashire
    BritishManaging Director32246840001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur J.M. COMPUTING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Sebastian Christopher Gray
    1 Lindsey Street
    EC1A 9HP London
    Found Studios
    England
    06 avr. 2016
    1 Lindsey Street
    EC1A 9HP London
    Found Studios
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    J.M. COMPUTING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 déc. 2015
    Livré le 29 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Lease of premises at riverside house riverside agecroft road pendlebury swinton manchester,lease of land and buildings to the north and west of riverside house please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Five Arrows Managers S.A.
    Transactions
    • 29 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 mai 2015
    Livré le 07 mai 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Lease of premises at riverside house riverside agecroft road pendlebury swinton manchester. Lease of land and buildings to the north and west of riverside house (the second lease).
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Five Arrows Managers S.A.
    Transactions
    • 07 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 mai 2015
    Livré le 07 mai 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Andrew Colin Burgess
    Transactions
    • 07 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 21 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 21 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 05 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 juil. 2003
    Livré le 23 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 23 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 juil. 2003
    Livré le 23 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from jmc.it group limited to the loan note holders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Paul Denis Tobin as Security Agent and Trustee for the Loan Note Holders (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 juin 1994
    Livré le 21 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Prompt credit application
    Créé le 13 mai 1993
    Livré le 26 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £16,271.20 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 26 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A credit agreement
    Créé le 21 sept. 1992
    Livré le 01 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £23427.91 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance for full details see form 395.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers LTD
    Transactions
    • 01 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A credit agreement
    Créé le 20 sept. 1991
    Livré le 08 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £17,236.80 due or to become due from the company to the chargeee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to all sums payable (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 08 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A credit agreement
    Créé le 14 sept. 1990
    Livré le 28 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £28,223-39 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement.
    Brèves mentions
    All its right, title and interest in and to all sums payable under the insurance (please see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 28 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 01 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 févr. 1988
    Livré le 26 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement dated 29/1/88
    Brèves mentions
    All the book and other debts due to the company. From time to time howsoever by way of a first fixed charge.
    Personnes ayant droit
    • Kellock Limited
    Transactions
    • 26 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 29 janv. 1988
    Livré le 09 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stocks shares & securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 07 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 29 janv. 1988
    Livré le 03 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from judge 0TABLE LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    The basement & ground floors & part of the first floor of heritage house 393-395 bury new road, salford manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 03 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 07 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 21 déc. 1981
    Livré le 31 déc. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0