SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01132760 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 25 Gresham Street London EC2V 7HN |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2027 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 07 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 21 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 07 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 déc. 2025 | 43 pages | AA | ||
Nomination de Mr Krishna Venkata Raman en tant que secrétaire le 01 mars 2026 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Caroline Anne Riddy en tant que secrétaire le 28 févr. 2026 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mrs Dena Jane Brumpton en tant qu'administrateur le 02 févr. 2026 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 07 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Jonathan Scott Wheway en tant que directeur le 31 oct. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Mary Helen Trussell en tant qu'administrateur le 07 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Joanna Kate Harris en tant que directeur le 04 juin 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 44 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Deborah Lee Davis en tant que directeur le 18 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 mars 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
État du capital après une attribution d'actions au 12 déc. 2024
| 3 pages | SH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher John George Moulder le 02 déc. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Deborah Lee Davis le 02 déc. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew Hilmar Cuhls le 02 déc. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Gayle Elaine Schumacher le 02 déc. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Cessation de la nomination de Jesujuwonlo Williams en tant que secrétaire le 12 sept. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mrs Caroline Anne Riddy en tant que secrétaire le 13 sept. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mr Paul Gerard Mcnamara en tant qu'administrateur le 02 sept. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Anthony Jonathan Reizenstein en tant que directeur le 30 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 42 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Jesujuwonlo Williams en tant que secrétaire le 29 mars 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Joanne Margaret Jolly en tant que secrétaire le 28 mars 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mrs Kirstine Ann Cooper en tant qu'administrateur le 01 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMAN, Krishna Venkata | Secrétaire | Second Floor 25 Gresham Street EC2V 7HN London Lloyds Banking Group United Kingdom | 345931750001 | |||||||
| BARUA, Chirantan | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 309933170001 | |||||
| BRUMPTON, Dena Jane | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 238482170001 | |||||
| CHALMERS, William Leon David | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 261222830001 | |||||
| COOPER, Kirstine Ann | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 320134320001 | |||||
| CUHLS, Matthew Hilmar | Administrateur | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | United Kingdom | British | 317975950001 | |||||
| MCNAMARA, Paul Gerard | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 156860390001 | |||||
| MOULDER, Christopher John George | Administrateur | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | United Kingdom | British | 233902290008 | |||||
| NYAHASHA, Shingirai Thaddeus | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 318476210001 | |||||
| SCHUMACHER, Gayle Elaine | Administrateur | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | United Kingdom | British | 70147240004 | |||||
| TRUSSELL, Mary Helen | Administrateur | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | United Kingdom | British | 338054460001 | |||||
| CLARKE, David | Secrétaire | Morrison Street EH3 8YF Edinburgh 69 United Kingdom | 194631030001 | |||||||
| FLETCHER, Alexandra Francis | Secrétaire | 106 Main Street EH25 9LT Roslin Midlothian | British | 71584000001 | ||||||
| FORSTER, Paul Martin | Secrétaire | 153 Hare Lane Claygate KT10 0RA Esher Surrey | British | 60264700001 | ||||||
| HANKIN, Christina Ann | Secrétaire | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat, Lloyds Banking Gro United Kingdom | 250712750001 | |||||||
| HOOTON, Tamsin | Secrétaire | Morrison Street EH3 8YF Edinburgh 69 United Kingdom | 190113580001 | |||||||
| JOLLY, Joanne Margaret | Secrétaire | Lloyds Banking Group Plc 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Company Secretariat Scotland Scotland | 266154260001 | |||||||
| MACLEAN, Jennifer Marion | Secrétaire | EH1 1YZ Edinburgh The Mound Scotland Scotland | 152392180001 | |||||||
| MCCARTHY, Martyn Gerald | Secrétaire | 7 Hayfields Lordswood ME5 8HF Chatham Kent | British | 34523810002 | ||||||
| MITCHELL, Fiona | Secrétaire | 11 Charles Drive FK5 3HB Larbert Stirlingshire | British | 68683100001 | ||||||
| NICHOLLS, Tracey Caroline | Secrétaire | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat, Lloyds Banking Gro United Kingdom | 191130690001 | |||||||
| NICHOLLS, Tracey Caroline | Secrétaire | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat Lloyds Banking Gro United Kingdom | 158587670001 | |||||||
| NICHOLLS, Tracey Caroline | Secrétaire | 7 Brunstane Road EH15 2EZ Edinburgh | British | 95560620001 | ||||||
| O'CONNOR, Sharon Noelle | Secrétaire | 176 Blagdon Road KT3 4AL New Malden Surrey | Irish | 45487120003 | ||||||
| PECK, Roger Brian | Secrétaire | 55 Avondale Road GU13 9BS Fleet Hampshire | British | 55429610001 | ||||||
| RIDDY, Caroline Anne | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | 327329690001 | |||||||
| SHAH, Farhat | Secrétaire | Flat 2/2, 8 Grantley Gardens Shawlands G41 3QA Glasgow | British | 101169780001 | ||||||
| SIMMONS, Ann Barrie | Secrétaire | 86/4 Orchard Brae Avenue EH4 2GB Edinburgh | British | 82555460001 | ||||||
| SPRAGG, Roy John | Secrétaire | Broadway Cottage Pluckley Road TN27 0AQ Charing Ashford Kent | British | 80174680001 | ||||||
| WILLIAMS, Jesujuwonlo | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | 321177160001 | |||||||
| ANDERSON, Charles Andrew | Administrateur | The Oast Cottage Pastens Road RH8 0RE Limpsfield Surrey | British | 65035350001 | ||||||
| BEVAN, Roger Lionel | Administrateur | Faygate Ashford Road Lenham ME17 2DA Maidstone Kent | United Kingdom | British | 7720150001 | |||||
| BLACK, James Masson | Administrateur | Level 7, Block E, Port Hamilton 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Division Secretariat, Lloyds Banking Gro United Kingdom | United Kingdom | British | 172334880001 | |||||
| BLANCE, Andrea Margaret | Administrateur | Lloyds Banking Group Plc 69 Morrison Street EH3 8YF Edinburgh Insurance Company Secretariat Scotland Scotland | United Kingdom | British | 334529130001 | |||||
| BOND, Jonathon Roderick Alan | Administrateur | Lloyds Banking Group Plc 69 Morrison Street EH3 8BW Edinburgh Insurance Company Secretariat Scotland Scotland | United Kingdom | British | 183950240001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SCOTTISH WIDOWS ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Widows Limited | 06 avr. 2016 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0