MINSTERGATE HULL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMINSTERGATE HULL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01133076
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MINSTERGATE HULL LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente de voitures d'occasion et de véhicules légers (45112) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Entretien et réparation de véhicules automobiles (45200) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Commerce de gros de pièces et accessoires pour véhicules automobiles (45310) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe MINSTERGATE HULL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit B
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MINSTERGATE HULL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MINSTERGATE LTD21 févr. 201421 févr. 2014
    MINSTERGATE PEUGEOT (SCARBOROUGH) LTD14 janv. 201414 janv. 2014
    H. ARUNDALE LIMITED07 sept. 197307 sept. 1973

    Quels sont les derniers comptes de MINSTERGATE HULL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2024

    Quels sont les derniers dépôts pour MINSTERGATE HULL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 011330760023 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 011330760024 en totalité

    1 pagesMR04

    État du capital au 26 avr. 2024

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Mark Paul Campey en tant que directeur le 19 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Helen Jane Campey en tant que directeur le 19 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024

    7 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 août 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Stephen Paul Forster en tant que directeur le 12 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Minstergate Livingstone Road Hessle East Yorkshire HU13 0AB à Unit B Rotterdam Road Hull HU7 0XD le 13 mars 2023

    1 pagesAD01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2022 au 31 mars 2023

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 22 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 011330760025 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 25 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2021

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 25 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MINSTERGATE HULL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CUFF, James Howard
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    Administrateur
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    EnglandBritishDirector198007350001
    BETHELL, Stephen Paul
    96 New Lane
    Huntington
    YO3 9NH York
    N Yorks
    Secrétaire
    96 New Lane
    Huntington
    YO3 9NH York
    N Yorks
    British26362540001
    BOYLE, Michael Roy
    18 Bracknell Close
    SR3 2DE Sunderland
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    18 Bracknell Close
    SR3 2DE Sunderland
    Tyne & Wear
    British18782760001
    MEE, Patrick Joseph
    203 St Patricks Road South
    FY8 1LG Lytham St Annes
    Lancashire
    Secrétaire
    203 St Patricks Road South
    FY8 1LG Lytham St Annes
    Lancashire
    IrishDirector94077880002
    MOORE, Keith
    1 New Forge Court
    Towthorpe Road, Haxby
    YO32 3YA York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    1 New Forge Court
    Towthorpe Road, Haxby
    YO32 3YA York
    North Yorkshire
    BritishSecretary49217290002
    TAYLOR, David Francis
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    BritishFinance Director81852670001
    ARUNDALE, James Neal
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Administrateur
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishChairman13444300001
    BANKS, Alan Graham
    The Jays
    Parklands
    DL7 9JN Newby Wiske
    Northalllerton North Yorkshire
    Administrateur
    The Jays
    Parklands
    DL7 9JN Newby Wiske
    Northalllerton North Yorkshire
    BritishManaging Director19296240002
    BLAIR, Richard
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Administrateur
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishGeneral Manager125847720001
    BRIDGETT, Jean Marjorie
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Administrateur
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishHousewife34836440002
    CAMPEY, Helen Jane
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    Administrateur
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    EnglandBritishCompany Director78016820003
    CAMPEY, Mark Paul
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    Administrateur
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    EnglandBritishCompany Director78016360002
    FORSTER, Stephen Paul
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    Administrateur
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    EnglandBritishCompany Director163526870001
    GIBBIN, Michael David
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Administrateur
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishFinance Director103592060001
    MEE, Patrick Joseph
    203 St Patricks Road South
    FY8 1LG Lytham St Annes
    Lancashire
    Administrateur
    203 St Patricks Road South
    FY8 1LG Lytham St Annes
    Lancashire
    United KingdomIrishManaging Director94077880002
    TAYLOR, David Francis
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Administrateur
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishFinance Director81852670002
    WATSON, Christopher
    2 Charnwood Drive
    High Grange
    DR3 0EG Darlington
    Administrateur
    2 Charnwood Drive
    High Grange
    DR3 0EG Darlington
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishOps Director124667140001
    WORRALL, Timothy John
    Linden Cottage
    The Hurst Kingsley
    WA6 8BB Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    Linden Cottage
    The Hurst Kingsley
    WA6 8BB Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishDirector49048830001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MINSTERGATE HULL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Mark Paul Campey
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    06 avr. 2016
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MINSTERGATE HULL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 mai 2014
    Livré le 02 mai 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Seamer road, scarborough, YO12 4HW - title nyk 168017. plus all buildings, fixtures & fittings in the nature of landlords fixtures & fittings together with all rights, easements & privileges relating to or benefiting the same.. Insurances: all monies from time to time payable to the mortgagor under or pursuant to any insurances including any refund of premiums.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Psa Wholesale LTD
    Transactions
    • 02 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mars 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 déc. 2013
    Livré le 18 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 avr. 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 déc. 2013
    Livré le 11 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All that f/h property located at seamer road scarborough north yorkshire t/no NYK168017. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 avr. 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 janv. 2004
    Livré le 24 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or banque psa finance (the secured parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Psa Wholesale Limited
    Transactions
    • 24 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 juin 2002
    Livré le 05 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Créé le 21 juin 2002
    Livré le 26 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the leasehold property known as land lying to the south of dalby way coulby newham middlesborough title number CE118514. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Créé le 21 juin 2002
    Livré le 26 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the leasehold property known as unit 3C york business park nether poppleton york title numbers NYK215329 and NYK219622. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Créé le 21 juin 2002
    Livré le 26 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that freehold property known as 72-76 bessingby road bridlington title number HS67221. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 févr. 2002
    Livré le 13 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a ambulance station seamer road scarborough t/n NYK168017`. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 févr. 2002
    Livré le 05 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 02 avr. 2001
    Livré le 05 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £62,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Second mortgage by care micri systems limited to the company on columbus ravine scarborough.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2002Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 29 janv. 1999
    Livré le 10 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at great north way york business park nether poppleton york north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and assignment
    Créé le 09 déc. 1998
    Livré le 15 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the agreement as set out in schedule and all premises therein; all moneys due under the agreement dated 17/8/98 relating to unit 3C,york business park,nether poppleton,north yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 22 juil. 1998
    Livré le 24 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights,title and interest in and to the insurances from time to time; floating charge over all stocks of used vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Psa Wholesale Limited
    Transactions
    • 24 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 1995
    Livré le 14 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings to the south of dalby way coulby newham middlesbrough cleveland t/n CE118514.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 01 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    An irregular-shaped piece of land situate at the rear of victoria road and brook street scarborough north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 01 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the west side of columbus ravine and coach depot in columbus ravine scarborough north yorkshire t/no nyk 69397.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 01 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Piece or parcel of land situate in or near to stakesby road whitby north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 01 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Pieces of land in northway and brook street scarborough north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 01 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Piece of land in victoria road and brook street scarborough and 3 dwellinghouses and shops number 61 63 and 65 victoria road scarborough north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 mars 1989
    Livré le 16 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    57 & 59 victoria road scarborough north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 juil. 1984
    Livré le 03 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 sept. 1982
    Livré le 01 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold, the garage site and premises situate and known as 72 to 76 bessingby road bridlington humberside. Title no. HS67221.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 déc. 1974
    Livré le 16 déc. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & bldgs in northway scarborough w yorkshire conveyance 23.8.74.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1974Enregistrement d'une charge
    • 26 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0