BANC GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BANC GROUP LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01134700 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BANC GROUP LIMITED ?
Adresse du siège social | c/o MSQ PARTNERS LIMITED 90 Tottenham Court Road W1T 4TJ London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BANC GROUP LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BANC GROUP LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour BANC GROUP LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 22 janv. 2016
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 10 Rathbone Place London W1T 1HP | AD03 | |||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 10 Rathbone Place London W1T 1HP | AD02 | |||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ashish Shah le 01 janv. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2014 | 9 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 011347000007 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Msq Partners Ltd 6 York Street London W1U 6PL à C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ le 13 août 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Inscription de la charge 011347000009, créée le 16 juil. 2014 | 59 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge 011347000008, créée le 16 juil. 2014 | 55 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 011347000007 | 17 pages | MR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Daniel Yardley en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dean Wright en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* le 07 févr. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BANC GROUP LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAH, Ashish | Secrétaire | c/o Msq Partners Limited Tottenham Court Road W1T 4TJ London 90 England | 164763690002 | |||||||
REID, Peter David | Administrateur | c/o Msq Partners Limited Tottenham Court Road W1T 4TJ London 90 England | England | British | Group Ceo | 147274580002 | ||||
YARDLEY, Daniel John | Administrateur | c/o Msq Partners Limited Tottenham Court Road W1T 4TJ London 90 England | England | British | Chief Financial Officer | 180507300001 | ||||
BRIGDEN, Colin John | Secrétaire | c/o Media Square Plc York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | 147336200001 | |||||||
BUCKLE, Michael | Secrétaire | Rowan Glen Tibshelf Road Holmewood S42 5TB Chesterfield Derbyshire | British | 4603180001 | ||||||
BURNS, Graeme Ian, Mr. | Secrétaire | 29 Moody Street CW12 4AN Congleton Cheshire | British | Company Director | 75720570001 | |||||
BURNS, Graeme Ian, Mr. | Secrétaire | 29 Moody Street CW12 4AN Congleton Cheshire | British | Commercial Director | 75720570001 | |||||
CLARKE, Martin John | Secrétaire | 105 Congleton Road SK11 7XD Macclesfield Cheshire | British | Accountant | 53461320002 | |||||
CUPITT, Mark Anthony | Secrétaire | 15 Parkland Avenue DY11 6BX Kidderminster Worcestershire | British | Director | 73763810002 | |||||
WINFIELD, Bruce Malcolm | Secrétaire | 22 Hillhouse Close RH10 4YY Turners Hill West Sussex | British | 147948820001 | ||||||
ALDRICH, Nicholas | Administrateur | 12 Little Brind Road S41 8XW Chesterfield Derbyshire | British | Director | 53553280002 | |||||
BUCKLE, Michael | Administrateur | Rowan Glen Tibshelf Road Holmewood S42 5TB Chesterfield Derbyshire | United Kingdom | British | Accountant | 4603180001 | ||||
BURNS, Graeme Ian, Mr. | Administrateur | 29 Moody Street CW12 4AN Congleton Cheshire | United Kingdom | British | Commercial Director | 75720570001 | ||||
HARTLEY, William Mellodew | Administrateur | Merton 9 Moss Road SK9 7JA Alderley Edge Cheshire | British | Solicitor | 17458290001 | |||||
MCNAMARA, Paul Daniel | Administrateur | Corngal 14 Lismore Park SK17 9AU Buxton Derbyshire | British | Creative Dir | 60633810001 | |||||
MIDDLETON, Arthur Jeremy Barritt | Administrateur | Corbar Hall Corbar Road SK17 6TF Buxton | England | British | Company Director | 72455560001 | ||||
MIDDLETON, Olive Margery | Administrateur | 18 Sycamore Close Cavendish Fields SK17 6FB Buxton Derbyshire | British | Company Director | 4603190002 | |||||
MIDDLETON, Timothy James | Administrateur | 12 Kents Bank Road SK17 9HJ Buxton Derbyshire | United Kingdom | British | Company Director | 3484470002 | ||||
SAVAGE, John William | Administrateur | 143 Handley Road New Whittington S43 2EP Chesterfield Derbyshire | England | British | Client Services Dir | 93156560001 | ||||
WATSON, Ian Ashley | Administrateur | 23 Castlecroft Gardens Finchfield WV3 8LN Wolverhampton | England | British | Director | 52601010001 | ||||
WINFIELD, Bruce Malcolm | Administrateur | 22 Hillhouse Close RH10 4YY Turners Hill West Sussex | United Kingdom | British | Accountant | 147948820001 | ||||
WRIGHT, Dean Anthony | Administrateur | c/o Msq Partners Ltd York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | England | British | Director | 159138180001 |
BANC GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 16 juil. 2014 Livré le 21 juil. 2014 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 16 juil. 2014 Livré le 18 juil. 2014 | En cours | ||
Brève description Description of all registered intellectual property rights subject to this security can be found in schedule 5 of the debenture. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 27 sept. 2013 Livré le 04 oct. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental debenture | Créé le 06 févr. 2012 Livré le 23 févr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 déc. 2011 Livré le 20 déc. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 nov. 2005 Livré le 17 nov. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of deposit | Créé le 11 mars 2004 Livré le 01 avr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The deposit initially of £150,000 credited to account designation 10206310 with the bank and any addition to that deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or acount. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent security deposit deed | Créé le 26 août 2003 Livré le 29 août 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions A deposit of £8,174.77. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 03 avr. 1992 Livré le 16 avr. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0