TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01134936 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ?
Adresse du siège social | 1 Albany Place Hyde Way AL7 3BT Welwyn Garden City Hertfordshire United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 25 mars 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tarsem Singh Dhaliwal en tant que directeur le 12 mars 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 25 mars 2011 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Donald Horne le 21 sept. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Tarsem Singh Dhaliwal le 21 sept. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Graham Berry en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jayne Burrell en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 26 mars 2010 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Nomination de Mr Tarsem Singh Dhaliwal en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Denmark House Parkway Welwyn Garden City Herts AL8 6JN le 30 juin 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Ramsden en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 mars 2009 | 2 pages | AA | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
legacy | 1 pages | 403a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERRY, John Graham | Secrétaire | Albany Place Hyde Way AL7 3BT Welwyn Garden City 1 Hertfordshire United Kingdom | 159126610001 | |||||||
HORNE, Christopher Donald | Administrateur | Albany Place Hyde Way AL7 3BT Welwyn Garden City 1 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 42920330001 | ||||
AGGARWAL, Amit | Secrétaire | 27 St Mary's Mansions St Mary's Terrace W2 1SQ London | British | Director | 113667030001 | |||||
BURRELL, Jayne Katherine | Secrétaire | 1 Moat Farm Court Pulford Lane Dodleston CH4 9NN Chester Cheshire | British | Solicitor | 99547650001 | |||||
EGAN, John Raymond | Secrétaire | 36 The Moorings IRISH Malahide Co Dublin Ireland | Irish | 17830940001 | ||||||
ELSBY SMITH, Andrew Edward | Secrétaire | House Road 2 Bordeaux Walk Seabridge ST5 3TZ Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | Director | 114320980001 | |||||
HARRIS, Michael Joseph | Secrétaire | 9 Moor Coppice Crosby L23 2XJ Liverpool Merseyside | British | Company Secretary | 49423350001 | |||||
HOWARTH, David | Secrétaire | Cherry Bank Church Lane, Guilden Sutton CH3 7EW Chester Cheshire | British | 107155000001 | ||||||
LAMBERT, Roy Jefferson | Secrétaire | 5 West Common Lindfield RH16 2AJ Haywards Heath West Sussex | British | 82996330001 | ||||||
REDMOND, Paul Michael | Secrétaire | 14 Trevor Road PR8 3PJ Southport Merseyside | English | 66475060001 | ||||||
DANZ, Freidhelm | Administrateur | Swynnerton Brighton Road IRISH Foxrock Dublin 18 Ireland | German | Director | 19886990002 | |||||
DHALIWAL, Tarsem Singh | Administrateur | Albany Place Hyde Way AL7 3BT Welwyn Garden City 1 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 151680990001 | ||||
EGAN, John Raymond | Administrateur | 36 The Moorings IRISH Malahide Co Dublin Ireland | Irish | Director | 17830940001 | |||||
ELSBY SMITH, Andrew Edward | Administrateur | House Road 2 Bordeaux Walk Seabridge ST5 3TZ Newcastle Under Lyme Staffordshire | England | British | Director | 114320980001 | ||||
HEAL, Stephen Alan | Administrateur | The Paddocks Drove Road Gamlingay SG19 3NY Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 42087770001 | ||||
HYSLOP, Edward James | Administrateur | Mayfield House Hall Lane, Haughton CW6 9RH Tarporley Cheshire | England | British | Director | 127371260001 | ||||
JAKOBSEN, Carsten Svejgaard | Administrateur | Langley Grounds 390 Birmingham Road CV37 0R Stratford Upon Avon Warwickshire | England | Danish | Director | 165874230001 | ||||
KIDD, Derek | Administrateur | Yew Cottage OX15 6NG Shenington Oxfordshire | British | Director | 57300690001 | |||||
RAMSDEN, Andrew Nicholas | Administrateur | The Farmhouse Wood Lea Farm Shepley HD8 8ES Huddersfield | England | British | Director | 122765080001 | ||||
REDMOND, Jacqueline Rita | Administrateur | 9 West Lane Freshfields L37 7AY Liverpool Merseyside | British | Company Director | 49423290001 | |||||
REDMOND, Michael Joseph | Administrateur | 9 West Lane Freshfields L37 7AY Liverpool Merseyside | British | Director | 41016180001 | |||||
WOODWARD, Jeremy Alan | Administrateur | Troon House Northop Country Park Northop CH7 6WD Mold Clwyd | United Kingdom | British | Director | 57016650004 |
TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
All assets debenture | Créé le 05 sept. 2006 Livré le 23 sept. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 05 sept. 2006 Livré le 23 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The property k/a land and buildings on the south west side of school lane, knowsley industrial park, knowsley, liverpool, merseyside t/no MS122055 a charge over all buildings, fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 03 déc. 1993 Livré le 07 déc. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Property at caddick road school lane knowsley industrial park liverpool. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 23 nov. 1993 Livré le 24 nov. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 31 mai 1985 Livré le 10 juin 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H land & buildings on the south west side of school lane knowsley industrial estate, knowsley. Merseyside (title no ms 122055). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 31 juil. 1984 Livré le 09 août 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H land & buildings on the south west side of school lane knowsley merseyside. Title no ms 122055. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 03 juil. 1984 Livré le 06 juil. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book & other debts due owing or incurred to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0