TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED

TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01134936
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ?

    • (6024) /
    • (6312) /

    Où se situe TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOM GRANBY (COLDSTORES) LIMITED 19 sept. 197319 sept. 1973

    Quels sont les derniers comptes de TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au25 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Tarsem Singh Dhaliwal en tant que directeur le 12 mars 2012

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 25 mars 2011

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 sept. 2011

    État du capital au 21 sept. 2011

    • Capital: GBP 260,802
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Donald Horne le 21 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Tarsem Singh Dhaliwal le 21 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr John Graham Berry en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jayne Burrell en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 26 mars 2010

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Nomination de Mr Tarsem Singh Dhaliwal en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Denmark House Parkway Welwyn Garden City Herts AL8 6JN le 30 juin 2010

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Andrew Ramsden en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 mars 2009

    2 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages190

    Qui sont les dirigeants de TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BERRY, John Graham
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    159126610001
    HORNE, Christopher Donald
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector42920330001
    AGGARWAL, Amit
    27 St Mary's Mansions
    St Mary's Terrace
    W2 1SQ London
    Secrétaire
    27 St Mary's Mansions
    St Mary's Terrace
    W2 1SQ London
    BritishDirector113667030001
    BURRELL, Jayne Katherine
    1 Moat Farm Court
    Pulford Lane Dodleston
    CH4 9NN Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    1 Moat Farm Court
    Pulford Lane Dodleston
    CH4 9NN Chester
    Cheshire
    BritishSolicitor99547650001
    EGAN, John Raymond
    36 The Moorings
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Secrétaire
    36 The Moorings
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Irish17830940001
    ELSBY SMITH, Andrew Edward
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Secrétaire
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishDirector114320980001
    HARRIS, Michael Joseph
    9 Moor Coppice
    Crosby
    L23 2XJ Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    9 Moor Coppice
    Crosby
    L23 2XJ Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Secretary49423350001
    HOWARTH, David
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    British107155000001
    LAMBERT, Roy Jefferson
    5 West Common
    Lindfield
    RH16 2AJ Haywards Heath
    West Sussex
    Secrétaire
    5 West Common
    Lindfield
    RH16 2AJ Haywards Heath
    West Sussex
    British82996330001
    REDMOND, Paul Michael
    14 Trevor Road
    PR8 3PJ Southport
    Merseyside
    Secrétaire
    14 Trevor Road
    PR8 3PJ Southport
    Merseyside
    English66475060001
    DANZ, Freidhelm
    Swynnerton
    Brighton Road
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    Swynnerton
    Brighton Road
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    GermanDirector19886990002
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector151680990001
    EGAN, John Raymond
    36 The Moorings
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Administrateur
    36 The Moorings
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    IrishDirector17830940001
    ELSBY SMITH, Andrew Edward
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector114320980001
    HEAL, Stephen Alan
    The Paddocks Drove Road
    Gamlingay
    SG19 3NY Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Paddocks Drove Road
    Gamlingay
    SG19 3NY Sandy
    Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector42087770001
    HYSLOP, Edward James
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritishDirector127371260001
    JAKOBSEN, Carsten Svejgaard
    Langley Grounds
    390 Birmingham Road
    CV37 0R Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Langley Grounds
    390 Birmingham Road
    CV37 0R Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandDanishDirector165874230001
    KIDD, Derek
    Yew Cottage
    OX15 6NG Shenington
    Oxfordshire
    Administrateur
    Yew Cottage
    OX15 6NG Shenington
    Oxfordshire
    BritishDirector57300690001
    RAMSDEN, Andrew Nicholas
    The Farmhouse
    Wood Lea Farm Shepley
    HD8 8ES Huddersfield
    Administrateur
    The Farmhouse
    Wood Lea Farm Shepley
    HD8 8ES Huddersfield
    EnglandBritishDirector122765080001
    REDMOND, Jacqueline Rita
    9 West Lane
    Freshfields
    L37 7AY Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    9 West Lane
    Freshfields
    L37 7AY Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director49423290001
    REDMOND, Michael Joseph
    9 West Lane
    Freshfields
    L37 7AY Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    9 West Lane
    Freshfields
    L37 7AY Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector41016180001
    WOODWARD, Jeremy Alan
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    Administrateur
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    United KingdomBritishDirector57016650004

    TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    All assets debenture
    Créé le 05 sept. 2006
    Livré le 23 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transactions
    • 23 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 05 sept. 2006
    Livré le 23 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a land and buildings on the south west side of school lane, knowsley industrial park, knowsley, liverpool, merseyside t/no MS122055 a charge over all buildings, fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landsbanki Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transactions
    • 23 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 1993
    Livré le 07 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at caddick road school lane knowsley industrial park liverpool. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 23 nov. 1993
    Livré le 24 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 31 mai 1985
    Livré le 10 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land & buildings on the south west side of school lane knowsley industrial estate, knowsley. Merseyside (title no ms 122055).
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 10 juin 1985Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 1984
    Livré le 09 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land & buildings on the south west side of school lane knowsley merseyside. Title no ms 122055.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 03 juil. 1984
    Livré le 06 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book & other debts due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1984Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0