TULLETT LIBERTY (EUROPEAN HOLDINGS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TULLETT LIBERTY (EUROPEAN HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01135101 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TULLETT LIBERTY (EUROPEAN HOLDINGS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Floor 2 155 Bishopsgate EC2M 3TQ London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TULLETT LIBERTY (EUROPEAN HOLDINGS) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour TULLETT LIBERTY (EUROPEAN HOLDINGS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 26 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Nomination de Mr Andrew Ren-Yiing Chen en tant qu'administrateur le 23 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul James Ashley en tant que directeur le 27 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 1 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Tower 42 Level 37 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ à Floor 2 155 Bishopsgate London EC2M 3TQ le 31 déc. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robin James Stewart le 17 juil. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2018 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Tiffany Fern Brill en tant que secrétaire le 21 juil. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Tiffany Fern Brill en tant que secrétaire le 31 oct. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de David Venus & Company Llp en tant que secrétaire le 31 oct. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Richard Mainwaring en tant que directeur le 30 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Nomination de Paul James Ashley en tant qu'administrateur le 06 mai 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 2 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire David Venus & Company Llp le 20 mars 2015 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de TULLETT LIBERTY (EUROPEAN HOLDINGS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEN, Andrew Ren-Yiing | Administrateur | 155 Bishopsgate EC2M 3TQ London Floor 2 England | England | British | 225251990001 | |||||||||||||
| STEWART, Robin James | Administrateur | 155 Bishopsgate EC2M 3TQ London Floor 2 England | England | British | 161299680001 | |||||||||||||
| BRILL, Tiffany Fern | Secrétaire | Level 37 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London Tower 42 | 218149200001 | |||||||||||||||
| BURT, Christopher Aubrey Nolan | Secrétaire | 31 Waterford Road SW6 2DT London | British | 67806960001 | ||||||||||||||
| CHALLEN, Nicola | Secrétaire | Level 37 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London Tower 42 United Kingdom | Other | 119903660002 | ||||||||||||||
| DE FREITAS, Maria Teresa | Secrétaire | Flat 1 47 Lloyd Baker Street WC1X 9AA London | British | 95153090009 | ||||||||||||||
| DEARLOVE, Juliet Mary | Secrétaire | Churchgate House 15 Churchgate Street CM17 0JT Old Harlow Essex | British | 72784040001 | ||||||||||||||
| DYER BARTLETT, Diana | Secrétaire | Level 37 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London Tower 42 United Kingdom | 177068720001 | |||||||||||||||
| DYER BARTLETT, Diana | Secrétaire | Ketton House Rectory Road CB9 7QL Kedington Suffolk | British | 197885470001 | ||||||||||||||
| HOSKINS, Justin Wilbert | Secrétaire | Level 37 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London Tower 42 United Kingdom | 171912440001 | |||||||||||||||
| LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Secrétaire | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | 42841660001 | ||||||||||||||
| LOWE, David Lawrence | Secrétaire | 29 Princes Road TW10 6DQ Richmond Surrey | British | 35548600001 | ||||||||||||||
| PEEL, Alistair Charles | Secrétaire | Deep Acres HP6 5NX Amersham 6 Bucks England | Other | 132896170001 | ||||||||||||||
| DAVID VENUS & COMPANY LLP | Secrétaire | Hersham Road KT12 1RZ Walton-On-Thames 42-50 Surrey United Kingdom |
| 131429630001 | ||||||||||||||
| ALLRIGHT, Anthony John | Administrateur | 3 Highfield Drive Ickenham UB10 8AL Uxbridge Middlesex | British | 10637720001 | ||||||||||||||
| ASHLEY, Paul James | Administrateur | Bishopsgate EC2M 3TQ London 155 United Kingdom | England | British | 332150410001 | |||||||||||||
| BENNETT, Ronald Graham | Administrateur | 125 Howards Lane SW15 6QE London | British | 66495700001 | ||||||||||||||
| BOLTON, Marcus Peregrine | Administrateur | High Barn Sutton Place, Abinger Hammer RH5 6RP Dorking Surrey | England | British | 84102400001 | |||||||||||||
| BOLTON, Marcus Peregrine | Administrateur | High Barn Sutton Place, Abinger Hammer RH5 6RP Dorking Surrey | England | British | 84102400001 | |||||||||||||
| BROWN, Michael James | Administrateur | 76 Bushey Way Park Langley BR3 2TD Beckenham Kent | British | 28134940001 | ||||||||||||||
| COLLINS, Bruce Paul | Administrateur | 35 Homestead Road BR6 6HN Chelsfield Kent | United Kingdom | British | 72822380002 | |||||||||||||
| COOPER, Richard Quentin Mortimer | Administrateur | Suite 3 Cochrane House, Admirals Way E14 9UD London | British | 120535720002 | ||||||||||||||
| CORKER, Stephen Roger | Administrateur | 10 Monmouth Road W2 5SB London | United Kingdom | British | 43964780001 | |||||||||||||
| COUPLAND, Nigel Thomas | Administrateur | 3 Ridgy Field Close TN15 7QZ Wrotham Kent | United Kingdom | British | 166810340001 | |||||||||||||
| DUCKWORTH, Stephen Charles | Administrateur | Level 37 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London Tower 42 United Kingdom | England | British | 69519860001 | |||||||||||||
| DUNKLEY, Paul Simon | Administrateur | Level 37 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London Tower 42 United Kingdom | England | British | 138694990001 | |||||||||||||
| EVERETT, Michael Jeffrey Leonard | Administrateur | Meadow Way Northdown Road Woldingham CR3 7BB Caterham Surrey | British | 10776110001 | ||||||||||||||
| GIBSON, William Robert | Administrateur | 102 Beauly Way Rise Park RM1 4XR Romford Essex | British | 2218540001 | ||||||||||||||
| GOGGIN, Michael John | Administrateur | Heronswood Eyhurst Close KT20 6NR Kingswood Surrey | British | 29051570002 | ||||||||||||||
| GOLDSMITH, Ian | Administrateur | Leydens Farm Lydens Lane Hever TN8 7EP Edenbridge Kent | British | 11037170002 | ||||||||||||||
| GOLDSMITH, Johnathon Michael | Administrateur | 29 Roedean Crescent SW15 Richmond London | British | 49646690002 | ||||||||||||||
| HITCHCOCK, Terence John | Administrateur | Hutton Wood Heronway CM13 2LX Brentwood Essex | United Kingdom | British | 88780740001 | |||||||||||||
| LAWRENCE, John Russell | Administrateur | Cross Keys House Ashgrove Road TN13 1SX Sevenoaks Kent | England | British | 64792000001 | |||||||||||||
| LJUBIC, Ivan | Administrateur | 15 Rue Des Gate Ceps Saint Cloud 92210 France | French | 82066250001 | ||||||||||||||
| LOWE, David Lawrence | Administrateur | 29 Princes Road TW10 6DQ Richmond Surrey | British | 35548600001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TULLETT LIBERTY (EUROPEAN HOLDINGS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullett Prebon Investment Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Level 37 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London Tower 42 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TULLETT LIBERTY (EUROPEAN HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Créé le 26 janv. 2000 Livré le 28 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the financing documents (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 18 oct. 1993 Livré le 03 nov. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents (as defined) | |
Brèves mentions ,. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 04 mars 1991 Livré le 18 mars 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0