TIMBERBASE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TIMBERBASE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01136241 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TIMBERBASE LIMITED ?
Adresse du siège social | Ground Floor, Boundary House 2 Wythall Green Way Wythall B47 6LW Birmingham United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TIMBERBASE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour TIMBERBASE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de PO Box 1586, Gemini One, John Smith Drive Oxford Business Park South Oxford OX4 9JF à Ground Floor, Boundary House 2 Wythall Green Way Wythall Birmingham B47 6LW le 15 mai 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
État du capital au 04 janv. 2018
| 6 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 10 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Garrett Wilkinson le 01 oct. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 9 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Po Box 1224 Pelham House Canwick Road Lincoln LN5 5NH à Po Box 1586, Gemini One, John Smith Drive Oxford Business Park South Oxford OX4 9JF le 13 août 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Colin O’Donovan en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Garrett Wilkinson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 8 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Colm O'nuallain en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Colin O’Donovan en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TIMBERBASE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAFTON GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | c/o Grafton Group Plc Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate IRISH Dublin 18 Ireland | 97259990001 | |||||||
O'HARA, Brian | Administrateur | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | Accountant | 181212990001 | ||||
WILKINSON, Garrett | Administrateur | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | Accountant | 187427640007 | ||||
JONES, Peter Howard | Secrétaire | 152 Church Green Road Bletchley MK3 6DD Milton Keynes Buckinghamshire | British | 25572450001 | ||||||
LATHAM, Philippa Anne Joan | Secrétaire | 4 Chepstow Crescent W11 3EB London | British | Company Sec | 38437780003 | |||||
CHADWICK, Michael | Administrateur | 39 Serpentine Avenue Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Ireland | Irish | Director | 16417710002 | ||||
JONES, Peter Howard | Administrateur | 152 Church Green Road Bletchley MK3 6DD Milton Keynes Buckinghamshire | British | 25572450001 | ||||||
KEMP, Terence George | Administrateur | Lowerbreeds Breeds Road Great Waltham CM3 1EE Chelmsford Essex | British | Chartered Accountant | 11609520001 | |||||
LATHAM, Peter Douglas Langdon | Administrateur | High Acre Hilltop Lane Chinnor OX9 4BH Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 15588560001 | ||||
LATHAM, Philippa Anne Joan | Administrateur | 4 Chepstow Crescent W11 3EB London | Uk | British | Company Secretary | 38437780003 | ||||
LYALL, James | Administrateur | 44 Millway Duston NN5 6ES Northampton Northamptonshire | British | Company Director | 12417440001 | |||||
MARTIN, Leo James | Administrateur | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | Director | 144555840001 | ||||
MCCABE, Michael Francis | Administrateur | 31 East Field Close Headington OX3 7SH Oxford | England | Irish | Director | 87622560002 | ||||
MIDDLETON, Kevin Paul | Administrateur | Canwick Road LN5 5NH Lincoln PO BOX 1224 Pelham House | England | British | Director | 61374610002 | ||||
O'DONOVAN, Colin | Administrateur | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | Chartered Accountant | 164508820001 | ||||
O'NUALLAIN, Colm | Administrateur | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | Director | 79602480001 | ||||
PARKINSON, Malcolm Ross | Administrateur | Claywood House Arnewood Bridge Road Sway SO41 6DA Lymington Hampshire | United Kingdom | British | Director | 36376230001 | ||||
SMITH, Christopher John | Administrateur | 5 Hammond Crescent Willen Park MK15 9DH Milton Keynes Buckinghamshire | British | Timber Manager | 25572430001 | |||||
SOWTON, Jonathon Paul | Administrateur | Wellbottom Cottage The Downs KT22 8JZ Leatherhead Surrey | England | British | Director | 151407670001 | ||||
TYLER, Maurice Henry | Administrateur | The Lawns Heath Road LU7 8AG Leighton Buzzard Bedfordshire | British | Company Director | 25572440001 | |||||
TYLER, Robert George | Administrateur | 70 Kirby Drive Barton Hills | British | Company Director | 25572420001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TIMBERBASE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafton Group (Uk) Plc | 06 avr. 2016 | 250-256 High Street RH4 1QT Dorking Oak Green House Surrey England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
TIMBERBASE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 26 mars 1997 Livré le 01 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brèves mentions Property being land and buildings on east and west sides of simpson road bletchley bucks t/no BM2021. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 mars 1997 Livré le 01 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brèves mentions Property being land and buildings on east and west sides of simpson road bletchley bucks t/no BM2021. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 mars 1997 Livré le 01 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brèves mentions The property being land and buildings on east and west sides of simpson road bletchley bucks t/no bm 2021 land and buildings on the south side of manor street braintree t/no ex 507592. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 31 mai 1994 Livré le 02 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings forming part of the former gas works at manor street braintree. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 19 nov. 1993 Livré le 03 déc. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0