TIMBERBASE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTIMBERBASE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01136241
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TIMBERBASE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TIMBERBASE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ground Floor, Boundary House 2 Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6LW Birmingham
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TIMBERBASE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LATHAM TIMBER CENTRES (HOLDINGS) LIMITED27 janv. 198227 janv. 1982
    JAMES LATHAM (MILTON KEYNES) LIMITED26 sept. 197326 sept. 1973

    Quels sont les derniers comptes de TIMBERBASE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour TIMBERBASE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 1586, Gemini One, John Smith Drive Oxford Business Park South Oxford OX4 9JF à Ground Floor, Boundary House 2 Wythall Green Way Wythall Birmingham B47 6LW le 15 mai 2018

    1 pagesAD01

    État du capital au 04 janv. 2018

    • Capital: GBP 1
    6 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    10 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 sept. 2015

    État du capital au 22 sept. 2015

    • Capital: GBP 5,068,100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Garrett Wilkinson le 01 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 sept. 2014

    État du capital au 22 sept. 2014

    • Capital: GBP 5,068,100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    9 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Po Box 1224 Pelham House Canwick Road Lincoln LN5 5NH à Po Box 1586, Gemini One, John Smith Drive Oxford Business Park South Oxford OX4 9JF le 13 août 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Colin O’Donovan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Garrett Wilkinson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 oct. 2013

    État du capital au 14 oct. 2013

    • Capital: GBP 5,068,100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Colm O'nuallain en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Colin O’Donovan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de TIMBERBASE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRAFTON GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    c/o Grafton Group Plc
    Heron House Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    Secrétaire
    c/o Grafton Group Plc
    Heron House Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    97259990001
    O'HARA, Brian
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrishAccountant181212990001
    WILKINSON, Garrett
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrishAccountant187427640007
    JONES, Peter Howard
    152 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    152 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British25572450001
    LATHAM, Philippa Anne Joan
    4 Chepstow Crescent
    W11 3EB London
    Secrétaire
    4 Chepstow Crescent
    W11 3EB London
    BritishCompany Sec38437780003
    CHADWICK, Michael
    39 Serpentine Avenue
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    39 Serpentine Avenue
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrishDirector16417710002
    JONES, Peter Howard
    152 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    152 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British25572450001
    KEMP, Terence George
    Lowerbreeds Breeds Road
    Great Waltham
    CM3 1EE Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Lowerbreeds Breeds Road
    Great Waltham
    CM3 1EE Chelmsford
    Essex
    BritishChartered Accountant11609520001
    LATHAM, Peter Douglas Langdon
    High Acre Hilltop Lane
    Chinnor
    OX9 4BH Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    High Acre Hilltop Lane
    Chinnor
    OX9 4BH Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director15588560001
    LATHAM, Philippa Anne Joan
    4 Chepstow Crescent
    W11 3EB London
    Administrateur
    4 Chepstow Crescent
    W11 3EB London
    UkBritishCompany Secretary38437780003
    LYALL, James
    44 Millway
    Duston
    NN5 6ES Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    44 Millway
    Duston
    NN5 6ES Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director12417440001
    MARTIN, Leo James
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrishDirector144555840001
    MCCABE, Michael Francis
    31 East Field Close
    Headington
    OX3 7SH Oxford
    Administrateur
    31 East Field Close
    Headington
    OX3 7SH Oxford
    EnglandIrishDirector87622560002
    MIDDLETON, Kevin Paul
    Canwick Road
    LN5 5NH Lincoln
    PO BOX 1224 Pelham House
    Administrateur
    Canwick Road
    LN5 5NH Lincoln
    PO BOX 1224 Pelham House
    EnglandBritishDirector61374610002
    O'DONOVAN, Colin
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant164508820001
    O'NUALLAIN, Colm
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrishDirector79602480001
    PARKINSON, Malcolm Ross
    Claywood House
    Arnewood Bridge Road Sway
    SO41 6DA Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    Claywood House
    Arnewood Bridge Road Sway
    SO41 6DA Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector36376230001
    SMITH, Christopher John
    5 Hammond Crescent
    Willen Park
    MK15 9DH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    5 Hammond Crescent
    Willen Park
    MK15 9DH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishTimber Manager25572430001
    SOWTON, Jonathon Paul
    Wellbottom Cottage
    The Downs
    KT22 8JZ Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Wellbottom Cottage
    The Downs
    KT22 8JZ Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishDirector151407670001
    TYLER, Maurice Henry
    The Lawns Heath Road
    LU7 8AG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Lawns Heath Road
    LU7 8AG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishCompany Director25572440001
    TYLER, Robert George
    70 Kirby Drive
    Barton Hills
    Administrateur
    70 Kirby Drive
    Barton Hills
    BritishCompany Director25572420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TIMBERBASE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Grafton Group (Uk) Plc
    250-256 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House
    Surrey
    England
    06 avr. 2016
    250-256 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House
    Surrey
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement02886378
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TIMBERBASE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 mars 1997
    Livré le 01 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    Property being land and buildings on east and west sides of simpson road bletchley bucks t/no BM2021. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merita Bank LTD
    Transactions
    • 01 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 mars 1997
    Livré le 01 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    Property being land and buildings on east and west sides of simpson road bletchley bucks t/no BM2021. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 01 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 mars 1997
    Livré le 01 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    The property being land and buildings on east and west sides of simpson road bletchley bucks t/no bm 2021 land and buildings on the south side of manor street braintree t/no ex 507592. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mai 1994
    Livré le 02 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings forming part of the former gas works at manor street braintree.
    Personnes ayant droit
    • Hambros Bank Limited
    Transactions
    • 02 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 nov. 1993
    Livré le 03 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hambros Bank Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 03 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0